HANOVER THREE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HANOVER THREE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00397132 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HANOVER THREE LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich HANOVER THREE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Luminar House Deltic Avenue Rooksley MK13 8LW Milton Keynes Bucks |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HANOVER THREE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
INDMAR CATERING LIMITED | 04. Apr. 1995 | 04. Apr. 1995 |
HENRY NUTTALL (ROCHDALE) LIMITED | 20. Juli 1945 | 20. Juli 1945 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HANOVER THREE LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 28. Feb. 2011 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Nov. 2011 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 25. Feb. 2010 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HANOVER THREE LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Aug. 2016 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 27. Aug. 2016 |
Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HANOVER THREE LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für HANOVER THREE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 4 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Bowcock als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Terence Douglas als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy O'gorman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy O'gorman als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Hedley Bowcock als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jayne Fearn als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy O'gorman als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 25. Feb. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Marks als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Luminar Leisure Limited als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Feb. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. März 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. März 2006 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a |
Wer sind die Geschäftsführer von HANOVER THREE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEARN, Jayne | Sekretär | Luminar House Deltic Avenue Rooksley MK13 8LW Milton Keynes Bucks | 158739980001 | |||||||||||
DOUGLAS, Simon Terence | Geschäftsführer | Coopers Green Lane AL4 9HR St. Albans Oak House Hertfordshire England | England | British | Director | 89567300002 | ||||||||
LUMINAR LEISURE LIMITED | Geschäftsführer | Deltic Avenue Rooksley MK13 8LW Milton Keynes Luminar House England |
| 152128020001 | ||||||||||
ARMSTRONG, Colin North | Sekretär | Barton End Priors Barton SO23 9QF Winchester Hampshire | British | Solicitor | 172030620001 | |||||||||
BROWN, Kenneth George | Sekretär | 12 Prestwick Place KY2 6LG Kirkcaldy Fife | British | 1035280001 | ||||||||||
CRAYSTON, David | Sekretär | Silver Coins Whassett LA7 7DN Milnthorpe Cumbria | British | 42771970001 | ||||||||||
DACRE, Ronald Robert Hugh | Sekretär | 21 Keirsbeath Court Kingseat KY12 0UE Dunfermline Fife | British | Accountant | 813060001 | |||||||||
HULME, Peter | Sekretär | 22 Rydal Road Little Lever BL3 1DT Bolton Lancashire | British | 524090001 | ||||||||||
MORRIS, David Charles | Sekretär | 12 Victoria Street LU6 3BA Dunstable Bedfordshire | British | 98815770001 | ||||||||||
O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard | Sekretär | 5 High Oaks Road AL8 7BJ Welwyn Garden City Hertfordshire | British | Solicitor | 55241590004 | |||||||||
PARSONS, Steven Ian | Sekretär | 13 Moreton Road South Round Green LU2 0TL Luton Bedfordshire | British | 87152410003 | ||||||||||
STRIDE, Andrew William | Sekretär | 6 Tilbury Road East Haddon NN6 8BX Northampton | British | 62422770001 | ||||||||||
BOWCOCK, Philip Hedley | Geschäftsführer | Luminar House Deltic Avenue Rooksley MK13 8LW Milton Keynes Bucks | England | British | Director | 158744440001 | ||||||||
BROWN, Gary | Geschäftsführer | Holly Tree House CV23 8AT Flecknoe Warwicks | British | Company Director | 94339190002 | |||||||||
BROWN, Kenneth George | Geschäftsführer | 12 Prestwick Place KY2 6LG Kirkcaldy Fife | British | Director | 1035280001 | |||||||||
BURFORD, Alistair Graham | Geschäftsführer | The Jungle Madingley Road, Coton CB23 7PH Cambridge | England | British | Company Director | 124289050002 | ||||||||
BURNS, Andrew Rae | Geschäftsführer | 11 Glebe Avenue EN2 8NZ Enfield Middlesex | England | British | Director | 54722740002 | ||||||||
CLARK, Gordon Edward | Geschäftsführer | 28 Ravenscliffe Drive Giffnock G46 7QP Glasgow Lanarkshire | British | Director | 524110001 | |||||||||
CLARK, Robin Dale | Geschäftsführer | 33 Old Barber HG1 3DF Harrogate North Yorkshire | British | Director | 44367550003 | |||||||||
DACRE, Ronald Robert Hugh | Geschäftsführer | 21 Keirsbeath Court Kingseat KY12 0UE Dunfermline Fife | British | Accountant | 813060001 | |||||||||
DICKSON, John Graeme | Geschäftsführer | 26 Thornly Park Drive PA2 7RP Paisley Renfrewshire | British | Director | 51692070001 | |||||||||
DOODSON, John | Geschäftsführer | 69 Seven Acres Lane Norden OL12 7RW Rochdale Lancashire | British | Director | 10407310001 | |||||||||
GUTTERIDGE, Timothy Roy | Geschäftsführer | 38 Northumberland Street EH3 6JA Edinburgh Scotland | British | Managing Director | 6050070003 | |||||||||
HEPBURN, Gavin Andrew Harley | Geschäftsführer | 22 Mansionhouse Road EH9 2JD Edinburgh Midlothian | British | Company Director | 211700001 | |||||||||
HULME, Peter | Geschäftsführer | 22 Rydal Road Little Lever BL3 1DT Bolton Lancashire | British | Director | 524090001 | |||||||||
KERSHAW, Anthony | Geschäftsführer | 38 Turfland Avenue OL2 6EN Royton Lancashire | British | Director | 83066910001 | |||||||||
MARKS, Andrew Geoffrey | Geschäftsführer | 170 Long Meadow Bedgrove HP21 7EB Aylesbury Bucks | United Kingdom | British | Director | 98760390001 | ||||||||
MILLS, Adam Francis | Geschäftsführer | The Walton Canonry 69 The Close SP1 2EN Salisbury Wiltshire | British | Chart.Accountant & Co.Director | 4058810004 | |||||||||
MORRIS, David Charles | Geschäftsführer | 12 Victoria Street LU6 3BA Dunstable Bedfordshire | British | Company Secretary | 98815770001 | |||||||||
O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard | Geschäftsführer | 5 High Oaks Road AL8 7BJ Welwyn Garden City Hertfordshire | England | British | Solicitor | 55241590004 | ||||||||
RITCHIE, Alastair James | Geschäftsführer | Mickry Lodge 56 Gamekeepers Road EH4 6LS Edinburgh Lothian | British | Director | 38770080002 | |||||||||
THOMAS, Stephen Charles | Geschäftsführer | Newnham Hall Poets Way, Newnham NN11 3HQ Daventry Northamptonshire | British | Director | 66198390004 | |||||||||
VALENTINE, Thomas | Geschäftsführer | 1 Huntingtower Park KY6 3QF Glenrothes Fife | British | Director | 28020001 | |||||||||
WILLITS, Henry Andrew | Geschäftsführer | Stable Barn Hall Farm Charwelton Road NN11 3TA Preston Capes Northamptonshire | British | Solicitor | 90132600002 |
Hat HANOVER THREE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 08. Feb. 1995 Geliefert am 23. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of offset | Erstellt am 18. Sept. 1990 Geliefert am 04. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of henry nottall (rochdale) limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of offset | Erstellt am 21. Nov. 1989 Geliefert am 11. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from fife indmar PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of henry nuttall (rochdale) limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of offset. | Erstellt am 24. Aug. 1982 Geliefert am 03. Sept. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from T.S. forster & sons limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any accounts or accounts of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of offset | Erstellt am 25. März 1982 Geliefert am 08. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the park naval engineering limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All sums which are now or which may at any time be at the credit of any account or accounts of the company with the bank (see doc M91). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of offset | Erstellt am 26. Feb. 1981 Geliefert am 18. März 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from and/or all of companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All sums which are now or which may at any time be at the credit of any account or accounts of the company with the bank. (See doc m 90). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0