CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED

CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00400725
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 004007250086 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 004007250085 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 004007250087 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    17 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung am 24. Dez. 2021

    • Kapital: GBP 100.00
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 004007250086

    1 SeitenMR05

    Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Simon Slavin am 14. Apr. 2021

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    18 SeitenAA

    **Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 004007250085

    2 SeitenMR05

    Beendigung der Bestellung von Michael Ben Jenkins als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020

    1 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung 004007250087, erstellt am 17. Dez. 2020

    71 SeitenMR01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Philip Simon Slavin als Direktor am 13. Feb. 2020

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HEAZELL, Frances Victoria
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    215875350001
    SAUNDERS, James Michael Edward
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish192568400002
    SLAVIN, Philip Simon
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish267205160002
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Sekretär
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Sekretär
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    KIERNAN, David Patrick
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Irish11366290003
    LINDSELL, Philip Edmund
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    Sekretär
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    British101775640001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Sekretär
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    174832640001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Sekretär
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Sekretär
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    ARNOLD, Robin David Clement
    Adam & Eve Mews
    W8 6UG London
    13a
    Geschäftsführer
    Adam & Eve Mews
    W8 6UG London
    13a
    United KingdomBritish136590160001
    BOAS, John Robert Sotheby
    5 Longwood Drive
    SW15 5DL London
    Geschäftsführer
    5 Longwood Drive
    SW15 5DL London
    British13518020001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish184444990001
    COSSEY, Robert Duncan
    24 Makepeace Avenue
    N6 6EJ London
    Geschäftsführer
    24 Makepeace Avenue
    N6 6EJ London
    British14907240001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Geschäftsführer
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    EnglandBritish90007990001
    DODD, Angus Alexander
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish201606390001
    DUGDALE, Edward Stratford
    190 Avenue Road
    W3 8QQ London
    Geschäftsführer
    190 Avenue Road
    W3 8QQ London
    British35942980001
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Geschäftsführer
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Geschäftsführer
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    ERDMAN, Edward Louis
    11 Park Towers
    W1Y 7DF London
    Geschäftsführer
    11 Park Towers
    W1Y 7DF London
    British10668170001
    GAMBLE, John Stuart
    The Old Lodge Itchingwood Common
    Limpsfield Chart
    Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Old Lodge Itchingwood Common
    Limpsfield Chart
    Oxted
    Surrey
    British14687500001
    GAVAGHAN, David Nicholas
    Grosvenor Street
    W1K 4QF London
    16
    Geschäftsführer
    Grosvenor Street
    W1K 4QF London
    16
    United KingdomBritish151855940001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    HENDERSON WILLIAMS, David Andrew
    Glade
    Earleydene
    SL5 9JY Sunninghill
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Glade
    Earleydene
    SL5 9JY Sunninghill
    Berkshire
    United KingdomBritish117166560001
    HEWITT, Roger Paul
    101 Harestone Valley Road
    CR3 6HR Caterham
    Surrey
    Geschäftsführer
    101 Harestone Valley Road
    CR3 6HR Caterham
    Surrey
    EnglandBritish49966910001
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish164108510003
    JENKINS, Michael Ben
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish221017630001
    KIERNAN, David Patrick
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Irish11366290003
    LINDSELL, Philip Edmund
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    British101775640001
    MARSHALL, Michael
    35 Jubilee Place
    SW3 3TD London
    Geschäftsführer
    35 Jubilee Place
    SW3 3TD London
    United KingdomBritish70899930001
    MAXTED, Robert David
    14 Wandon Road
    SW6 2JF London
    Geschäftsführer
    14 Wandon Road
    SW6 2JF London
    British50790720001
    PRESLEY, Ronald John
    2 Vale Lodge
    KT22 8JQ Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Vale Lodge
    KT22 8JQ Leatherhead
    Surrey
    British2913710001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Geschäftsführer
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    30. Juni 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortUnited Kingdom
    Registrierungsnummer4910856
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 17. Dez. 2020
    Geliefert am 18. Dez. 2020
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch as Trustee for Each of the Secured Parties (As Defined in the Instrument)
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2020Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 18. Sept. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Nov. 2017
    Geliefert am 07. Nov. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Homes and Communities Agency
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 31. Mai 2021Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 18. Sept. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Nov. 2016
    Geliefert am 15. Nov. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The mortgaged property being 76 grasmere road, blackpool, FY1 5PN registered with title number LA472534. Please refer to the instrument for further details.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch, 90 Long Acre, London WC2E 9RA (As Common Security Agent for Each of the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 29. Nov. 2018Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 04. März 2021Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 18. Sept. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge security agreement
    Erstellt am 14. März 2008
    Geliefert am 17. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 17. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security agreement
    Erstellt am 04. Feb. 2008
    Geliefert am 15. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A security agreement
    Erstellt am 29. Jan. 2008
    Geliefert am 07. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A security agreement
    Erstellt am 29. Jan. 2008
    Geliefert am 01. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 22. Okt. 2007
    Geliefert am 25. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 09. Juni 2004
    Geliefert am 15. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 02. Juni 2004
    Geliefert am 04. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment under clause 2 of the deed.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Facility Agent)
    Transaktionen
    • 04. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage (with floating charge)
    Erstellt am 11. Nov. 2003
    Geliefert am 19. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and/or each guarantor and/or the company to the agent and/or any of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (1) f/h land k/a becton dickinson house, cowley, oxford, t/n ON83795; (2) f/h land k/a units 2001 and 2002, ravens park, coal road, seacroft, leeds WYK737596, fixed charge the goodwill, the benefit of all licences, book debts, stocks shares and other securities.floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment;.
    Berechtigte Personen
    • Bradford & Bingley PLC (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Sept. 2001
    Geliefert am 09. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land k/a the northpoint shopping centre in the city of kingston upon hull. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share charge
    Erstellt am 10. Mai 2001
    Geliefert am 17. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the borrower under oe pursuant to the financing documents (as defined therein)
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all shares.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Okt. 2000
    Geliefert am 17. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever together with bank's charges and commission interest and expenses (as hereinafter defined)
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as the northpoint shopping centre, hull title numbers HS11163, HS100274, HS142967 and HS280238 full title guarantee all legal interests and otherwise by way of fixed charge all the plant machinery and fixtures and fittings all furniture furnishings equipment tools and other chattels the goodwill any insurance charged asset.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 27. Okt. 1999
    Geliefert am 04. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a wheatsheaf shopping centre rochdale t/n GM521095 and the proceeds of sale thereof floating charge all of the assets not charge by way of fixed charge and assigns the goodwill of the business and the benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 28. Aug. 1998
    Geliefert am 16. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £3,383,520 8 per cent. First mortgage debenture stock 1999/2004 of the prudential assurance company limited and all other monies intended to be secured by this deed and the existing deeds (as therein defined) to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    The capital sum of £3,222,040 and the investments for the time being and from time to time representing the same (no such investments exist at the date of the above deed).
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 16. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Juli 1998
    Geliefert am 06. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land being part of north point shopping centre (formerley the bransholme centre) goodhart road kingston upon hull. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Juli 1998
    Geliefert am 06. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land being part of the north point shopping centre (formerly the bransholme centre) goodhart road kingston-upon-hull.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 04. Feb. 1998
    Geliefert am 10. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the outstanding £3,415,440 8 per cent first mortgage debenture stock 1999/2004 of chesterfield properties PLC and all other monies intended to be secured by this deed and the existing deeds (as therein defined) to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    £1,500,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same (no such investments existing at the date of the above deed).
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Aug. 1997
    Geliefert am 20. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 22 to 62 (even) east walk and 36 to 44 (even) southernhay basildon essex.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of subordination
    Erstellt am 30. Juni 1997
    Geliefert am 02. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from capital & comet limited (the "borrower") to the chargee on any account whatsoever and other monies incurred pursuant to the agreement constituted by the acceptance by the borrower of the bank's facility letter dated 11TH june 1997
    Kurze Angaben
    All present and future liabilities of the borrower to the company in any manner whatsoever (the "junior debt") please refer to form 395 for full details of charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 17. Juni 1997
    Geliefert am 01. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the outstanding £3,415,440 8 per cent first mortgage debenture stock 1999/2004 of chesterfield properties PLC and all other monies intended to be secured by this deed and the existing deeds (as therein defined) to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    £1,180,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 01. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Sept. 1996
    Geliefert am 08. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a basildon shopping centre 28-62 (even) east walk & 36-44 (even) southernhay basildon essex t/no EX384592 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 18. Aug. 1993
    Geliefert am 18. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £3,543,120 8 % first mortgage debenture stock 1999-2004 of chesterfirld properties PLC, and all other monies intended to be secured by the above deed adn deeds dated 30-6-66 ,29-12-66 29-12-67, 25-2-69, 30-12-70 ,31.12.71. 28.6.74 ,4.5.77,4.5.77,4/5/78. 12/2/81.19/1/82. 6/12/90, 21/8/91 ,22/12/92, and 26/2/93 to which it is supplemental.
    Kurze Angaben
    The captal sum of eight hundred and sixty thousand pounds and the investments from time to time representing the same ..
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited.
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Apr. 1993
    Geliefert am 10. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises k/as crystal peaks shopping centre mossborough sheffield and car park to the north of waterthorpe greenway. All that the goodwill and connection of any business carried on upon the property and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0