CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00400725 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 004007250086 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 004007250085 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 004007250087 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 24. Dez. 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 004007250086 | 1 Seiten | MR05 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Simon Slavin am 14. Apr. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
**Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 004007250085 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Ben Jenkins als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 004007250087, erstellt am 17. Dez. 2020 | 71 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Simon Slavin als Direktor am 13. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAZELL, Frances Victoria | Sekretär | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | 215875350001 | |||||||
| SAUNDERS, James Michael Edward | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 192568400002 | |||||
| SLAVIN, Philip Simon | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 267205160002 | |||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Sekretär | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Sekretär | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| HUGHES, Paul | Sekretär | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| KIERNAN, David Patrick | Sekretär | 7 The Haydens TN9 1NS Tonbridge Kent | Irish | 11366290003 | ||||||
| LINDSELL, Philip Edmund | Sekretär | Southside Cottage Stone Lane Axford SN8 2EY Marlborough Wiltshire | British | 101775640001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Sekretär | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 174832640001 | |||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Sekretär | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Sekretär | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| ARNOLD, Robin David Clement | Geschäftsführer | Adam & Eve Mews W8 6UG London 13a | United Kingdom | British | 136590160001 | |||||
| BOAS, John Robert Sotheby | Geschäftsführer | 5 Longwood Drive SW15 5DL London | British | 13518020001 | ||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 184444990001 | |||||
| COSSEY, Robert Duncan | Geschäftsführer | 24 Makepeace Avenue N6 6EJ London | British | 14907240001 | ||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Geschäftsführer | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | England | British | 90007990001 | |||||
| DODD, Angus Alexander | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 201606390001 | |||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Geschäftsführer | 190 Avenue Road W3 8QQ London | British | 35942980001 | ||||||
| DWYER, Tonianne | Geschäftsführer | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Geschäftsführer | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| ERDMAN, Edward Louis | Geschäftsführer | 11 Park Towers W1Y 7DF London | British | 10668170001 | ||||||
| GAMBLE, John Stuart | Geschäftsführer | The Old Lodge Itchingwood Common Limpsfield Chart Oxted Surrey | British | 14687500001 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Geschäftsführer | Grosvenor Street W1K 4QF London 16 | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| GREENSLADE, Daniel Mark | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 196504990001 | |||||
| HENDERSON WILLIAMS, David Andrew | Geschäftsführer | Glade Earleydene SL5 9JY Sunninghill Berkshire | United Kingdom | British | 117166560001 | |||||
| HEWITT, Roger Paul | Geschäftsführer | 101 Harestone Valley Road CR3 6HR Caterham Surrey | England | British | 49966910001 | |||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Geschäftsführer | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 164108510003 | |||||
| JENKINS, Michael Ben | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 221017630001 | |||||
| KIERNAN, David Patrick | Geschäftsführer | 7 The Haydens TN9 1NS Tonbridge Kent | Irish | 11366290003 | ||||||
| LINDSELL, Philip Edmund | Geschäftsführer | Southside Cottage Stone Lane Axford SN8 2EY Marlborough Wiltshire | British | 101775640001 | ||||||
| MARSHALL, Michael | Geschäftsführer | 35 Jubilee Place SW3 3TD London | United Kingdom | British | 70899930001 | |||||
| MAXTED, Robert David | Geschäftsführer | 14 Wandon Road SW6 2JF London | British | 50790720001 | ||||||
| PRESLEY, Ronald John | Geschäftsführer | 2 Vale Lodge KT22 8JQ Leatherhead Surrey | British | 2913710001 | ||||||
| RILEY, Michael Edward | Geschäftsführer | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Geschäftsführer | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintain (Holdings) Limited | 30. Juni 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 17. Dez. 2020 Geliefert am 18. Dez. 2020 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2017 Geliefert am 07. Nov. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung None. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2016 Geliefert am 15. Nov. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The mortgaged property being 76 grasmere road, blackpool, FY1 5PN registered with title number LA472534. Please refer to the instrument for further details. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge security agreement | Erstellt am 14. März 2008 Geliefert am 17. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge all its assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 04. Feb. 2008 Geliefert am 15. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 07. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 01. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 22. Okt. 2007 Geliefert am 25. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 09. Juni 2004 Geliefert am 15. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 02. Juni 2004 Geliefert am 04. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment under clause 2 of the deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage (with floating charge) | Erstellt am 11. Nov. 2003 Geliefert am 19. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower and/or each guarantor and/or the company to the agent and/or any of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (1) f/h land k/a becton dickinson house, cowley, oxford, t/n ON83795; (2) f/h land k/a units 2001 and 2002, ravens park, coal road, seacroft, leeds WYK737596, fixed charge the goodwill, the benefit of all licences, book debts, stocks shares and other securities.floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment;. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Sept. 2001 Geliefert am 09. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land k/a the northpoint shopping centre in the city of kingston upon hull. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 10. Mai 2001 Geliefert am 17. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the borrower under oe pursuant to the financing documents (as defined therein) | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all shares. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Okt. 2000 Geliefert am 17. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever together with bank's charges and commission interest and expenses (as hereinafter defined) | |
Kurze Angaben The leasehold property known as the northpoint shopping centre, hull title numbers HS11163, HS100274, HS142967 and HS280238 full title guarantee all legal interests and otherwise by way of fixed charge all the plant machinery and fixtures and fittings all furniture furnishings equipment tools and other chattels the goodwill any insurance charged asset. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 27. Okt. 1999 Geliefert am 04. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a wheatsheaf shopping centre rochdale t/n GM521095 and the proceeds of sale thereof floating charge all of the assets not charge by way of fixed charge and assigns the goodwill of the business and the benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 28. Aug. 1998 Geliefert am 16. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £3,383,520 8 per cent. First mortgage debenture stock 1999/2004 of the prudential assurance company limited and all other monies intended to be secured by this deed and the existing deeds (as therein defined) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben The capital sum of £3,222,040 and the investments for the time being and from time to time representing the same (no such investments exist at the date of the above deed). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 28. Juli 1998 Geliefert am 06. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land being part of north point shopping centre (formerley the bransholme centre) goodhart road kingston upon hull. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 28. Juli 1998 Geliefert am 06. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a land being part of the north point shopping centre (formerly the bransholme centre) goodhart road kingston-upon-hull.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 04. Feb. 1998 Geliefert am 10. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the outstanding £3,415,440 8 per cent first mortgage debenture stock 1999/2004 of chesterfield properties PLC and all other monies intended to be secured by this deed and the existing deeds (as therein defined) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben £1,500,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same (no such investments existing at the date of the above deed). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Aug. 1997 Geliefert am 20. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 22 to 62 (even) east walk and 36 to 44 (even) southernhay basildon essex.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of subordination | Erstellt am 30. Juni 1997 Geliefert am 02. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from capital & comet limited (the "borrower") to the chargee on any account whatsoever and other monies incurred pursuant to the agreement constituted by the acceptance by the borrower of the bank's facility letter dated 11TH june 1997 | |
Kurze Angaben All present and future liabilities of the borrower to the company in any manner whatsoever (the "junior debt") please refer to form 395 for full details of charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 17. Juni 1997 Geliefert am 01. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the outstanding £3,415,440 8 per cent first mortgage debenture stock 1999/2004 of chesterfield properties PLC and all other monies intended to be secured by this deed and the existing deeds (as therein defined) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben £1,180,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Sept. 1996 Geliefert am 08. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a basildon shopping centre 28-62 (even) east walk & 36-44 (even) southernhay basildon essex t/no EX384592 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 18. Aug. 1993 Geliefert am 18. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £3,543,120 8 % first mortgage debenture stock 1999-2004 of chesterfirld properties PLC, and all other monies intended to be secured by the above deed adn deeds dated 30-6-66 ,29-12-66 29-12-67, 25-2-69, 30-12-70 ,31.12.71. 28.6.74 ,4.5.77,4.5.77,4/5/78. 12/2/81.19/1/82. 6/12/90, 21/8/91 ,22/12/92, and 26/2/93 to which it is supplemental. | |
Kurze Angaben The captal sum of eight hundred and sixty thousand pounds and the investments from time to time representing the same .. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. Apr. 1993 Geliefert am 10. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and premises k/as crystal peaks shopping centre mossborough sheffield and car park to the north of waterthorpe greenway. All that the goodwill and connection of any business carried on upon the property and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0