WELDGRIP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWELDGRIP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00403085
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WELDGRIP LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich WELDGRIP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WELDGRIP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SPENCER MESH LIMITED12. Jan. 194612. Jan. 1946

    Welche sind die letzten Einreichungen für WELDGRIP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Dez. 2012

    6 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 15. Dez. 2011

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 Seiten4.70

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Mai 2011

    Kapitalaufstellung am 26. Mai 2011

    • Kapital: GBP 1,300,500
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Stuart Morriss am 08. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Lloyd Kynaston am 08. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Michael Hayhurst am 08. Mai 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von WELDGRIP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAYHURST, Michael
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Sekretär
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    British15201970002
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish10529040001
    MORRISS, Andrew Stuart
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish11643310001
    BAKER, Arthur Sidney
    Tanglewood
    25 Chantry Road Stourton
    DY7 6SA Stourbridge
    West Midlands
    Sekretär
    Tanglewood
    25 Chantry Road Stourton
    DY7 6SA Stourbridge
    West Midlands
    British37624890002
    CRIBB, Nicholas Stephen
    16 Glebe Road
    B91 2LX Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    16 Glebe Road
    B91 2LX Solihull
    West Midlands
    British100811140001
    DAVIES, John Graeme
    Airlie
    Roberts Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 0QR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Airlie
    Roberts Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 0QR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British72253030004
    SANDLAND, Nicholas Edward
    2 Boningale Way
    ST17 9UN Stafford
    Staffordshire
    Sekretär
    2 Boningale Way
    ST17 9UN Stafford
    Staffordshire
    British20983630001
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Sekretär
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    British36008490001
    BAKER, Arthur Sidney
    Tanglewood
    25 Chantry Road Stourton
    DY7 6SA Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Tanglewood
    25 Chantry Road Stourton
    DY7 6SA Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish37624890002
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    British72559760001
    GRAHAM, Ian Lawrence
    Pendle House
    10 Castle Hill
    SK10 4AR Prestbury
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Pendle House
    10 Castle Hill
    SK10 4AR Prestbury
    Cheshire
    Australian31470130002
    HALL, John
    Charnes Hall
    ST21 6NP Eccleshall
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Charnes Hall
    ST21 6NP Eccleshall
    Staffordshire
    British9819250001
    HINKINS, Brian Edward Walter
    38 Newick Avenue
    Little Aston
    B74 3DA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    38 Newick Avenue
    Little Aston
    B74 3DA Sutton Coldfield
    West Midlands
    British52146460001
    HUGHES, Mark Leonard William
    Pippin Lodge Church Road
    Snitterfield
    CV37 0LF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Pippin Lodge Church Road
    Snitterfield
    CV37 0LF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British51202520001
    HUSSEY, David Gordon
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    British131639570001
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    United KingdomBritish10529040001
    PARROTT, Antony Graham
    40-42 Hall Cliffe Road
    Horbury
    WF4 6BZ Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    40-42 Hall Cliffe Road
    Horbury
    WF4 6BZ Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish9950960001
    ROACHE, David John
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    United KingdomBritish40953790002
    SMITH, Alastair Moray
    Ryecroft Stafford Road
    Great Bridgeford
    ST18 9SQ Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Ryecroft Stafford Road
    Great Bridgeford
    ST18 9SQ Stafford
    Staffordshire
    British9819210001
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish1600540001
    WILKINSON, Brian Stanley
    Murano Beech Lane
    Coppenhall
    ST18 9BT Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Murano Beech Lane
    Coppenhall
    ST18 9BT Stafford
    Staffordshire
    British9819220001
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    British36008490001

    Hat WELDGRIP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A hong kong law governed supplemental debenture dated 24TH august 1999
    Erstellt am 24. Aug. 1999
    Geliefert am 10. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured obligations due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee arising under the debenture as amended
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A singapore law governed supplemental debenture dated 24TH august 1999
    Erstellt am 24. Aug. 1999
    Geliefert am 10. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured obligations due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee arising under the debenture as amended
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture to target group debenture
    Erstellt am 24. Aug. 1999
    Geliefert am 10. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured obligations due or to become due from each charging entity to the chargee under or pursuant to the debenture (as amended)
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property (other than the heritable property in scotland) owned by the company or in which the company has an interest at the date of the charge all its other assets and undertakings (and all rights in respect thereof). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited as Security Agent for and on Behalf of the Financeparties (As Defined in the Supplemental Debenture) from Time to Time
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A composite guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Juli 1999
    Geliefert am 12. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and all obligations due or to become due from the company to the chargee acting as security agent for the finance parties (as defined) or any of them pursuant to the facilities agreement including without limitation all monies obligations and liabilities due owing or incurred under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A composite (singapore law governed) guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Juli 1999
    Geliefert am 12. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and all obligations due or to become due from the company to the chargee acting as security agent for the finance parties (as defined) or any of them pursuant to the facilities agreement including without limitation all monies obligations and liabilities due owing or incurred as from time to time varies or extended under or pursuant to the target group debenture (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A composite (hong kong law governed) guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Juli 1999
    Geliefert am 12. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and all obligations due or to become due from the company to the chargee acting as security agent for the finance parties (as defined) or any of them pursuant to the facilities agreement including without limitation all monies obligations and liabilities due owing or incurred as from time to time varies or extended under or pursuant to the target group debenture (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Feb. 1998
    Geliefert am 16. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from takao hall property to the chargee under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    F/H plot 6000 gloucester business park hucclecote road gloucester t/n GR189089 all estates or interests all buildings fixtures proceeds of sale benefit of any covenants floating charge all assets not otherwise mortgaged or charged by way of fixed mortgage or charge.
    Berechtigte Personen
    • The Sumitomo Bank Limited
    Transaktionen
    • 16. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Aug. 1995
    Geliefert am 01. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the other secured parties (as defined) under or in connection with any of the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge on book debts and other debts
    Erstellt am 23. Aug. 1991
    Geliefert am 30. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all book debts and other debts (including any funds standing to the credit of the company from time to time on any account. (See form 395 document M90C for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 09. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on book debts
    Erstellt am 19. Juli 1991
    Geliefert am 25. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 09. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WELDGRIP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. März 2014Aufgelöst am
    15. Dez. 2011Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0