ASTRA HOUSE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameASTRA HOUSE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00410217
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ASTRA HOUSE LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich ASTRA HOUSE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASTRA HOUSE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für ASTRA HOUSE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 14. Nov. 2019

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Robert Marshall als Direktor am 14. Okt. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Alan Matthew Syers als Geschäftsführer am 14. Okt. 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Terence Millington als Geschäftsführer am 01. Juli 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2018

    22 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    20 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    22 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Terence Millington am 22. Nov. 2016

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Roderick Michael Evans am 22. Nov. 2016

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Alan Matthew Syers am 22. Nov. 2016

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Andreas Frederick Evans als Geschäftsführer am 31. März 2016

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von ASTRA HOUSE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MARSHALL, Robert
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    Sekretär
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    165717270001
    EVANS, Roderick Michael
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    Geschäftsführer
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    United KingdomBritish40175270005
    MARSHALL, Robert
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    Geschäftsführer
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    United KingdomBritish190577840001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Sekretär
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Sekretär
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Sekretär
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MARCUS, Ian
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    Geschäftsführer
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    EnglandBritish85847920002
    MILLINGTON, Paul Terence
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    Geschäftsführer
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    United KingdomBritish58693930003
    SYERS, Alan Matthew
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    Geschäftsführer
    Millshaw
    Ring Road
    LS11 8EG Beeston
    Leeds
    EnglandBritish65588650002
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASTRA HOUSE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Evans Residential Holdings Limited
    Ring Road
    LS11 8EG Leeds
    Millshaw
    England
    06. Apr. 2016
    Ring Road
    LS11 8EG Leeds
    Millshaw
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer6006096
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat ASTRA HOUSE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. März 2007
    Geliefert am 30. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h land and buildings lying to the south of millshaw leeds west yorkshire k/a unit L1 millshaw park t/n WYK61658 together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries
    Transaktionen
    • 30. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. März 2007
    Geliefert am 30. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at orchard farm streethay lichfield t/n SF157390 f/h land lying to the north side of orchard farm streethay lichfield t/n SF290964 and f/h land adjoining on the north side of orchard farm streethay lichfield t/NSF156380 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery and the procceds of sale of the same floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 30. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Juni 2005
    Geliefert am 18. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land k/a hawarden hill, dollis hill lane, london t/no. NGL411856 together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 18. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Erstellt am 03. Aug. 1999
    Geliefert am 16. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of release & substitution
    Erstellt am 18. Sept. 1997
    Geliefert am 22. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds PLC and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    Land and buildings to the south of millshaw leeds t/n WYK61658 together with all buildings erections fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 20. Sept. 1996
    Geliefert am 24. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal amount of the original stock and the new stock together with interest arising under a trust deed dated 20TH september 1985,a deed of release and substitution dated 7TH april 1988,a first supplemental trust deed dated 1ST february 1989,a deed of release dated 29TH march 1989,a second supplemental trust deed dated 4TH december 1992,a third supplemental trust deed dated 4TH november 1993,a deed of release and substitution dated 29TH september 1994,a deed of confirmation dated 17TH november 1994,a deed of release dated 12TH july 1995,a deed of release and substitution dated 26TH september 1995 and a deed of release dated 21ST june 1996 together constituting and securing £100,000,000 11 per cent first mortgage debenture stock 2025.
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a bridge house outwood lane horsforth t/n wyk 433235.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1980
    Geliefert am 30. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from evas of leeds limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and premises on the south side of hauison street, leeds.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Nora Scotia
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 24. März 1977
    Geliefert am 25. März 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever evans of leeds limited. Not exceeding ukp 300,000.
    Kurze Angaben
    Land and premises on the south side of harrison street leeds.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 25. März 1977Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 11. Juni 1971
    Geliefert am 11. Juni 1971
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Memo of deposit for securing all monies due its from boden investments LTD. Not exceeding £190,000
    Kurze Angaben
    Property on the s/side of harrison st., Leeds.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 11. Juni 1971Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0