ASTRA HOUSE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASTRA HOUSE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00410217 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASTRA HOUSE LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich ASTRA HOUSE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Millshaw Ring Road LS11 8EG Beeston Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASTRA HOUSE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASTRA HOUSE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. Nov. 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert Marshall als Direktor am 14. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Matthew Syers als Geschäftsführer am 14. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Terence Millington als Geschäftsführer am 01. Juli 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2018 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Terence Millington am 22. Nov. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Roderick Michael Evans am 22. Nov. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alan Matthew Syers am 22. Nov. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andreas Frederick Evans als Geschäftsführer am 31. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASTRA HOUSE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSHALL, Robert | Sekretär | Millshaw Ring Road LS11 8EG Beeston Leeds | 165717270001 | |||||||
| EVANS, Roderick Michael | Geschäftsführer | Millshaw Ring Road LS11 8EG Beeston Leeds | United Kingdom | British | 40175270005 | |||||
| MARSHALL, Robert | Geschäftsführer | Millshaw Ring Road LS11 8EG Beeston Leeds | United Kingdom | British | 190577840001 | |||||
| CURTIS, Ernest Leonard | Sekretär | Cedar Lodge Greenfield Lane Hawksworth Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | 19382660001 | ||||||
| GIBSON, William Mcaulay | Sekretär | Ivy Bank 1 Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 5387660001 | ||||||
| GILBERT, Nicholas Jay | Sekretär | Woodville 14 Carlton Park Avenue WF8 3HQ Pontefract West Yorkshire | British | 81344240001 | ||||||
| JOBBINS, Stuart | Sekretär | 16 Riverside Avenue LS21 2RT Otley West Yorkshire | British | 108146440001 | ||||||
| MILLINGTON, Paul Terence | Sekretär | 2a Gilleyfield Avenue Dore S17 3NS Sheffield | British | 58693930003 | ||||||
| BELL, John Drummond | Geschäftsführer | Gates Garth 49 Rutland Drive HG1 2NX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 63940900001 | |||||
| BEST, George Laidler | Geschäftsführer | Kiddall Hall Farm York Road Barwick In Elmet LS14 3AE Leeds West Yorkshire | British | 2748600001 | ||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Geschäftsführer | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||
| CURTIS, Ernest Leonard | Geschäftsführer | Cedar Lodge Greenfield Lane Hawksworth Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | 19382660001 | ||||||
| EVANS, Andreas Frederick | Geschäftsführer | Leathley Grange LS21 2LA Leathley North Yorkshire | United Kingdom | British | 9485290003 | |||||
| EVANS, Dominic Redvers | Geschäftsführer | Pine Lodge 9 Sandmoor Avenue LS17 7DW Leeds West Yorkshire | British | 7095590001 | ||||||
| EVANS, Frederick Redvers | Geschäftsführer | 16 Sandmoor Drive LS17 7DG Leeds West Yorkshire | British | 4409160001 | ||||||
| GIBSON, William Mcaulay | Geschäftsführer | Ivy Bank 1 Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 5387660001 | ||||||
| HELLIWELL, David Alistair | Geschäftsführer | 8 Farndale Close Spofforth Hill LS22 4XE Wetherby West Yorkshire | England | British | 15578740001 | |||||
| HORSBROUGH, Pauline Elizabeth | Geschäftsführer | 30 The Orchard Wrenthorpe WF2 0LL Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 4961270001 | |||||
| MARCUS, Ian | Geschäftsführer | Millshaw Ring Road LS11 8EG Beeston Leeds | England | British | 85847920002 | |||||
| MILLINGTON, Paul Terence | Geschäftsführer | Millshaw Ring Road LS11 8EG Beeston Leeds | United Kingdom | British | 58693930003 | |||||
| SYERS, Alan Matthew | Geschäftsführer | Millshaw Ring Road LS11 8EG Beeston Leeds | England | British | 65588650002 | |||||
| TURNER, Philip Arthur | Geschäftsführer | Red Roofs 2 Mulberry Garth Thorp Arch LS23 7AF Wetherby West Yorkshire | British | 66424440001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASTRA HOUSE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evans Residential Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Ring Road LS11 8EG Leeds Millshaw England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ASTRA HOUSE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 28. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h land and buildings lying to the south of millshaw leeds west yorkshire k/a unit L1 millshaw park t/n WYK61658 together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at orchard farm streethay lichfield t/n SF157390 f/h land lying to the north side of orchard farm streethay lichfield t/n SF290964 and f/h land adjoining on the north side of orchard farm streethay lichfield t/NSF156380 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery and the procceds of sale of the same floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Juni 2005 Geliefert am 18. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land k/a hawarden hill, dollis hill lane, london t/no. NGL411856 together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999) | Erstellt am 03. Aug. 1999 Geliefert am 16. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release & substitution | Erstellt am 18. Sept. 1997 Geliefert am 22. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds PLC and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Land and buildings to the south of millshaw leeds t/n WYK61658 together with all buildings erections fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 20. Sept. 1996 Geliefert am 24. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal amount of the original stock and the new stock together with interest arising under a trust deed dated 20TH september 1985,a deed of release and substitution dated 7TH april 1988,a first supplemental trust deed dated 1ST february 1989,a deed of release dated 29TH march 1989,a second supplemental trust deed dated 4TH december 1992,a third supplemental trust deed dated 4TH november 1993,a deed of release and substitution dated 29TH september 1994,a deed of confirmation dated 17TH november 1994,a deed of release dated 12TH july 1995,a deed of release and substitution dated 26TH september 1995 and a deed of release dated 21ST june 1996 together constituting and securing £100,000,000 11 per cent first mortgage debenture stock 2025. | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a bridge house outwood lane horsforth t/n wyk 433235. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Dez. 1980 Geliefert am 30. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from evas of leeds limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and premises on the south side of hauison street, leeds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 24. März 1977 Geliefert am 25. März 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever evans of leeds limited. Not exceeding ukp 300,000. | |
Kurze Angaben Land and premises on the south side of harrison street leeds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 11. Juni 1971 Geliefert am 11. Juni 1971 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Memo of deposit for securing all monies due its from boden investments LTD. Not exceeding £190,000 | |
Kurze Angaben Property on the s/side of harrison st., Leeds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0