HMV RETAIL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HMV RETAIL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00411080 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HMV RETAIL LIMITED?
- (5248) /
Wo befindet sich HMV RETAIL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 100 New Bridge Street London EC4V 6JA |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HMV RETAIL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HMV GROUP LIMITED | 04. Juni 1987 | 04. Juni 1987 |
| HMV RETAIL INTERNATIONAL LIMITED | 10. März 1986 | 10. März 1986 |
| TANSLEY & COOKE LIMITED | 21. Mai 1946 | 21. Mai 1946 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HMV RETAIL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HMV RETAIL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 353a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Apr. 2007 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Apr. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HMV RETAIL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Sekretär | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 73539350001 | |||||||
| GOTO, Toshitake | Geschäftsführer | 1-26-14 Hatsudai, Shibuya-Ku FOREIGN Tokyo Japan | Japanese | 124493910001 | ||||||
| OTA, Tatsunosuke | Geschäftsführer | 3-21-16 Shoan Suginami-Ku Toyo Japan | Japanese | 135463360001 | ||||||
| BRIGHT, Neil Irvine | Sekretär | Pound End Cedar Drive, Cookham SL6 9DZ Maidenhead Berkshire | British | 180993450001 | ||||||
| CAMPBELL, Laurence James | Sekretär | Mellbreak Dell Grove Frimley GU16 5PZ Camberley Surrey | British | 27960300001 | ||||||
| HOWELL, Peter Graham | Sekretär | 76 Kings Road SW19 8QW London | British | 62634010001 | ||||||
| LYMATH, Michael Gerald | Sekretär | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | British | 76768320001 | ||||||
| MARRINER, Elaine | Sekretär | 48 Hemsdale Pinkneys Green SL6 6SL Maidenhead Berkshire | British | 40470020001 | ||||||
| RITCHIE, Ian | Sekretär | 66 Cherwell Drive Marston OX3 0LZ Oxford Oxfordshire | British | 68246050001 | ||||||
| SMITH, George Marsden | Sekretär | 18 Bevin Square SW17 7BB London | British | 15729150003 | ||||||
| TOMBLIN, Denise Lynne | Sekretär | 20 Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough Buckinghamshire | British | 63502600001 | ||||||
| ALOFS, Paul | Geschäftsführer | 283 Heath Street East Toronto FOREIGN Ontario Canada | Canadian | 27960290002 | ||||||
| BELL, Duncan Charles | Geschäftsführer | Longwood Queen Annes Road SL4 2BJ Windsor Berkshire | British | 9950440002 | ||||||
| BRIGHT, Neil Irvine | Geschäftsführer | Pound End Cedar Drive, Cookham SL6 9DZ Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | 180993450001 | |||||
| CAMPBELL, Laurence James | Geschäftsführer | Mellbreak Dell Grove Frimley GU16 5PZ Camberley Surrey | British | 27960300001 | ||||||
| CHRISTIANS, Sharon Jane | Geschäftsführer | Le Faure 33890 Gensac France | British | 91189160002 | ||||||
| FOX, Simon Richard | Geschäftsführer | St Nicolas House Rectory Road Taplow SL6 0ET Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | 58101280002 | |||||
| GILES, Alan James | Geschäftsführer | Tanglewood Crowsley Road RG9 3LE Shiplake Oxfordshire | England | British | 156046020001 | |||||
| GOVIER, Leonard Edward | Geschäftsführer | Skarra Beechfield Road SK9 7AU Alderley Edge Cheshire | British | 27960310001 | ||||||
| HASEGAWA, Tetsuzo Hasegawa | Geschäftsführer | 1-16-17 Gakuenhigashico, Kodaira-Shi FOREIGN Tokyo Japan | Japanese | 124493830001 | ||||||
| HOWELL, Peter Graham | Geschäftsführer | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||
| LUCKHURST, Peter Martin | Geschäftsführer | 423 Walmer Road Toronto Ontario M5p 2x9 Canada | British | 70061260001 | ||||||
| LYMATH, Michael Gerald | Geschäftsführer | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | England | British | 76768320001 | |||||
| LYMATH, Michael Gerald | Geschäftsführer | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | England | British | 76768320001 | |||||
| MCALLISTER, Stuart | Geschäftsführer | The Granary 38 Wellington Street OX9 3BN Thame Oxfordshire | British | 9406880001 | ||||||
| MCLAUGHLIN, Brian Finbar | Geschäftsführer | Pangbourne Lodge Tidmarsh Road RG8 7AZ Pangbourne Berkshire | United Kingdom | British | 9950470002 | |||||
| OKADO, Takeshi | Geschäftsführer | 4-22-1 Shibaura, Minato-Ku FOREIGN Tokyo Japan | Japanese | 124493970001 | ||||||
| VALLANCE, Elizabeth Mary, Dr | Geschäftsführer | 22 Dulwich Wood Avenue SE19 1HD London | British | 27960320001 |
Hat HMV RETAIL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A supplemental charge (supplemental to a debenture dated 28 march 1998) | Erstellt am 22. Mai 1998 Geliefert am 10. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (the "security agent") (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement dated 28 march 1998 (including the supplemental charge and the debenture) | |
Kurze Angaben First floating charge all rights title and interests of the company relating to copyrights in published and unpublished works, registered designs, unregistered designs, design rights, patents, inventions, trade marks, get up rights in and/or relating to databases, rights to computer software, know how etc and all other similar rights including the benefit of licences under the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Mai 1998 Geliefert am 04. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge (to a debenture dated 28TH march 1998 as amended and restated on 14TH may 1998, the "amended and restated debenture") | Erstellt am 22. Mai 1998 Geliefert am 03. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including a floating charge over all intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998) | Erstellt am 14. Mai 1998 Geliefert am 15. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. März 1998 Geliefert am 09. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent") (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (as defined) under or pursuant to the senior facility agreement (as defined) (including the debenture) including further advances | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. März 1998 Geliefert am 09. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0