HMV RETAIL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHMV RETAIL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00411080
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HMV RETAIL LIMITED?

    • (5248) /

    Wo befindet sich HMV RETAIL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    100 New Bridge Street
    London
    EC4V 6JA
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HMV RETAIL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HMV GROUP LIMITED04. Juni 198704. Juni 1987
    HMV RETAIL INTERNATIONAL LIMITED10. März 198610. März 1986
    TANSLEY & COOKE LIMITED21. Mai 194621. Mai 1946

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HMV RETAIL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für HMV RETAIL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Conflict of interest 26/05/2009
    RES13

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008

    26 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten353a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Apr. 2007

    22 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Apr. 2006

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von HMV RETAIL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Sekretär
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    73539350001
    GOTO, Toshitake
    1-26-14 Hatsudai,
    Shibuya-Ku
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    Geschäftsführer
    1-26-14 Hatsudai,
    Shibuya-Ku
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    Japanese124493910001
    OTA, Tatsunosuke
    3-21-16 Shoan Suginami-Ku
    Toyo
    Japan
    Geschäftsführer
    3-21-16 Shoan Suginami-Ku
    Toyo
    Japan
    Japanese135463360001
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    British180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Sekretär
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Sekretär
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    British62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Sekretär
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    48 Hemsdale
    Pinkneys Green
    SL6 6SL Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    48 Hemsdale
    Pinkneys Green
    SL6 6SL Maidenhead
    Berkshire
    British40470020001
    RITCHIE, Ian
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    Sekretär
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    British68246050001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Sekretär
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Sekretär
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    ALOFS, Paul
    283 Heath Street East
    Toronto
    FOREIGN Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    283 Heath Street East
    Toronto
    FOREIGN Ontario
    Canada
    Canadian27960290002
    BELL, Duncan Charles
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    British9950440002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    CHRISTIANS, Sharon Jane
    Le Faure
    33890 Gensac
    France
    Geschäftsführer
    Le Faure
    33890 Gensac
    France
    British91189160002
    FOX, Simon Richard
    St Nicolas House Rectory Road
    Taplow
    SL6 0ET Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    St Nicolas House Rectory Road
    Taplow
    SL6 0ET Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish58101280002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    GOVIER, Leonard Edward
    Skarra Beechfield Road
    SK9 7AU Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Skarra Beechfield Road
    SK9 7AU Alderley Edge
    Cheshire
    British27960310001
    HASEGAWA, Tetsuzo Hasegawa
    1-16-17 Gakuenhigashico,
    Kodaira-Shi
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    Geschäftsführer
    1-16-17 Gakuenhigashico,
    Kodaira-Shi
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    Japanese124493830001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Geschäftsführer
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    LUCKHURST, Peter Martin
    423 Walmer Road
    Toronto
    Ontario M5p 2x9
    Canada
    Geschäftsführer
    423 Walmer Road
    Toronto
    Ontario M5p 2x9
    Canada
    British70061260001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritish76768320001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritish76768320001
    MCALLISTER, Stuart
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    British9406880001
    MCLAUGHLIN, Brian Finbar
    Pangbourne Lodge
    Tidmarsh Road
    RG8 7AZ Pangbourne
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Pangbourne Lodge
    Tidmarsh Road
    RG8 7AZ Pangbourne
    Berkshire
    United KingdomBritish9950470002
    OKADO, Takeshi
    4-22-1 Shibaura, Minato-Ku
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    Geschäftsführer
    4-22-1 Shibaura, Minato-Ku
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    Japanese124493970001
    VALLANCE, Elizabeth Mary, Dr
    22 Dulwich Wood Avenue
    SE19 1HD London
    Geschäftsführer
    22 Dulwich Wood Avenue
    SE19 1HD London
    British27960320001

    Hat HMV RETAIL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A supplemental charge (supplemental to a debenture dated 28 march 1998)
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 10. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the "security agent") (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement dated 28 march 1998 (including the supplemental charge and the debenture)
    Kurze Angaben
    First floating charge all rights title and interests of the company relating to copyrights in published and unpublished works, registered designs, unregistered designs, design rights, patents, inventions, trade marks, get up rights in and/or relating to databases, rights to computer software, know how etc and all other similar rights including the benefit of licences under the same. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation (As "Security Agent")
    Transaktionen
    • 10. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 04. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge (to a debenture dated 28TH march 1998 as amended and restated on 14TH may 1998, the "amended and restated debenture")
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 03. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including a floating charge over all intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 03. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998)
    Erstellt am 14. Mai 1998
    Geliefert am 15. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 15. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent") (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (as defined) under or pursuant to the senior facility agreement (as defined) (including the debenture) including further advances
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0