NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00414351 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St. James House 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road RM1 3NH Romford Essex United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NORFOLK CAPITAL GROUP P L C | 04. Juli 1946 | 04. Juli 1946 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Sept. 2023
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Change of details for Dtp Finance Number 1 Limited as a person with significant control on 07. Aug. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Valor Hospitality Europe Ltd St. James House, 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH United Kingdom zum St. James House 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH am 07. Aug. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Warunya Punawakul am 24. März 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Wanida Suksuwan am 24. März 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Hansa Susayan am 24. März 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Change of details for Dtp Finance Number 1 Limited as a person with significant control on 24. März 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG zum Valor Hospitality Europe Ltd St. James House, 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH am 24. März 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 004143510015 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Andre Kula als Geschäftsführer am 10. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNAWAKUL, Warunya | Geschäftsführer | 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road RM1 3NH Romford St. James House Essex United Kingdom | Thailand | Thai | 265448120001 | |||||
| SUKSUWAN, Wanida | Geschäftsführer | 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road RM1 3NH Romford St. James House Essex United Kingdom | Thailand | Thai | 265450970001 | |||||
| SUSAYAN, Hansa | Geschäftsführer | 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road RM1 3NH Romford St. James House Essex United Kingdom | Thailand | Thai | 265450980001 | |||||
| BURGESS, Keith John | Sekretär | 3 Queen Annes Gate White House Walk GU9 9AN Farnham Surrey | British | 7009790002 | ||||||
| CHRISTIAN, Tracy Joanne | Sekretär | 19 Lovell Walk RM13 7ND Rainham Essex | British | 102667300001 | ||||||
| COUGHLAN, Sally Ann | Sekretär | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | British | 107832420001 | ||||||
| JONES, Vanessa | Sekretär | Stables House Castle Hill RH1 4LB Bletchingley Surrey | British | 72146200001 | ||||||
| PURVIS, Martin Terence Alan | Sekretär | Fenetters Melfort Road TN6 1QT Crowborough East Sussex | British | 7901050001 | ||||||
| WALLER, Ronald John | Sekretär | Brindles 118 Hanging Hill Lane CM13 2HN Brentwood Essex | British | 1210620001 | ||||||
| WATERS, Jonathan Roy | Sekretär | Maldon Road CO3 3BQ Colchester 237 Essex | British | 129848360001 | ||||||
| ALLSOP, Heather Louise | Geschäftsführer | 62 Prebend Street N1 8PS London | British | 101912850001 | ||||||
| ARZI, David | Geschäftsführer | 38th Floor NY 10036 New York One Bryant Park Usa | United States | American | 190079640001 | |||||
| BAIRSTOW, John | Geschäftsführer | Frieze Cottage Coxtie Green Road South Weald CM14 5RE Brentwood Essex | British | 537400001 | ||||||
| BELL, Gerald James | Geschäftsführer | Cavewood Rectory Lane Datchworth SG3 6RD Knebworth Hertfordshire | British | 47018930002 | ||||||
| BRAIDLEY, Jonathan Patrick | Geschäftsführer | 16 Palace Street SW1E 5JD London Mcap Global Finance (Uk) Llp United Kingdom | United Kingdom | British | 190075510001 | |||||
| CAIRNS, Michael Anthony | Geschäftsführer | Birchlands Old Avenue KT13 0PY Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 36488470001 | |||||
| COLES, Alan Clifford | Geschäftsführer | The Knoll Grendon NN7 1JG Northampton Beeches, 5 Northamptonshire | England | British | 101144900002 | |||||
| COLLYER, Brian Charles | Geschäftsführer | 49 Route De Croissy 78110 Le Vesinet France | Canadian | 101144260001 | ||||||
| COPPEL, Andrew Maxwell | Geschäftsführer | Orchard House 8 Claremont Park Road KT10 9LT Esher Surrey | England | British | 14330100002 | |||||
| FINKLEMAN, Michael David | Geschäftsführer | Charlewood Manor Crescent, Seer Green HP9 2QX Beaconsfield Buckinghamshire | British | 66057660001 | ||||||
| GOIN, Russell Todd | Geschäftsführer | 4 Rue Jadin 75017 FOREIGN Paris France | American | 108675490001 | ||||||
| HERSEY, David Michael | Geschäftsführer | Greenways Ridgeway Hutton Mount CM13 2LS Brentwood Essex | British | 17567250001 | ||||||
| KABALAN, Fadi | Geschäftsführer | Keyes House Dolphin Square SW1V 3NA London Suite 311 | England | British | 133846470001 | |||||
| KRAIS, Ashley Simon | Geschäftsführer | 74 Marsh Lane NW7 4NT London | United Kingdom | British | 105921220001 | |||||
| KULA, Christopher Andre | Geschäftsführer | 16 Palace Street SW1E 5JD London Mcap Global Finance (Uk) Llp United Kingdom | United Kingdom | British,Canadian,German | 219684180001 | |||||
| LE POIDEVIN, Andrew Daryl | Geschäftsführer | Kinneil 34 Bulstrode Way SL9 7QU Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 4958800007 | |||||
| MARCUS, Martin Alan | Geschäftsführer | 17 Monkhams Drive IG8 0LG Woodford Green Essex | British | 35543430001 | ||||||
| MENARD, Veronique Pascale Dominique | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International England | United Kingdom | French | 141156250001 | |||||
| METCALFE, Michael Stuart | Geschäftsführer | Harwil 37 Howards Thicket SL9 7NT Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 40294180002 | |||||
| MOORE, Richard John | Geschäftsführer | 2 Maple Wood Bedhampton PO9 3JB Havant Hampshire | England | British | 101144680001 | |||||
| MULAHASANI, Heather Louise | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International | England | British | 136994090001 | |||||
| OGDEN, Kathryn | Geschäftsführer | 14 Arundel Court 43-47 Arundel Gardens W11 2LP London | American | 114248790002 | ||||||
| PORTER, Allan William | Geschäftsführer | 147 Worrin Road CM15 8JR Shenfield Essex | British | 17567090001 | ||||||
| QUINN, Martin Joseph | Geschäftsführer | 34 Francis Grove, Wimbledon SW19 4DT London Westmont Management Limited England | England | Irish | 186571310001 | |||||
| RIECK, Erwin Joseph | Geschäftsführer | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | German | 108675520002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dtp Finance Number 1 Limited | 06. Apr. 2016 | 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road RM1 3NH Romford St. James House Essex United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 09. Juni 2017 | 25. Jan. 2018 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat NORFOLK CAPITAL GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 28. Nov. 2017 Geliefert am 28. Nov. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 23. Juli 2015 Geliefert am 05. Aug. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 22. Feb. 2011 Geliefert am 02. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (For details of properties charged please refer to form MG01) fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Feb. 2005 Geliefert am 11. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by an obligor or by some other person of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 23. Feb. 2005 Geliefert am 04. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Nov. 2004 Geliefert am 14. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juni 2004 Geliefert am 25. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental accession deed to the composite guarantee and debenture | Erstellt am 08. Juni 2004 Geliefert am 11. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 25. März 2004 Geliefert am 26. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit of deeds without instrument | Erstellt am 28. Mai 1974 Geliefert am 30. Mai 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben 12,13,14,15,16,17,18,19 & 20 montague street camden. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal sub-mortgage | Erstellt am 16. Aug. 1965 Geliefert am 18. Aug. 1965 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben 234, 235 and 236 tottenham court road and 11,12 and 13 bayley street, london WC1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 09. Okt. 1963 Geliefert am 30. Okt. 1963 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc | |
Kurze Angaben The norfolk hotel, being the premises nos. 146, 147 & 148 kings road & nos. 6.7.8 & 9 bedford square, brighton with trade & other fixtures, plant, future, goodwill of the business isssued on thereat and benefit of all licences hold on connection therewith (see doc. 67). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge without written inster. | Erstellt am 12. Jan. 1960 Geliefert am 18. Jan. 1960 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc. | |
Kurze Angaben 6-9, bedford square and 146-148, kings road, brighton, sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 17. Dez. 1959 Geliefert am 23. Dez. 1959 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben The norfolk hotel, brighton, sussex, together with all trade and other fixtures present and future, including goodwill of the business and benefit of alllicences held in connection thereon with all compensation etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge without written instrument | Erstellt am 23. Juli 1959 Geliefert am 04. Aug. 1959 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben Norfolk hotel (hove) LTD kings road, brighton, sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0