QMH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | QMH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00416937 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von QMH LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich QMH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 27 Old Gloucester Street WC1N 3AX London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von QMH LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| QUEENS MOAT HOUSES LIMITED | 08. Nov. 2004 | 08. Nov. 2004 |
| QUEENS MOAT HOUSES PLC | 19. Mai 1995 | 19. Mai 1995 |
| QUEEN'S MOAT HOUSES P L C | 09. Aug. 1946 | 09. Aug. 1946 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QMH LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für QMH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 15 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2020 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 15 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 42 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE England zum 27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX am 05. März 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Felipe Kodellas De La Morena als Geschäftsführer am 14. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Vernon Bernard Schwartz als Geschäftsführer am 14. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Tavis Colm Peter Cannell als Geschäftsführer am 14. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Alan Wiltshire als Geschäftsführer am 14. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Guillaume Pierre Marie Cassou als Geschäftsführer am 14. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für David Frauman am 19. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für David Frauman am 19. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 48 Seiten | AA | ||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 22 | 14 Seiten | MR05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 8 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Julia Butler als Geschäftsführer am 19. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Vernon Bernard Schwartz am 02. März 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung von Tavis Cannell als Direktor am 17. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Jeremy Alan Wiltshire als Direktor am 17. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Sarah Louise Warhurst als Geschäftsführer am 17. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von QMH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUGHLAN, Sally Ann | Sekretär | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 United Kingdom | British | 107832420001 | ||||||
| FRAUMAN, David | Geschäftsführer | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 United Kingdom | England | British | 181556770004 | |||||
| BURGESS, Keith John | Sekretär | 3 Queen Annes Gate White House Walk GU9 9AN Farnham Surrey | British | 7009790002 | ||||||
| CHRISTIAN, Tracy Joanne | Sekretär | 19 Lovell Walk RM13 7ND Rainham Essex | British | 102667300001 | ||||||
| JONES, Vanessa | Sekretär | Stables House Castle Hill RH1 4LB Bletchingley Surrey | British | 72146200001 | ||||||
| PURVIS, Martin Terence Alan | Sekretär | Fenetters Melfort Road TN6 1QT Crowborough East Sussex | British | 7901050001 | ||||||
| WALLER, Ronald John | Sekretär | Brindles 118 Hanging Hill Lane CM13 2HN Brentwood Essex | British | 1210620001 | ||||||
| WATERS, Jonathan Roy | Sekretär | Maldon Road CO3 3BQ Colchester 237 Essex | British | 129848360001 | ||||||
| ABSON, Robert | Geschäftsführer | 24 Rothamsted Avenue AL5 2DJ Harpenden Hertfordshire | British | 46707820001 | ||||||
| ALLSOP, Heather Louise | Geschäftsführer | 62 Prebend Street N1 8PS London | British | 101912850001 | ||||||
| BAIRSTOW, John | Geschäftsführer | Frieze Cottage Coxtie Green Road South Weald CM14 5RE Brentwood Essex | British | 537400001 | ||||||
| BARKER, Leslie Charles Sidney | Geschäftsführer | 15 Waltham Way CO13 9JE Frinton On Sea Essex | British | 12675060001 | ||||||
| BECKETT, Michael Ernest | Geschäftsführer | Northcroft Dulwich Common SE21 7EW London | British | 118661100001 | ||||||
| BELL, Gerald James | Geschäftsführer | Cavewood Rectory Lane Datchworth SG3 6RD Knebworth Hertfordshire | British | 47018930002 | ||||||
| BERTHOLDT, Peter Gerhard Otto | Geschäftsführer | Askells 23 Bell Lane SG12 8SH Widford Hertfordshire | British | 68457850001 | ||||||
| BUTLER, Julia | Geschäftsführer | Istarfinancial Inc 1114 Avenue Of The Americas NY 10036 New York 1114 Usa | United States | Us Citizen | 176317780001 | |||||
| CAIRNS, Michael Anthony | Geschäftsführer | Birchlands Old Avenue KT13 0PY Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 36488470001 | |||||
| CANNELL, Tavis Colm Peter | Geschäftsführer | EC4A 2BB London 133 Fleet Street England | United Kingdom | Canadian | 159374770001 | |||||
| CANNELL, Tavis Colm Peter | Geschäftsführer | Fleet Street EC4A 2BB London 133 England | United Kingdom | Canadian | 159374770001 | |||||
| CASSOU, Guillaume Pierre Marie | Geschäftsführer | Stirling Square 7 Carlton Gardens SW1Y 5AD London Kkr England | England | French | 268427940001 | |||||
| CHECOURY, Yves | Geschäftsführer | 18 Avenue Bugeaud FOREIGN 75016 Paris France | French | 114404750001 | ||||||
| COLLYER, Brian Charles | Geschäftsführer | 49 Route De Croissy 78110 Le Vesinet France | Canadian | 101144260001 | ||||||
| COPPEL, Andrew Maxwell | Geschäftsführer | Orchard House 8 Claremont Park Road KT10 9LT Esher Surrey | England | British | 14330100002 | |||||
| DE POURTALES, Jean Andre | Geschäftsführer | 55 Rowan Road W6 7DT London | British French | 101197070001 | ||||||
| DEBLIECK, Tracy | Geschäftsführer | 17 Coulson Street SW3 3NB London | United States | 101371750001 | ||||||
| DEMIRKIRAN, Banu | Geschäftsführer | Fleet Street EC4A 2BB London 133 England | England | Turkish | 160090070001 | |||||
| DIMITROV, Nathalie Lydia Julia | Geschäftsführer | 12 Torrington Gardens N11 2AB London | British / French | 108884300001 | ||||||
| DIMITROV, Nathalie Lydia Julia | Geschäftsführer | 12 Torrington Gardens N11 2AB London | British / French | 108884300001 | ||||||
| EAREY, Eric Raymond | Geschäftsführer | Little Bushfield Huttongate CM13 2XA Shenfield Essex | British | 4560400003 | ||||||
| FURTH, Michael Martin | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International England | Irish | 137419240002 | ||||||
| GALE, John | Geschäftsführer | Tudor House The Green Navestock Side CM14 5SD Brentwood Essex | British | 13560160001 | ||||||
| GLASGOW, Andrew John | Geschäftsführer | Slough Farm Thaxted Road, Debden CB11 3LS Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 63416780004 | |||||
| GOULDING, Merrill Graham | Geschäftsführer | Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International England | United Kingdom | British | 187433150001 | |||||
| HART, Maurice George | Geschäftsführer | Coney Green Littlewick Green SL6 3RA Maidenhead Berk | British | 6582660001 | ||||||
| HERSEY, David Michael | Geschäftsführer | Greenways Ridgeway Hutton Mount CM13 2LS Brentwood Essex | British | 17567250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei QMH LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Henry Kravis | 06. Apr. 2016 | 9 West 57th St, Suite 4200 10019 New York Kohlberg Kravis Roberts And Co Lp United States | Nein | ||||||||||
Nationalität: American Staatsangehörigkeit: United States | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr George Rosenberg Roberts | 06. Apr. 2016 | 9 West 57th St, Suite 4200 10019 New York Kohlberg Kravis Roberts And Co Lp United States | Nein | ||||||||||
Nationalität: American Staatsangehörigkeit: United States | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Elq Investors Limited | 06. Apr. 2016 | 133 Fleet Street EC2A 2BB London Peterborough Court Germany | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat QMH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 22. Feb. 2011 Geliefert am 02. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (For details of properties charged please refer to form MG01) fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 23. Feb. 2005 Geliefert am 04. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over bank account | Erstellt am 14. Jan. 2005 Geliefert am 04. Feb. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in the charged accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Nov. 2004 Geliefert am 14. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 24. Nov. 2004 Geliefert am 13. Dez. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights title and interest in and to the collateral meaning the assigned contractual interest, any derivative asset and any other property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juni 2004 Geliefert am 25. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over retention accounts | Erstellt am 08. Juni 2004 Geliefert am 11. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Each of the euro deposit and the sterling deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed to the composite guarantee and debenture | Erstellt am 08. Juni 2004 Geliefert am 11. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Seventh supplemental trust deed | Erstellt am 08. Juni 2004 Geliefert am 08. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the stockholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right title and intrest in and to all sums from time to time standing to the credit of the bank accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 25. März 2004 Geliefert am 26. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement | Erstellt am 18. Mai 1995 Geliefert am 31. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a guarantee dated 14/10/91 a facility agreement and the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed charge all such rights to the payment of the deposits as the company may have under the terms upon which the deposits were made and the provisions contained in the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter | Erstellt am 04. Aug. 1994 Geliefert am 23. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The difference (as defined) and all fees and disbursements of external legal or accounting advisers in france and england incurred by credit lyonnais in connection with the preparation execution or enforcement of the letter and the acte de cession de creances professionelles entered into by the company in favour of the bank on 9TH february 1994 as amended by an avenant to that acte de cession entered into by the company in favour of the bank on 4TH august 1994 | |
Kurze Angaben The loans and the recoveries as defined. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Act of assignment of professional debts | Erstellt am 04. Aug. 1994 Geliefert am 23. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The present and future obligations of the company to credit lyonais under the terms of an unconfirmed credit line in an amount of french francs 15,893,582.58 granted pursuant to a letter dated 8TH november 1993 and a loan facility dated 9TH february 1994 in an amount of french francs 11,588,331 | |
Kurze Angaben The assignment debt and its accessories being the pledge over the shares in sci les closeaux rungis dated 27TH july 1993 as amended by an amendment agreement dated 9TH february 1994. the assigned debt is defined in the bordereau to mean the debt in total amount of french francs 30,000,000 in principal which is owed to the company by francilienne de developpement sarl by virtue of three credit facilities dated 27TH july 1993,14 january 1994 and 9 february. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Act of assignment of professional debts | Erstellt am 04. Aug. 1994 Geliefert am 23. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The present and future obligations of the company to credit lyonais under the terms of an unconfirmed credit line in an amount of french francs 15,893,582.58 granted pursuant to a letter dated 8TH november 1993 and a loan facility dated 9TH february 1994 in an amount of french francs 11,588,331 | |
Kurze Angaben The assigned debt and its accessories being the pledge over the shares in sci les closeaux rungis constituted by an amendment agreement no 2 dated 4TH august 1994 to the share pledge agreement dated 27TH july 1993. the assigned debt in total amount of french francs 20,000,000 in principal which is owed to the company by francilienne de developpement sarl by virtue of a credit facility dated 4TH august 1994. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 27. Juni 1994 Geliefert am 11. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All debts and liabilities due from the company to the chargee in respect of the facility letter dated 8TH november 1993 | |
Kurze Angaben All the rights, title and interest of the company and to the "assigned rights" defined in a deed of assignment dated 10/11/93. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter | Erstellt am 09. Feb. 1994 Geliefert am 22. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The obligations of the company to pay "the difference"(as defined in the letter) and all fees and disbursements to the chargee | |
Kurze Angaben The loans and recoveries (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Act of assignment of professional debts | Erstellt am 09. Feb. 1994 Geliefert am 22. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The present and future obligations of the company to the chargee under the terms of an unconfirmed credit line in an amount of ff 15,881,224.51 granted pursuant to a letter dated 8TH november 1993 | |
Kurze Angaben The assigned debt & its accessories being the pledge over the shares in sci les closeaux rungis dated 27/7/93 as amended by an agreement dated 9/2/94. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 09. Feb. 1994 Geliefert am 22. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in respect of the uncommitted treasury line in the amount of ff 11,588,331 pursuant to the terms of a facility letter dated 9TH february 1994 | |
Kurze Angaben All rights title & interest in & to the assigned rights refer to reverse of form 395 for full definitions. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third supplemental trust deed | Erstellt am 10. Dez. 1991 Geliefert am 10. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £95,000,000 10 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2020 of queens moat houses P.L.C. (the "new stock") and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the trust deeds as defined therein | |
Kurze Angaben The sum of £10 standing to the credit of account number 27587452 and all other sums (see doc ref M741C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Sept. 1980 Geliefert am 18. Sept. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property known as the airport hotel, suithend title no:- ex 162036. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Sept. 1980 Geliefert am 18. Sept. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property known as the historic aircraft museum, southend title no:- ex 162035. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 21. Juli 1978 Geliefert am 03. Aug. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or moat house (cateress) LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben L/H property known as st george & droyon, wargmore berkshire and land and building adjacent to the grey hand public house, high street wargmore foresaid.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Apr. 1974 Geliefert am 10. Apr. 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 52, shevon way, brentwood essex, title no ex 104364. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0