HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED

HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00418328
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?

    • Vermietung und Leasing von anderen Maschinen, Geräten und Sachanlagen n.a. (77390) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SAMUEL MONTAGU LEASING SERVICES LIMITED12. Aug. 198212. Aug. 1982
    CENTRAL AMERICAN INVESTMENT CO. LIMITED29. Aug. 194629. Aug. 1946

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Kapitalaufstellung am 26. Sept. 2016

    • Kapital: GBP 2,000
    3 SeitenSH19

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Robin Louis Henning Bencard als Geschäftsführer am 01. Aug. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Simon Einar Long als Direktor am 15. März 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David John Cavanna als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Michael Connelly Anderson als Direktor am 16. Dez. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 02. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 150,000
    SH01

    Verschiedenes

    Section 519.
    1 SeitenMISC

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    20 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Ernennung von Ms Romana Lewis als Sekretär am 06. Juli 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 06. Juli 2015

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Tony Bhambhra als Sekretär am 05. Jan. 2015

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 05. Jan. 2015

    2 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 150,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Naresh Manjanath als Geschäftsführer am 11. Sept. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    21 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Katherine Dean als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Tony Bhambhra als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Wer sind die Geschäftsführer von HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Sekretär
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    199208930001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Sekretär
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square, 41st Floor
    Canary Wharf
    London, Greater London E145hq
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square, 41st Floor
    Canary Wharf
    London, Greater London E145hq
    8
    United Kingdom
    184080800001
    BLACK, Nicola Suzanne
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Sekretär
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British52160130002
    BRYANT, Shaun Kevin
    22 Searle Way
    Eight Ash Green
    CO6 3QS Colchester
    Essex
    Sekretär
    22 Searle Way
    Eight Ash Green
    CO6 3QS Colchester
    Essex
    British38944420002
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180090820001
    GARNHAM, Vanessa Indira
    15 Galveston Road
    Putney
    SW15 2RZ London
    Sekretär
    15 Galveston Road
    Putney
    SW15 2RZ London
    British30058370001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Sekretär
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    HOBLEY, Elizabeth Anne
    12 Spice Court
    Asher Way Wapping
    E1W 2JD London
    Sekretär
    12 Spice Court
    Asher Way Wapping
    E1W 2JD London
    British85623090001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Sekretär
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Sekretär
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    28 Carey Road
    Moordown
    BH9 2XB Bournemouth
    Dorset
    Sekretär
    28 Carey Road
    Moordown
    BH9 2XB Bournemouth
    Dorset
    British26776940001
    POOLE, Rebecca Louise
    69b Replingham Road
    Southfields
    SW18 5LU Wimbledon
    Sekretär
    69b Replingham Road
    Southfields
    SW18 5LU Wimbledon
    British92013940001
    QUIN, Richard William
    Bridge House 57 Chipping Hill
    CM8 2JT Witham
    Essex
    Sekretär
    Bridge House 57 Chipping Hill
    CM8 2JT Witham
    Essex
    Irish2887010001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194214450001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154950800001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    165563740001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    BOTHAM, Trevor Julian Worthington
    10 Vanbrugh Fields
    SE3 7TZ London
    Geschäftsführer
    10 Vanbrugh Fields
    SE3 7TZ London
    United KingdomBritish141223590001
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Geschäftsführer
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    FLEMING, Maria Therese
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomIrish148275470001
    GODFREY, Kevin Joseph
    7 Windsor Walk
    KT13 9AP Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Windsor Walk
    KT13 9AP Weybridge
    Surrey
    Irish34130580002
    GODFREY, Kevin Joseph
    7 Windsor Walk
    KT13 9AP Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Windsor Walk
    KT13 9AP Weybridge
    Surrey
    Irish34130580002
    HANSFORD, James Victor
    24b Old Farm Road
    Darien
    Connecticut
    06820
    Usa
    Geschäftsführer
    24b Old Farm Road
    Darien
    Connecticut
    06820
    Usa
    UsaBritish105682320001
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Geschäftsführer
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    MANJANATH, Naresh
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish123167790002
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MOLLOY, Marcus Peter John
    B504 The Jam Factory
    27 Green Walk
    SE1 4TX London
    Geschäftsführer
    B504 The Jam Factory
    27 Green Walk
    SE1 4TX London
    EnglandIrish95286610002
    MURPHY, Christopher John
    3 Craigweil Avenue
    WD7 7ES Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    3 Craigweil Avenue
    WD7 7ES Radlett
    Hertfordshire
    British55612820001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    26. Okt. 2016
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer14259
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A first priority norwegian mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 2004
    Geliefert am 20. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (sub lessee) or to the sub-lessee`s account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the companys right title and interest in and to the mortgage over the norwegian registered vessel M.V. jo acer (ex hull 351 at kitanihon shipbuilding co, LTD) dated 1 april 2004 and granted by blaf (no.9) in favour of the company.
    Berechtigte Personen
    • Hazel Shipping LTD (The Sub Lessee)
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A lessee sub-lease security assignment
    Erstellt am 01. Apr. 2004
    Geliefert am 15. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest to the lessee assigned property and all its benefits therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hazel Shipping LTD
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment of builder's warranties
    Erstellt am 01. Apr. 2004
    Geliefert am 15. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in the warranties,as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hazel Shipping LTD
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment of sub-lease and guarantee and indemnity in respect of hull no. 351
    Erstellt am 09. Juli 2003
    Geliefert am 17. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigned the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Blaf (No.9) Limited
    Transaktionen
    • 17. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A first priority norwegian mortgage
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 09. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel M.V. "jo betula" (ex hull no.337 At kitanihon shipbuilding co. LTD.) and in her equipment and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Hazel Shipping LTD. (The Sub Lessee)
    Transaktionen
    • 09. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Lessee sub-lease security assignment
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 09. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the lessee's rights, title and interest to the lessee assigned property being (a) the lessee insurances and any requisition compensation (b) the lessor assigned property (c) the lease proceeds rebate rights and (d) the lease rights and all its benefits and interest present and future therein.
    Berechtigte Personen
    • Hazel Shipping LTD
    Transaktionen
    • 09. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment of sub-lease and guarantee of indemnity
    Erstellt am 25. Juni 2003
    Geliefert am 05. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights, title and interest, present and future in, to and under the sub-lease, the guarantee and all claims, rights and remediesof the company arising out of or in connection with a breach of or a default under or in connection with any of the amounts or rights set out above and the rights to enforce the same.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Blaf (No.2) Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment of builder's warranties
    Erstellt am 25. Juni 2003
    Geliefert am 07. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The full benefit of all of the lessee's rights, title and interest in the warranties.
    Berechtigte Personen
    • Hazel Shipping LTD
    Transaktionen
    • 07. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A first priority norweigian mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 2003
    Geliefert am 20. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The norwegian registered vessel M.V. 'jo sequoia' (ex hull no. 141 at kleven floro) and all euqipment and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Hazel Shipping LTD
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    A lessee sub-lease security assignment
    Erstellt am 06. Feb. 2003
    Geliefert am 19. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The lessee's rights title and interest to the lessee assigned property and all its benefits and interests present and future therein.
    Berechtigte Personen
    • Hazel Shipping Limited
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment if builder warranties
    Erstellt am 05. Feb. 2003
    Geliefert am 25. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hazel Shipping LTD
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment of sub-lease and guarantee and indemnity
    Erstellt am 05. Feb. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights, title and interest, present and future in, to and under the sub-lease, the guarantee and all claims, rights and remediesof the company arising out of or in connection with a breach of or a default under or in connection with any of the amounts or rights set out above and the rights to enforce the same.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Blaf (No.10) Limited
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of sub-lease agreement relating to one 6,332 teu "e-type" container ship with hull no.1255 Called M.V."hatsu ethic"
    Erstellt am 07. Jan. 2003
    Geliefert am 07. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All assignor's right,title and interest in and to the sub-lease agreement and all amounts payable thereunder and all claims,rights and remedies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mcc Leasing (No.24) Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    An insurance assignment
    Erstellt am 12. Dez. 2002
    Geliefert am 23. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rights, title, benefit and interest in and to the insurances.
    Berechtigte Personen
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment of head lease agreement
    Erstellt am 12. Dez. 2002
    Geliefert am 17. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned property being all rights and interests of every kind which the assignor now or at any later time has to in or in connection with the head lease agreement and the tax side letter or in relation to any matter arising out of or in connection with the head lease agreement and the tax side letters. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hatsu Marine Limited
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment of head lease agreement
    Erstellt am 04. Juni 2002
    Geliefert am 24. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights and interest to in or in connection with the head lease agreement dated 4 june 2002 realting to the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hatsu Marine Limited
    Transaktionen
    • 24. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    An insurance assignment
    Erstellt am 04. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's rights title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hamburgische Landesbank-Girozentrale-(The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment of sub-lease agreement relating to one 6,332 teu container ship called M.V."hatsu excel"
    Erstellt am 04. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right,title and interest whatsoever under the (I) sub-lease agreement and all amounts payable thereon and (ii) all claims,rights and remedies arising out of or in connection with a breach of or default including all damages and compensation payable thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mcc Leasing (No.24) Limited
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0