HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00418328 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?
- Vermietung und Leasing von anderen Maschinen, Geräten und Sachanlagen n.a. (77390) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SAMUEL MONTAGU LEASING SERVICES LIMITED | 12. Aug. 1982 | 12. Aug. 1982 |
| CENTRAL AMERICAN INVESTMENT CO. LIMITED | 29. Aug. 1946 | 29. Aug. 1946 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. Sept. 2016
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robin Louis Henning Bencard als Geschäftsführer am 01. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Einar Long als Direktor am 15. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Cavanna als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Connelly Anderson als Direktor am 16. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Verschiedenes Section 519. | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Ernennung von Ms Romana Lewis als Sekretär am 06. Juli 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 06. Juli 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tony Bhambhra als Sekretär am 05. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 05. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Naresh Manjanath als Geschäftsführer am 11. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katherine Dean als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Tony Bhambhra als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Romana | Sekretär | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E145HQ London, Greater London 8 England England | 199208930001 | |||||||
| ANDERSON, Michael Connelly | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 269666390001 | |||||
| KENT, John Richard | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 174308200001 | |||||
| LONG, Simon Einar | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 206202590001 | |||||
| OWEN CONWAY, Gareth | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 82999960002 | |||||
| SUBRAMANIYAN, Jaya | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Malaysian | 136924480002 | |||||
| BAYER, George William | Sekretär | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| BHAMBHRA, Tony | Sekretär | Canada Square, 41st Floor Canary Wharf London, Greater London E145hq 8 United Kingdom | 184080800001 | |||||||
| BLACK, Nicola Suzanne | Sekretär | Springfield 24 Drovers Way CM23 4GF Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52160130002 | ||||||
| BRYANT, Shaun Kevin | Sekretär | 22 Searle Way Eight Ash Green CO6 3QS Colchester Essex | British | 38944420002 | ||||||
| DEAN, Katherine | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180090820001 | |||||||
| GARNHAM, Vanessa Indira | Sekretär | 15 Galveston Road Putney SW15 2RZ London | British | 30058370001 | ||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Sekretär | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| HOBLEY, Elizabeth Anne | Sekretär | 12 Spice Court Asher Way Wapping E1W 2JD London | British | 85623090001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Sekretär | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Sekretär | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Sekretär | 28 Carey Road Moordown BH9 2XB Bournemouth Dorset | British | 26776940001 | ||||||
| POOLE, Rebecca Louise | Sekretär | 69b Replingham Road Southfields SW18 5LU Wimbledon | British | 92013940001 | ||||||
| QUIN, Richard William | Sekretär | Bridge House 57 Chipping Hill CM8 2JT Witham Essex | Irish | 2887010001 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194214450001 | |||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 154950800001 | |||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 165563740001 | |||||||
| BARKER, Fiona Ann | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||
| BENCARD, Robin Louis Henning | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 46782110002 | |||||
| BOTHAM, Trevor Julian Worthington | Geschäftsführer | 10 Vanbrugh Fields SE3 7TZ London | United Kingdom | British | 141223590001 | |||||
| CAVANNA, David John | Geschäftsführer | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| FLEMING, Maria Therese | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 148275470001 | |||||
| GODFREY, Kevin Joseph | Geschäftsführer | 7 Windsor Walk KT13 9AP Weybridge Surrey | Irish | 34130580002 | ||||||
| GODFREY, Kevin Joseph | Geschäftsführer | 7 Windsor Walk KT13 9AP Weybridge Surrey | Irish | 34130580002 | ||||||
| HANSFORD, James Victor | Geschäftsführer | 24b Old Farm Road Darien Connecticut 06820 Usa | Usa | British | 105682320001 | |||||
| KENNY, Mary Bridget | Geschäftsführer | 178 Empire Square West Long Lane SE1 4NL London | United Kingdom | British | 118995490002 | |||||
| MANJANATH, Naresh | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 123167790002 | |||||
| MCKENZIE, John Hume | Geschäftsführer | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MOLLOY, Marcus Peter John | Geschäftsführer | B504 The Jam Factory 27 Green Walk SE1 4TX London | England | Irish | 95286610002 | |||||
| MURPHY, Christopher John | Geschäftsführer | 3 Craigweil Avenue WD7 7ES Radlett Hertfordshire | British | 55612820001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hsbc Bank Plc | 26. Okt. 2016 | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HSBC INTERMEDIATE LEASING (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A first priority norwegian mortgage | Erstellt am 01. Apr. 2004 Geliefert am 20. Apr. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (sub lessee) or to the sub-lessee`s account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the companys right title and interest in and to the mortgage over the norwegian registered vessel M.V. jo acer (ex hull 351 at kitanihon shipbuilding co, LTD) dated 1 april 2004 and granted by blaf (no.9) in favour of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A lessee sub-lease security assignment | Erstellt am 01. Apr. 2004 Geliefert am 15. Apr. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights title and interest to the lessee assigned property and all its benefits therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment of builder's warranties | Erstellt am 01. Apr. 2004 Geliefert am 15. Apr. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights title and interest in the warranties,as defined. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment of sub-lease and guarantee and indemnity in respect of hull no. 351 | Erstellt am 09. Juli 2003 Geliefert am 17. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigned the assigned property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A first priority norwegian mortgage | Erstellt am 30. Juni 2003 Geliefert am 09. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The vessel M.V. "jo betula" (ex hull no.337 At kitanihon shipbuilding co. LTD.) and in her equipment and appurtenances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Lessee sub-lease security assignment | Erstellt am 30. Juni 2003 Geliefert am 09. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the lessee's rights, title and interest to the lessee assigned property being (a) the lessee insurances and any requisition compensation (b) the lessor assigned property (c) the lease proceeds rebate rights and (d) the lease rights and all its benefits and interest present and future therein. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment of sub-lease and guarantee of indemnity | Erstellt am 25. Juni 2003 Geliefert am 05. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights, title and interest, present and future in, to and under the sub-lease, the guarantee and all claims, rights and remediesof the company arising out of or in connection with a breach of or a default under or in connection with any of the amounts or rights set out above and the rights to enforce the same.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment of builder's warranties | Erstellt am 25. Juni 2003 Geliefert am 07. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The full benefit of all of the lessee's rights, title and interest in the warranties. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A first priority norweigian mortgage | Erstellt am 06. Feb. 2003 Geliefert am 20. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The norwegian registered vessel M.V. 'jo sequoia' (ex hull no. 141 at kleven floro) and all euqipment and appurtenances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A lessee sub-lease security assignment | Erstellt am 06. Feb. 2003 Geliefert am 19. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The lessee's rights title and interest to the lessee assigned property and all its benefits and interests present and future therein. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment if builder warranties | Erstellt am 05. Feb. 2003 Geliefert am 25. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in the warranties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment of sub-lease and guarantee and indemnity | Erstellt am 05. Feb. 2003 Geliefert am 14. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights, title and interest, present and future in, to and under the sub-lease, the guarantee and all claims, rights and remediesof the company arising out of or in connection with a breach of or a default under or in connection with any of the amounts or rights set out above and the rights to enforce the same.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of sub-lease agreement relating to one 6,332 teu "e-type" container ship with hull no.1255 Called M.V."hatsu ethic" | Erstellt am 07. Jan. 2003 Geliefert am 07. Jan. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All assignor's right,title and interest in and to the sub-lease agreement and all amounts payable thereunder and all claims,rights and remedies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An insurance assignment | Erstellt am 12. Dez. 2002 Geliefert am 23. Dez. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The rights, title, benefit and interest in and to the insurances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment of head lease agreement | Erstellt am 12. Dez. 2002 Geliefert am 17. Dez. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assigned property being all rights and interests of every kind which the assignor now or at any later time has to in or in connection with the head lease agreement and the tax side letter or in relation to any matter arising out of or in connection with the head lease agreement and the tax side letters. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment of head lease agreement | Erstellt am 04. Juni 2002 Geliefert am 24. Juni 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights and interest to in or in connection with the head lease agreement dated 4 june 2002 realting to the ship. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An insurance assignment | Erstellt am 04. Juni 2002 Geliefert am 18. Juni 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company's rights title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An assignment of sub-lease agreement relating to one 6,332 teu container ship called M.V."hatsu excel" | Erstellt am 04. Juni 2002 Geliefert am 18. Juni 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right,title and interest whatsoever under the (I) sub-lease agreement and all amounts payable thereon and (ii) all claims,rights and remedies arising out of or in connection with a breach of or default including all damages and compensation payable thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0