BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED

BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00428073
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O INTERPATH LTD
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Fleet Place London EC4M 7QS zum 10 Fleet Place London EC4M 7RB am 01. Juli 2022

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    104 SeitenLIQ10

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL zum 10 Fleet Place London EC4M 7QS am 14. Dez. 2021

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Sept. 2021

    5 Seiten4.68

    Rücktritt eines Liquidators

    3 SeitenLIQ06

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    42 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. März 2021

    5 Seiten4.68

    Rücktritt eines Liquidators

    3 SeitenLIQ06

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    14 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Sept. 2020

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. März 2020

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Sept. 2019

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. März 2019

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Sept. 2018

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. März 2018

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Sept. 2017

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. März 2017

    5 Seiten4.68

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    30 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Sept. 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. März 2016

    5 Seiten4.68

    Wer sind die Geschäftsführer von BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOLAN, Malcolm George
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    British73207060001
    KIMBERLEY, Howard Fraser
    7 Harbour Building
    Waterfront West Dudley Road
    DY5 1LN Brierley Hill
    West Midlands
    Geschäftsführer
    7 Harbour Building
    Waterfront West Dudley Road
    DY5 1LN Brierley Hill
    West Midlands
    EnglandBritish75325410002
    KIMBERLEY, Howard Fraser
    8 Lyttelton Road
    WR9 7AA Droitwich Spa
    Worcestershire
    Sekretär
    8 Lyttelton Road
    WR9 7AA Droitwich Spa
    Worcestershire
    British75325410002
    SMAILES, Thomas Frederick Kenyon
    7 Cromedale Crescent
    Standish
    WN6 0BS Wigan
    Lancashire
    Sekretär
    7 Cromedale Crescent
    Standish
    WN6 0BS Wigan
    Lancashire
    British19681540001
    WELCH, John Reginald
    22 Balmoral Road
    Kingshurst
    B36 0JT Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    22 Balmoral Road
    Kingshurst
    B36 0JT Birmingham
    West Midlands
    British2243210001
    ABBEY, Mark Antony
    Elm Home
    69 Jubilee Road, Walmer Bridge
    PR4 5QW Preston
    Geschäftsführer
    Elm Home
    69 Jubilee Road, Walmer Bridge
    PR4 5QW Preston
    EnglandBritish60758320003
    ASPEY, David
    1 Claughton Avenue
    Clayton Le Woods Leyland
    PR5 2TJ Leyland
    Lancashire
    Geschäftsführer
    1 Claughton Avenue
    Clayton Le Woods Leyland
    PR5 2TJ Leyland
    Lancashire
    British44793750001
    BROOKS, Ronald Anthony
    18 Archer Avenue
    BL2 2SJ Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    18 Archer Avenue
    BL2 2SJ Bolton
    Lancashire
    British70076470001
    CHADWICK, Anthony
    7 Barnfield Drive
    Westhoughton
    BL5 3UA Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Barnfield Drive
    Westhoughton
    BL5 3UA Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish66511750001
    CUTLER, John Leslie
    4 Claverdon Drive
    B74 3AH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    4 Claverdon Drive
    B74 3AH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British1454360001
    DAVIES, Christopher Erith
    Hollytree The Common
    Wellington Heath
    HR8 1LY Ledbury
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Hollytree The Common
    Wellington Heath
    HR8 1LY Ledbury
    Herefordshire
    British48167130002
    DIGGLES, Stuart Richard
    18 Rushton Close
    Burtonwood
    WA5 4HB Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    18 Rushton Close
    Burtonwood
    WA5 4HB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish82993900003
    FOSTER, Thomas Henry
    25 Laburnum Park
    Bradshaw
    BL2 3BX Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    25 Laburnum Park
    Bradshaw
    BL2 3BX Bolton
    Lancashire
    English2328780001
    GASH, Michael Alfred
    54 Richmond Hill Road
    Edgbaston
    B15 3AZ Birmingham
    Geschäftsführer
    54 Richmond Hill Road
    Edgbaston
    B15 3AZ Birmingham
    British6255580001
    RAJAH, Sheela
    5 Victory Way
    DN34 5UY Grimsby
    North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    5 Victory Way
    DN34 5UY Grimsby
    North East Lincolnshire
    Malaysian78910840001
    SCRIVEN, Jeremy Mark Richard
    8 Birch Close
    CH43 5XE Prenton
    Merseyside
    Geschäftsführer
    8 Birch Close
    CH43 5XE Prenton
    Merseyside
    British71442440001
    SMAILES, Thomas Frederick Kenyon
    7 Cromedale Crescent
    Standish
    WN6 0BS Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Cromedale Crescent
    Standish
    WN6 0BS Wigan
    Lancashire
    British19681540001
    TORPEY, Norman Noel
    23 Pilgrims Way
    Standish
    WN6 0AJ Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    23 Pilgrims Way
    Standish
    WN6 0AJ Wigan
    Lancashire
    British65046550003
    WALKER, Ian Rodway
    Silverdale Quarry Park Road
    Pedmore
    DY8 2RE Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Silverdale Quarry Park Road
    Pedmore
    DY8 2RE Stourbridge
    West Midlands
    British1454400001
    WARD, Kim Stephen
    3 Beauchamp Gardens
    Myton Lane
    CV34 6QG Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    3 Beauchamp Gardens
    Myton Lane
    CV34 6QG Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish71325320006
    WAY, Raymond Brinsley Mallen
    Pinners
    Astley
    DY13 0RJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Pinners
    Astley
    DY13 0RJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritish14538110001

    Hat BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2005
    Geliefert am 22. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge all plant machinery vehicles computers office and other equipment all bank accounts receivables investments intellectual property goodwill uncalled capital floating charge undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Nov. 2004
    Geliefert am 03. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 12. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 11. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 07. März 1991
    Geliefert am 27. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 13. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Nov. 1990
    Geliefert am 29. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 03. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 06. Nov. 1986
    Geliefert am 26. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    • 03. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Juli 1982
    Geliefert am 23. Juli 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed dated 7/4/71 and further deed.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Juli 1982Registrierung einer Belastung
    • 03. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 18. Apr. 1975
    Geliefert am 25. Apr. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed dated 7/4/71 and further deed.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1975Registrierung einer Belastung
    • 03. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 07. Apr. 1971
    Geliefert am 19. Apr. 1971
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the 11 other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and goodwill present and future including uncalled capital. Fixed & floating charges (see doc 48).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1971Registrierung einer Belastung
    • 03. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Feb. 1966
    Geliefert am 16. Feb. 1966
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and goodwill present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1966Registrierung einer Belastung
    • 03. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Feb. 1960
    Geliefert am 17. Feb. 1960
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due etc
    Kurze Angaben
    Undertaking and goodwill & all property including uncalled capital present and future.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1960Registrierung einer Belastung
    • 03. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. März 2010Beginn der Liquidation
    15. Okt. 2022Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    David John Pike
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0