FINNEYS SEEDS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFINNEYS SEEDS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00428887
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FINNEYS SEEDS LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich FINNEYS SEEDS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FINNEYS SEEDS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis26. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für FINNEYS SEEDS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 28. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Capital redemption reserve reduced 21/09/2011
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. März 2010

    11 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Prentis als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Charles Wilson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Laura Taylor als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mark Chilton als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Laura Taylor als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. März 2009

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    11 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Jonathan Paul Prentis am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mark Chilton am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    legacy

    9 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. März 2008

    11 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. März 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von FINNEYS SEEDS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TAYLOR, Laura
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    Sekretär
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    155913700001
    TAYLOR, Laura
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    United KingdomBritish155913200001
    ALEXANDER, Keith David Rennie
    3 West Terrace
    High Street
    TN17 3LG Cranbrook
    Kent
    Sekretär
    3 West Terrace
    High Street
    TN17 3LG Cranbrook
    Kent
    British35984770001
    ATTWOOD, Paul Gerard
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    Sekretär
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    British72538660001
    BELTON, Doris Valerie
    49 Drayton Road
    Irthlingborough
    NN9 5TA Wellingborough
    Northamptonshire
    Sekretär
    49 Drayton Road
    Irthlingborough
    NN9 5TA Wellingborough
    Northamptonshire
    British67694030001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    Sekretär
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    British78255980001
    CHILTON, Mark
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    Sekretär
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    British109675640001
    JOHNSON, Shirley Elizabeth
    25 Stoney Common
    CM24 8NF Stansted
    Essex
    Sekretär
    25 Stoney Common
    CM24 8NF Stansted
    Essex
    British52701320001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Sekretär
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    British48949090001
    ALEXANDER, Keith David Rennie
    3 West Terrace
    High Street
    TN17 3LG Cranbrook
    Kent
    Geschäftsführer
    3 West Terrace
    High Street
    TN17 3LG Cranbrook
    Kent
    British35984770001
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Geschäftsführer
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    WalesBritish10711650001
    CAMP, Michael James
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritish12204760003
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    United KingdomBritish135246350001
    GLEW, Steven Peter
    22 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NZ Welwyn
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    22 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NZ Welwyn
    Hertfordshire
    British88254510001
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    HUDSON, Philip John
    25 Bennett Drive
    CV34 6QJ Warwick
    Geschäftsführer
    25 Bennett Drive
    CV34 6QJ Warwick
    British47142130001
    HUSTAD, Hans Kristian
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Geschäftsführer
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Norwegian103594230001
    KERSLAKE, Rosaleen Clare
    Little Manor House
    Guildford Road
    RH4 3NJ Westcott
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Manor House
    Guildford Road
    RH4 3NJ Westcott
    Surrey
    EnglandBritish294886590001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    United KingdomBritish48949090001
    ROBINSON, Edward Christopher
    142 Burbage Road
    SE21 7AG London
    Geschäftsführer
    142 Burbage Road
    SE21 7AG London
    EnglandBritish12210001
    WILSON, Charles
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northants
    Geschäftsführer
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northants
    United KingdomBritish123998480001

    Hat FINNEYS SEEDS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 15. Dez. 1980
    Geliefert am 24. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from finney lock seeds limited to the chargee.
    Kurze Angaben
    F/H 1 factory, thorpe arch trading estate, thorp arch, wetherby, yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all of any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital with all buildings fixtures fixed plant & machinery (see doc for fuller details).
    Berechtigte Personen
    • Brown Shipley & Co LTD.
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all of any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital with all buildings fixtures fixed plant & machinery (see doc for fuller details).
    Berechtigte Personen
    • Henry Ansbacher & Co. LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all of any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital with all buildings fixtures fixed plant & machinery (see doc for fuller details).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Composite gurantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or of any of the other companies named therein
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital, with all buildings fixtures fixed plant & machinery (see doc for fuller details).
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank LTD.
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all of any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital. With all buildings fixtures fixed plant & machinery (see doc for fuller details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein. To the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital. With all buildings fixturres fixed plant & machinery (see docs for full details).
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank LTD.
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0