TRACTAMOTOR SERVICES LIMITED

TRACTAMOTOR SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRACTAMOTOR SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00428963
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRACTAMOTOR SERVICES LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich TRACTAMOTOR SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    26 Park Road
    LE13 1TT Melton Mowbray
    Leicestershire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRACTAMOTOR SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRACTAMOTOR SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    5 SeitenAA

    Kapitalaufstellung am 21. Sept. 2017

    • Kapital: GBP 1.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 29/08/2017
    RES13

    Erfüllung der Belastung 27 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 22. Juni 2016

    • Kapital: GBP 1,015
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    9 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Elaine Barbara Hack als Geschäftsführer am 27. Nov. 2015

    1 SeitenTM01

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 01. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 1,015
    4 SeitenSH06

    Eigenkapitalrückkauf.

    3 SeitenSH03

    Erfüllung der Belastung 25 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 26 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 23. Juni 2015

    • Kapital: GBP 2,516
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs. Susan Beverly O'connor am 14. Juli 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Peter Hugh O'connor am 14. Juli 2014

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Hugh O'connor am 14. Juli 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    9 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mrs. Susan Beverly O'connor am 16. Juni 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 17. Juni 2014

    • Kapital: GBP 2,516
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von TRACTAMOTOR SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    O'CONNOR, Peter Hugh
    9a High Street
    Waltham On The Wolds
    LE14 4AH Melton Mowbray
    The Old Stables
    Leicestershire
    United Kingdom
    Sekretär
    9a High Street
    Waltham On The Wolds
    LE14 4AH Melton Mowbray
    The Old Stables
    Leicestershire
    United Kingdom
    179320850001
    O'CONNOR, Peter Hugh
    LE13 1TT Melton Mowbray
    26 Park Road
    Leicestershire
    England
    Geschäftsführer
    LE13 1TT Melton Mowbray
    26 Park Road
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish25590500002
    O'CONNOR, Susan Beverley
    LE13 1TT Melton Mowbray
    26 Park Road
    Leicestershire
    England
    Geschäftsführer
    LE13 1TT Melton Mowbray
    26 Park Road
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish8949420003
    CRAIG, Michael John
    1 Lyndale Drive
    DE5 9QJ Codnor
    Derbyshire
    Sekretär
    1 Lyndale Drive
    DE5 9QJ Codnor
    Derbyshire
    British84642730001
    CRAIG, Michael John
    1 Lyndale Drive
    DE5 9QJ Codnor
    Derbyshire
    Sekretär
    1 Lyndale Drive
    DE5 9QJ Codnor
    Derbyshire
    British84642730001
    HACK, Kathleen Ida
    The Cedars
    Frisby On The Wreake
    LE14 2NP Melton Mowbray
    Leicestershire
    Sekretär
    The Cedars
    Frisby On The Wreake
    LE14 2NP Melton Mowbray
    Leicestershire
    British11345400001
    JONES, Glenys Elizabeth, Dr
    Scotland Hill Farm
    Costock Road, Wysall
    NG12 5QT Nottingham
    The Barns
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Scotland Hill Farm
    Costock Road, Wysall
    NG12 5QT Nottingham
    The Barns
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    British137120180001
    O'CONNOR, Susan Beverly, Mrs.
    Stone Villa 96 High Street
    Somerby
    LE14 2QB Melton Mowbray
    Leicestershire
    Sekretär
    Stone Villa 96 High Street
    Somerby
    LE14 2QB Melton Mowbray
    Leicestershire
    British8949420002
    BADDELEY, David John
    11 Brook Street
    Burton On The Wolds
    LE12 5AB Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    11 Brook Street
    Burton On The Wolds
    LE12 5AB Loughborough
    Leicestershire
    British11345430001
    FABRIS, Michael Edgell
    5c Brook Street
    Rearsby
    LE7 4YA Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    5c Brook Street
    Rearsby
    LE7 4YA Melton Mowbray
    Leicestershire
    British44492120001
    HACK, Cyril Alan
    Chiswell Barn
    Sherden Lane Marsh Green
    TN8 5PR Edenbridge
    Geschäftsführer
    Chiswell Barn
    Sherden Lane Marsh Green
    TN8 5PR Edenbridge
    EnglandBritish8244200003
    HACK, Elaine Barbara
    LE13 1TT Melton Mowbray
    26 Park Road
    Leicestershire
    England
    Geschäftsführer
    LE13 1TT Melton Mowbray
    26 Park Road
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish137120200002
    HACK, Kathleen Ida
    The Cedars
    Frisby On The Wreake
    LE14 2NP Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Cedars
    Frisby On The Wreake
    LE14 2NP Melton Mowbray
    Leicestershire
    British11345400001
    HALLOWS, Leonard John
    Hamilton House
    68 Burton Road
    LE13 1DJ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Hamilton House
    68 Burton Road
    LE13 1DJ Melton Mowbray
    Leicestershire
    United KingdomBritish111742410001
    HOWS, George
    2 Wicklow Avenue
    LE13 1DX Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    2 Wicklow Avenue
    LE13 1DX Melton Mowbray
    Leicestershire
    British11345420001
    O'CONNOR, Peter Hugh
    Stone Villa 96 High Street
    Somerby
    LE14 2QB Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Stone Villa 96 High Street
    Somerby
    LE14 2QB Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish25590500001
    O'CONNOR, Peter Hugh
    Stone Villa 96 High Street
    Somerby
    LE14 2QB Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Stone Villa 96 High Street
    Somerby
    LE14 2QB Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish25590500001
    O'CONNOR, Susan Beverly, Mrs.
    Stone Villa 96 High Street
    Somerby
    LE14 2QB Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Stone Villa 96 High Street
    Somerby
    LE14 2QB Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish8949420002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TRACTAMOTOR SERVICES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Jagos Investments Limited
    LE13 1TT Melton Mowbray
    26 Park Road
    Leicestershire
    England
    06. Apr. 2016
    LE13 1TT Melton Mowbray
    26 Park Road
    Leicestershire
    England
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer09902125
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat TRACTAMOTOR SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. März 2010
    Geliefert am 27. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Nov. 2009
    Geliefert am 27. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    56 scalford road melton mowbray leicestershire by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 09. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juni 2005
    Geliefert am 14. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south side of leicester road melton mowbray. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 17. Mai 2002
    Geliefert am 22. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fce Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on vehicle stocks
    Erstellt am 17. Mai 2002
    Geliefert am 22. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First floating charge all new and used motor vehicles (motor vehicles) from time to time in the possession of the company or in respect of which the company is or may be entitled to exercise rights of possession ownership or otherwise in whatsoever capacity. First fixed charge all such the present and future property and assets of the company as listed in the second schedule of the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fce Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Juni 2001
    Geliefert am 05. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as unit 4 benner road industrial estate spalding lincolnshire title number LL196222. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Juni 2001
    Geliefert am 05. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land k/a the volvo centre and land and buildings on the south east side of newark road peterborough t/no: CB145719. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 23. Juni 2000
    Geliefert am 24. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of floating security all of the motor vehicle stock now and in the future belonging to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Guarantee Finance Limited
    Transaktionen
    • 24. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Feb. 1999
    Geliefert am 04. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chartered Trust PLC
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Okt. 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 13. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Juni 1995
    Geliefert am 14. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 56 scalford road melton mowbray leicestershire and land adjacent and 61 square yards situate on the east side of scalford road melton mowbray leicestershire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Juni 1995
    Geliefert am 05. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H-land lying on the south side of leicester road melton mowbray leicestershire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 26. Juni 1995
    Geliefert am 04. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Juni 1995
    Geliefert am 22. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a west side of great north road spittlegate level grantham lincolnshire t/no LL56941 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 05. Aug. 1994
    Geliefert am 12. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed and floating charge dated 15TH february 1991
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Juni 1993
    Geliefert am 25. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property on the south side of leicester road melton mowbray leicestershire tog with all fixtures other than trade. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Juni 1993
    Geliefert am 25. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 56 scalford road melton mowbray leicestershire tog with all fixtures attached to the property other than trade. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 30. Jan. 1992
    Geliefert am 12. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £34,839.20
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance please see doc M513C for details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Mai 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 18. Feb. 1991
    Geliefert am 05. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    21236-20
    Kurze Angaben
    All the companys rights title and interest in and to all sums payable under the insurance particulars whereof are set out on form M395 ref. 48C.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers. Limited
    Transaktionen
    • 05. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 12. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 15. Feb. 1991
    Geliefert am 21. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all book & other debts, floating charge on all other the:-. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 05. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 26. Juni 1978
    Geliefert am 29. Juni 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H lands and premises being old scalford melton mowbray leics. Together with all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juni 1978Registrierung einer Belastung
    • 05. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 23. März 1977
    Geliefert am 01. Apr. 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Approx 7 acres 611 square yards of land at scalford metton mowbray leicester. Together with all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1977Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 1975
    Geliefert am 06. Nov. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and premises being approx 81 acres on the east side of scalford rd.melton mowbray leics. Together with all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Nov. 1975Registrierung einer Belastung
    • 12. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 14. Okt. 1975
    Geliefert am 20. Okt. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1975Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 14. Okt. 1975
    Geliefert am 20. Feb. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises being 61 sq yrds or thereabouts situate on the east side of scalford rd. Melton mowbray leics. Together with all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1975Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Okt. 1965
    Geliefert am 12. Okt. 1965
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    13,000 andall other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land having frontage of 148 ft. To scotland rd. Melton mowbray leicestershire together with all buildings erections future pumps and tanks erected 28 bowley ave. Melton mowbray leics. The goodwill of the business.
    Berechtigte Personen
    • Total Oil Products (G.B) Limited
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1965Registrierung einer Belastung
    • 22. Apr. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0