J. DAWSON & SONS

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJ. DAWSON & SONS
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 00438289
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von J. DAWSON & SONS?

    • (1533) /

    Wo befindet sich J. DAWSON & SONS?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o NIDERA UK LTD
    15 The Havens
    Ransomes Europark
    IP3 9SJ Ipswich
    Suffolk
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J. DAWSON & SONS?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für J. DAWSON & SONS?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    18 SeitenAA

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 04. Mai 2011

    • Kapital: GBP 441.00
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2009

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2009

    14 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , the Havens Ransomes Europark, Ipswich, Suffolk, IP3 9SJ am 22. Dez. 2009

    2 SeitenAD01

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    2 Seiten403a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    7 Seiten395

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von J. DAWSON & SONS?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KERRIDGE, Nicholas Adam
    79 Belvedere Road
    IP4 4AD Ipswich
    Suffolk
    Sekretär
    79 Belvedere Road
    IP4 4AD Ipswich
    Suffolk
    British107209810001
    DORDERY, Mark Stuart
    Pond House
    Main Road Bucklesham
    IP10 0DN Ipswich
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Pond House
    Main Road Bucklesham
    IP10 0DN Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishCompany Director101914720001
    BILLARD, Trevor
    1 Webster Crescent
    Kimberworth
    S61 2BS Rotherham
    South Yorkshire
    Sekretär
    1 Webster Crescent
    Kimberworth
    S61 2BS Rotherham
    South Yorkshire
    British115878900001
    BILLINTON, Richard
    11 Lowndes Park
    YO25 5BE Driffield
    East Yorkshire
    Sekretär
    11 Lowndes Park
    YO25 5BE Driffield
    East Yorkshire
    British2674250001
    HAGSTON, Raymond Arthur
    116 Holme Road
    Market Weighton
    YO4 3EJ York
    North Yorkshire
    Sekretär
    116 Holme Road
    Market Weighton
    YO4 3EJ York
    North Yorkshire
    British20531620001
    LEWIS OGDEN, James Philip
    Oakdene
    Forge Close
    YO42 4QS Melbourne
    East Riding Of Yorkshire
    Sekretär
    Oakdene
    Forge Close
    YO42 4QS Melbourne
    East Riding Of Yorkshire
    BritishSolicitor71506990002
    NEWBY, Mark Phillip
    96 Myrtle Way
    HU15 1SR Brough
    North Humberside
    Sekretär
    96 Myrtle Way
    HU15 1SR Brough
    North Humberside
    British104771060003
    BILLINTON, Richard
    11 Lowndes Park
    YO25 5BE Driffield
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 Lowndes Park
    YO25 5BE Driffield
    East Yorkshire
    BritishCorn Merchant2674250001
    BOOTH, Philip
    130 Gott Close
    Kellythorpe
    YO25 9EZ Driffield
    North Humberside
    Geschäftsführer
    130 Gott Close
    Kellythorpe
    YO25 9EZ Driffield
    North Humberside
    BritishSales Director102722440001
    DAWSON, Charles Richard
    South Lodge
    Kilham
    YO25 0FP Driffield
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    South Lodge
    Kilham
    YO25 0FP Driffield
    East Yorkshire
    BritishCorn Merchant2719790001
    DAWSON, Simon Harold
    Rudston House
    Rudston
    YO25 4UH Driffield
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Rudston House
    Rudston
    YO25 4UH Driffield
    East Yorkshire
    EnglandBritishFarmer13321210001
    DAWSON, Susan
    South Lodge
    Kilham
    YO25 0FP Driffield
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    South Lodge
    Kilham
    YO25 0FP Driffield
    East Yorkshire
    BritishCorn Merchant20660270001
    HAGSTON, Raymond Arthur
    116 Holme Road
    Market Weighton
    YO4 3EJ York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    116 Holme Road
    Market Weighton
    YO4 3EJ York
    North Yorkshire
    BritishOffce Manager20531620001
    HARRISON, David
    7 Darley Close
    Kilham
    YO25 4UA Driffield
    North Humberside
    Geschäftsführer
    7 Darley Close
    Kilham
    YO25 4UA Driffield
    North Humberside
    EnglandBritishCorn Merchant274176720001
    LEE, Robin
    Cedrus House
    11 Bradshaw Close
    S75 2JN Barnsley
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cedrus House
    11 Bradshaw Close
    S75 2JN Barnsley
    South Yorkshire
    BritishAccountant43451530001
    NEWBY, Mark Phillip
    96 Myrtle Way
    HU15 1SR Brough
    North Humberside
    Geschäftsführer
    96 Myrtle Way
    HU15 1SR Brough
    North Humberside
    BritishAccountant104771060003
    POPPLEWELL, Michael Ian
    Croft Villa 48 Garths End
    Pocklington
    YO4 2JB York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Croft Villa 48 Garths End
    Pocklington
    YO4 2JB York
    North Yorkshire
    BritishCorn Merchant72123800001

    Hat J. DAWSON & SONS Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed & floating charge
    Erstellt am 12. Mai 2008
    Geliefert am 13. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 14. Nov. 2005
    Geliefert am 22. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 11. Juli 2003
    Geliefert am 14. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Volvo FM12 reg/id no. W428 trh, volvo FM12 reg/id no. X845 oag, corsa van reg/id no. YE02 nrx, together with any part or parts thereof and all additions alterations accessories replacements and renewals of component parts thereto, the benefit of any obligations and warranties the benefit of all maintenance agreements, for details of further chattels charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Nov. 2002
    Geliefert am 29. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Berechtigte Personen
    • Euro Sales Finance PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over contract
    Erstellt am 04. Okt. 1985
    Geliefert am 11. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that benefit made between the intervention board and the company relating to all monies now or from time to time owing to us by the intervention board for agricultural produce or any emanation thereof of successor thereto.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1985Registrierung einer Belastung
    • 10. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0