NORTH WESTERN ROAD CAR COMPANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NORTH WESTERN ROAD CAR COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00439260 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NORTH WESTERN ROAD CAR COMPANY LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich NORTH WESTERN ROAD CAR COMPANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NORTH WESTERN ROAD CAR COMPANY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BLUE BIRD SECURITIES LIMITED | 21. Juli 1947 | 21. Juli 1947 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORTH WESTERN ROAD CAR COMPANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NORTH WESTERN ROAD CAR COMPANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP am 14. Sept. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Kenneth Mcintyre Carlaw als Direktor am 28. Aug. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Paul Featham als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 26. Mai 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Nigel Paul Featham als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan May als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 30. Juli 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Paul May am 30. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Anthony Bowler am 30. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NORTH WESTERN ROAD CAR COMPANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Elizabeth Anne | Sekretär | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | British | 102907000002 | ||||||
| CARLAW, Kenneth Mcintyre | Geschäftsführer | Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 | England | British | 161250030001 | |||||
| LAUCHT, Robert Ian | Sekretär | 1 High Meadows, Church Lane Kirk Ella HU10 7NJ Hull East Riding Yorkshire | British | 13774020001 | ||||||
| RICHARDS, Lewis | Sekretär | 16 Dove House Lane B91 2EX Solihull West Midlands | British | 2452070001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Sekretär | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| WATSON, Kenneth James | Sekretär | 1 Portsmouth Place DL1 2XH Darlington County Durham | British | 29509590001 | ||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | United Kingdom | British | 35116070001 | |||||
| FEATHAM, Nigel Paul | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | England | British | 161124990001 | |||||
| GRACE, David | Geschäftsführer | Wood House Back Lane Horbury WF4 2JJ Wakefield West Yorkshire | British | 27031320004 | ||||||
| HIND, Robert Andrew | Geschäftsführer | 18 Maplewell Road Woodhouse Eaves LE12 8QZ Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 21961900002 | |||||
| HODGSON, Gordon William | Geschäftsführer | Bramble House Easington Lane DH5 0QX Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | 1108360001 | ||||||
| HODGSON, Kenneth | Geschäftsführer | The Grange Church Lane Elvington YO41 4HD York | United Kingdom | British | 9946200002 | |||||
| HUNTER, Michael John | Geschäftsführer | 100 Manygates Lane Sandal WF2 7DP Wakefield West Yorkshire | British | 1058260002 | ||||||
| KERSLAKE, Brian John | Geschäftsführer | Oaklands Coppenhall ST18 9BW Stafford Staffordshire | British | 34169610003 | ||||||
| LAUCHT, Robert Ian | Geschäftsführer | 1 High Meadows, Church Lane Kirk Ella HU10 7NJ Hull East Riding Yorkshire | United Kingdom | British | 13774020001 | |||||
| LEEDER, David John | Geschäftsführer | 3 Juniper House 140 Narrow Street E14 8BP London | England | British | 110562870001 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Geschäftsführer | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MAY, Jonathan Paul | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | United Kingdom | British | 125675730002 | |||||
| RAY, John Alfred | Geschäftsführer | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | 58415290001 | ||||||
| STONE, Philip Martin | Geschäftsführer | 21 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | 69200640003 | |||||
| STONE, Philip Martin | Geschäftsführer | 21 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | 69200640003 | |||||
| WHITE, Philip Michael | Geschäftsführer | 25 Viceroy Close Bristol Road B5 7UR Birmingham West Midlands | British | 5721830002 | ||||||
| WOOLNER, Andrew Edward | Geschäftsführer | Green Farm Back Lane Shustoke B46 2AP Coleshill Warwickshire | British | 45409730001 |
Hat NORTH WESTERN ROAD CAR COMPANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 1995 Geliefert am 10. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Nov. 1993 Geliefert am 17. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 28. Juli 1988 Geliefert am 05. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee debenture | Erstellt am 31. Juli 1987 Geliefert am 10. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 25. Nov. 1985 Geliefert am 16. Dez. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Okt. 1984 Geliefert am 09. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Jan. 1984 Geliefert am 13. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat NORTH WESTERN ROAD CAR COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0