FAIRBAIRN U.K. LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFAIRBAIRN U.K. LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00447698
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FAIRBAIRN U.K. LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich FAIRBAIRN U.K. LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5th Floor Millennium Bridge House 2
    Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FAIRBAIRN U.K. LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OMFS COMPANY 1 LIMITED29. Apr. 200329. Apr. 2003
    GERRARD & KING LIMITED06. Jan. 199706. Jan. 1997
    GERRARD & NATIONAL LIMITED31. Dez. 198131. Dez. 1981
    GERRARD & NATIONAL DISCOUNT COMPANY LIMITED08. Jan. 194808. Jan. 1948

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FAIRBAIRN U.K. LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für FAIRBAIRN U.K. LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Cessation of Omfs (Ggp) Limited as a person with significant control on 15. Sept. 2017

    2 SeitenPSC07

    Notification of Om Seed Investments (Uk) Limited as a person with significant control on 15. Sept. 2017

    4 SeitenPSC02

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    5 SeitenMR04

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 16. Mai 2017

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    9 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Martin Charles Murray als Geschäftsführer am 26. Mai 2016

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Colin Robert Campbell als Direktor am 27. Mai 2016

    3 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    17 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 23. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    16 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 14. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Martin Charles Murray am 01. Okt. 2014

    3 SeitenCH01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 13. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Cancel share prem a/c 30/07/2014
    RES13

    Verschiedenes

    Section 519
    2 SeitenMISC

    Verschiedenes

    Section 519
    2 SeitenMISC

    Wer sind die Geschäftsführer von FAIRBAIRN U.K. LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FORSYTHE, Paul
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    United Kingdom
    Sekretär
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    United Kingdom
    British112400030002
    CAMPBELL, Colin Robert
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish209094790001
    COXON, Robert Harold
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomAustralian65171530001
    PEARCE, Iain Anthony
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    United Kingdom
    EnglandBritish168163420001
    TELFER, Miranda Lauraine
    Lingfield House
    East Grinstead
    RH7 6ES Lingfield
    Sekretär
    Lingfield House
    East Grinstead
    RH7 6ES Lingfield
    British80083220001
    WALLIS, Nicholas Charles
    35 Woodstock Road North
    AL1 4QD St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    35 Woodstock Road North
    AL1 4QD St Albans
    Hertfordshire
    British4190770001
    WALLIS, Nicholas Charles
    35 Woodstock Road North
    AL1 4QD St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    35 Woodstock Road North
    AL1 4QD St Albans
    Hertfordshire
    British4190770001
    WARR, Mark Robert
    Flat 17, Yew Tree House
    19-23 Hook Road
    KT6 5AA Surbiton
    Surrey
    Sekretär
    Flat 17, Yew Tree House
    19-23 Hook Road
    KT6 5AA Surbiton
    Surrey
    British68147240001
    ZENTNER, Laurence
    6 Wyatt Road
    N5 2JU London
    Sekretär
    6 Wyatt Road
    N5 2JU London
    British43891140001
    ABSALOM, David
    6 Westfield
    Raglan Road
    RH2 0DZ Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Westfield
    Raglan Road
    RH2 0DZ Reigate
    Surrey
    British44013110001
    ANSTEE, Eric Edward
    Whitethorns
    Weydown Road
    GU27 1DS Haslemere
    Surrey
    Geschäftsführer
    Whitethorns
    Weydown Road
    GU27 1DS Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish76479900001
    ASKEW, Henry John
    77 Chester Row
    SW1W 8JL London
    Geschäftsführer
    77 Chester Row
    SW1W 8JL London
    British530770001
    AVEY, Nigel Anthony Bruce
    34 Kendal Avenue
    CM16 4PR Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    34 Kendal Avenue
    CM16 4PR Epping
    Essex
    British46157050001
    BAILES, Raymond Gene
    36 Greenheys Drive
    E18 2HB South Woodford
    London
    Geschäftsführer
    36 Greenheys Drive
    E18 2HB South Woodford
    London
    British57688100001
    BEEVOR, Anthony Romer
    20 Radipole Road
    SW6 5DL London
    Geschäftsführer
    20 Radipole Road
    SW6 5DL London
    EnglandBritish14269200002
    BOULTON, Paul
    17 Springfields
    EN10 7LX Broxbourne
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    17 Springfields
    EN10 7LX Broxbourne
    Hertfordshire
    British38532730001
    BRAYSHAW, David Arthur
    25 Avenue Road
    CM23 5NT Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    25 Avenue Road
    CM23 5NT Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish119697400001
    BREISLIN, Richard John Henry
    9 Blackthorn Close
    AL4 9RP St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    9 Blackthorn Close
    AL4 9RP St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish167444170001
    BROOKS, Mark Allan
    81 Eastbury Road
    BR5 1JW Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    81 Eastbury Road
    BR5 1JW Orpington
    Kent
    British44013180001
    DAVIES, Mark Edward Trehearne
    26 Chester Street
    SW1X 7BL London
    Geschäftsführer
    26 Chester Street
    SW1X 7BL London
    EnglandBritish82536300001
    DAVIES, Stephen Arthur James
    Iverwood
    43 Oatlands Chase
    KT13 9RP Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Iverwood
    43 Oatlands Chase
    KT13 9RP Weybridge
    Surrey
    British73623020001
    DUGDALE, David John
    Icomb Bank
    Icomb
    GL54 1JD Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Icomb Bank
    Icomb
    GL54 1JD Cheltenham
    Gloucestershire
    British98118020001
    ELKINGTON, Robert John
    Cranbourne Grange
    Sutton Scotney
    SO21 3NA Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Cranbourne Grange
    Sutton Scotney
    SO21 3NA Winchester
    Hampshire
    British3175220001
    FELLOWES, Thomas William
    The Old Rectory
    Barking
    IP6 8HH Ipswich
    Suffolk
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Barking
    IP6 8HH Ipswich
    Suffolk
    British9854990001
    FRANKLIN, David
    85 Hawkwell Chase
    SS5 4NE Hawkwell
    Essex
    Geschäftsführer
    85 Hawkwell Chase
    SS5 4NE Hawkwell
    Essex
    British52439310001
    GEIGER, Christoph
    The White House
    Ottershaw Park Mansions
    KT16 0QS Chertsey
    Surrey
    Geschäftsführer
    The White House
    Ottershaw Park Mansions
    KT16 0QS Chertsey
    Surrey
    Swiss36738220001
    HARRIS, Rosemary
    The Mount
    GU2 4JB Guildford
    74
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Mount
    GU2 4JB Guildford
    74
    Surrey
    EnglandBritish228468970001
    HOPE, Donald Ian
    92 Copse Hill
    SW20 0NN London
    Geschäftsführer
    92 Copse Hill
    SW20 0NN London
    United KingdomUk And New Zealand65171640001
    JONES, Andrew Stewart Ross
    Church Road
    PE28 0PA Catworth
    Glebe House
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Church Road
    PE28 0PA Catworth
    Glebe House
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish136052260001
    KENT, John Christian William
    48 Stradella Road
    Dulwich
    SE24 9HA London
    Geschäftsführer
    48 Stradella Road
    Dulwich
    SE24 9HA London
    United KingdomBritish79544930001
    LENTON, John Michael Babington
    3 Kings Avenue
    BR1 4HN Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    3 Kings Avenue
    BR1 4HN Bromley
    Kent
    British77897640001
    MOSS, Nicholas James
    3 Cranbrook Drive
    KT10 8DL Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 Cranbrook Drive
    KT10 8DL Esher
    Surrey
    UkBritish83498750001
    MURRAY, Katie
    Highbury Crescent
    Islington
    N5 1RN London
    8a
    Geschäftsführer
    Highbury Crescent
    Islington
    N5 1RN London
    8a
    BritainBritish136222180001
    MURRAY, Martin Charles
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish34484270004
    PERKINS, Ian Richard Brice
    Moth House
    Brown Candover
    SO24 9TT Alresford
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Moth House
    Brown Candover
    SO24 9TT Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritish24289520001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FAIRBAIRN U.K. LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Om Seed Investments (Uk) Limited
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millenium Bridge House
    United Kingdom
    15. Sept. 2017
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millenium Bridge House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Registrierungsnummer09921370
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    06. Apr. 2016
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4GG London
    5th Floor Millennium Bridge House
    Ja
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer2019022
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat FAIRBAIRN U.K. LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security deed
    Erstellt am 22. Juni 2000
    Geliefert am 05. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whether solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Supplemental security deed dated 10 january 2000 (supplemental to a security deed ated 25 september 1996 (the "principal deed")
    Erstellt am 10. Jan. 2000
    Geliefert am 24. Jan. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility agreement (as defined in the principal deed) any assured payment (as defined in the principal deed) by the bank, or any transfer of stock to the company by means of crest any agreement to transfer stock to the company by means of crest, or any issue of stock to the company by means of crest
    Kurze Angaben
    The principal deed was amended to include a first fixed charge on all sums and payments from time to time after the date of the supplemental security deed receivable by or for the account of the company by reason of or in respect of the closing out or liquidation of any unsettled contract relating to any stocks in crest.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental security deed (the "supplemental security deed") which is supplemental to a security deed dated 7TH november 1997 (the "principal deed")
    Erstellt am 24. Mai 1999
    Geliefert am 02. Juni 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilities whatsoever now and from time to time thereafter due, owing or incurred by the company to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all sums payments monies interests rights and remedies (charged by clause 3.1 of the principal deed)..by way of first floating charge all stock money property assets benefits interests rights and remedies (charged by clause 3.2 of the principal deed).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Letter of fixed charge
    Erstellt am 11. Jan. 1999
    Geliefert am 16. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the designated securities being all bonds certificates of deposit promissory notes treasury bills bill of exchange negotiable instruments stocks and shares (in bearer or registered form) gilt edged securities (including any such described by certificates or chits issued by the bank of england central gilts office, bank of england central moneymarkets office instruments local authority bills sterling bills commercial paper and medium term notes issued compliant to regulation 13 banking act 1987 (as amended) deposited with the company by the chargee. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chichester District Council
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Security deed
    Erstellt am 14. Jan. 1998
    Geliefert am 29. Jan. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with A. the security deed, B. the settlement bank services agreement or otherwise, C. any transfer of cmo instruments or property rights to the company by means of the cmo service, or D. any agreement to make a transfer of the kind specified in paragraph c
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge (a) all sums and payments now and from time to time hereafter receivable by or for the account of the company or directly or indirectly on its behalf by reason or in respect of any transfer or debit of, or any agreement to transfer or debit, cmo instruments from any eligible cmo instrument account of or in the name of or otherwise referable to the company in the cmo service or of any transfer by the company of any of its right, title or interest to and in cmo instruments represented or to be represented by any credit balance for the time being on any such eligible cmo instrument account in the cmo service (the debts), together with all rights and interests in such sums and payments;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Security deed
    Erstellt am 07. Nov. 1997
    Geliefert am 17. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred from the company to the chargee (whether solely or jointly, or jointly and severally with another or others and whether as principal or surety and whether actual or contingent present or future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsoever and including without limitation any such debts obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of cgo settlement bank facilities (as more particularly described in the security deed).
    Kurze Angaben
    All sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or on behalf of or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of any agreement to transfer or debit, stock from any eligible stock account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Security deed
    Erstellt am 25. Sept. 1996
    Geliefert am 03. Okt. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in conection with the provision of crest settlement bank facilities (as more particularly described in the security deed)
    Kurze Angaben
    All sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of, or any agreement to transfer or debit stock from eligible stock account of or in the name of or otherwise referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented or to be represented by any credit balance on any such eligible account together with all rights and interest in such sums and payments.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Security deed
    Erstellt am 13. Aug. 1996
    Geliefert am 23. Aug. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whther solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge pursuant to the ap facility agreement dated 22/11/95 between the bank and the company
    Erstellt am 12. Dez. 1995
    Geliefert am 20. Dez. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever now and from time to time hereafter (whether before or after the service of a default notice)
    Kurze Angaben
    Fixed charge all sums now and from time to time hereafter receivable by the company by reason or in respect of any transfer or debit stock or other securities from any stock account in the name of the company at the cgo. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge
    Erstellt am 25. Sept. 1995
    Geliefert am 11. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right, title and interest in and to all designated securities and designated cmo securities by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Building Society
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of fixed charge
    Erstellt am 01. Juli 1991
    Geliefert am 20. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right, title and interest in all designated securities by way of fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada
    Transaktionen
    • 20. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Jan. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 01. Juli 1991
    Geliefert am 17. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Stocks of shares, certificates of deposit, bills of exchange and instruments. (See 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • Commerz Bank Aktiengesells Chaft
    Transaktionen
    • 17. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Jan. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juli 1991
    Geliefert am 15. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee.
    Kurze Angaben
    All the company's rights title and interest to and in all designated securities.
    Berechtigte Personen
    • Banque Internationale a Luxembourg
    Transaktionen
    • 15. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Jan. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of subordination
    Erstellt am 20. Feb. 1991
    Geliefert am 28. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from seawillow limited under the terms of any of the security documents (as defined) up to the bank maximum of £12,500,000 to the chargee.
    Kurze Angaben
    The company as subordinated creditor agrees and declares it will hold anysums received in respect of any realisation of the property in respect of the subordinated liabilities (as defined) of seawillow prior to the bank liabilities up to the bank maximum being paid and satisfied in full, upon trust for the bank and forthwith pay the same to the bank. (Please see doc M395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Caisse Nationale De Credit Agricole S.A.
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 20. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Letter of hypothecation
    Erstellt am 26. März 1990
    Geliefert am 13. Apr. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Securities include, but not be limited to stocks (including gilt-edged securities) and shares, certificates of deposit, bills of exchange and investmentsof every description and documents concerning title thereto and shall include the right to delivery of investments held in a clearing system.
    Berechtigte Personen
    • Commerz Bank a Ktiengeseuschaft
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 18. Jan. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of subordination
    Erstellt am 22. Feb. 1990
    Geliefert am 02. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from seawillow limited to the chargee. Under the terms of any of the security documents (as defined) whether arising before or after the date of the winding-up (as defined) of seawillow limited or the commencement thereof up to a maximum amount of £ 9,063,000 in respect of principal plus costs and interest thereon
    Kurze Angaben
    Interchange warehouse chalk farm road, london NW7. (Please see doc 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Caisse National De Credit Agricole
    Transaktionen
    • 02. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 20. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge
    Erstellt am 23. Okt. 1986
    Geliefert am 30. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the banking services agreement
    Kurze Angaben
    A fixed and floating charge over stock or other securities (see form 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of England.
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    • 20. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Collateral agreement
    Erstellt am 17. Okt. 1984
    Geliefert am 23. Okt. 1984
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euro-clear system by the brussels office off morgan guaranty on its books in the name of the company. The collateral agreement prohibits the creation or subsistence of any other "lien" (as defined) over the collateral.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transaktionen
    • 23. Okt. 1984Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0