GEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED

GEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00450082
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED?

    • (2924) /
    • (7415) /

    Wo befindet sich GEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AUTOWRAPPERS EUROPACK LIMITED19. Apr. 199519. Apr. 1995
    AUTOWRAPPERS LIMITED24. Okt. 199024. Okt. 1990
    AUTO WRAPPERS (NORWICH) LIMITED 26. Feb. 194826. Feb. 1948

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für GEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. März 2011

    10 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 18. März 2011

    11 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Sept. 2010

    6 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    4 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    31 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O United Industries Plc Unit a Beech Industrial Estate Bacup Lancashire OL13 9EL am 22. Apr. 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Okt. 2009

    Kapitalaufstellung am 19. Okt. 2009

    • Kapital: GBP 323,254
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Darren Close am 02. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Philip Corke am 02. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Darren Close am 02. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Juli 2008

    19 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2007

    17 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2006

    22 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2005

    22 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    Seiten363(353)

    legacy

    Seiten363(190)

    Wer sind die Geschäftsführer von GEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CLOSE, Darren
    Whiteoak View
    BL3 1ST Bolton
    68
    Sekretär
    Whiteoak View
    BL3 1ST Bolton
    68
    British97213800001
    CLOSE, Darren
    Whiteoak View
    BL3 1ST Bolton
    68
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Whiteoak View
    BL3 1ST Bolton
    68
    United Kingdom
    EnglandBritish97213800001
    CORKE, Philip
    The Manor House
    1 Bedford Road
    MK44 3RG Moggerhanger
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    The Manor House
    1 Bedford Road
    MK44 3RG Moggerhanger
    Bedfordshire
    EnglandBritish85311430001
    FITZJOHN, Marianne
    Oliver House 4 Camoys Close
    Great Stukeley
    PE17 5AL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Sekretär
    Oliver House 4 Camoys Close
    Great Stukeley
    PE17 5AL Huntingdon
    Cambridgeshire
    British77119200001
    HARE, Richard Warren
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    British2955620006
    JAMES, Michael Chenery
    Heath House
    59 Loddon Road
    NR35 2RA Ditchingham
    Suffolk
    Sekretär
    Heath House
    59 Loddon Road
    NR35 2RA Ditchingham
    Suffolk
    British45245140001
    JAMES, Philip Alan
    Knavesmire
    2(B) Poplar Avenue
    NR4 7LB Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    Knavesmire
    2(B) Poplar Avenue
    NR4 7LB Norwich
    Norfolk
    British42593110001
    NEWMAN, James Allen
    1 Cranwell Gardens
    Poringland
    NR14 7SQ Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    1 Cranwell Gardens
    Poringland
    NR14 7SQ Norwich
    Norfolk
    British35885650001
    GEI GROUP OPERATIONS LIMITED
    Unit A
    Beech Industrial Estate
    OL13 9EL Bacup
    Lancashire
    Sekretär
    Unit A
    Beech Industrial Estate
    OL13 9EL Bacup
    Lancashire
    68840350005
    BELL, Gordon
    6 Old Rectory Close
    Mulbarton
    NR14 8LX Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    6 Old Rectory Close
    Mulbarton
    NR14 8LX Norwich
    Norfolk
    British30997150001
    BISSELL, Michael John
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British72109080003
    CARRUTH, Geoffrey Thomas
    10 Oaklands
    Taverham
    NR8 6TY Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    10 Oaklands
    Taverham
    NR8 6TY Norwich
    Norfolk
    British38882090001
    DAVIES, Vaughan Thomas
    The Poplars
    Grange Road
    YO25 8LN North Frodingham East Riding
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Poplars
    Grange Road
    YO25 8LN North Frodingham East Riding
    Yorkshire
    EnglandBritish80457720001
    DRAKE, Lucy Elizabeth
    11 Paultons Street
    SW3 5DR London
    Geschäftsführer
    11 Paultons Street
    SW3 5DR London
    British72020850003
    DUTNALL, Robert James
    32 Hartland Road
    CM16 4PE Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    32 Hartland Road
    CM16 4PE Epping
    Essex
    United KingdomBritish144310800001
    ELMS, William Alan
    Pinewood 67 Church Road Aspley Heath
    Woburn Sands
    MK17 8TJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Pinewood 67 Church Road Aspley Heath
    Woburn Sands
    MK17 8TJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British14255610001
    FIELD, Paul
    Reign Holme House Lane
    Luddenden Luddenden Foot
    HX2 6SZ Halifax
    W Yorks
    Geschäftsführer
    Reign Holme House Lane
    Luddenden Luddenden Foot
    HX2 6SZ Halifax
    W Yorks
    British48140110001
    FITZJOHN, Marianne
    Oliver House 4 Camoys Close
    Great Stukeley
    PE17 5AL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Oliver House 4 Camoys Close
    Great Stukeley
    PE17 5AL Huntingdon
    Cambridgeshire
    British77119200001
    FOWLER, Ian
    32 Newton Road
    W2 5LT London
    Geschäftsführer
    32 Newton Road
    W2 5LT London
    British41294100001
    GRAY, Ian Archie
    6 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    Geschäftsführer
    6 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    EnglandBritish115801110001
    HARE, Richard Warren
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish2955620006
    JAMES, Michael Chenery
    Heath House
    59 Loddon Road
    NR35 2RA Ditchingham
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Heath House
    59 Loddon Road
    NR35 2RA Ditchingham
    Suffolk
    British45245140001
    JAMES, Philip Alan
    Knavesmire
    2(B) Poplar Avenue
    NR4 7LB Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Knavesmire
    2(B) Poplar Avenue
    NR4 7LB Norwich
    Norfolk
    British42593110001
    MARSHALL, Peter Neville
    Linden
    Ashwood Road
    GU22 7JW Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Linden
    Ashwood Road
    GU22 7JW Woking
    Surrey
    British65049990001
    MULLARKEY, Stephen Patrick
    1 Lightfoot Court
    MK7 7HZ Milton Keynes
    Geschäftsführer
    1 Lightfoot Court
    MK7 7HZ Milton Keynes
    EnglandBritish72537260001
    NEWMAN, James Allen
    1 Cranwell Gardens
    Poringland
    NR14 7SQ Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    1 Cranwell Gardens
    Poringland
    NR14 7SQ Norwich
    Norfolk
    British35885650001
    PETERS, Dennis Robert
    Millfield Mill Lane
    Barnby
    NR34 7PX Beccles
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Millfield Mill Lane
    Barnby
    NR34 7PX Beccles
    Suffolk
    British19005510001
    PLATER, Bernard Arthur
    48 Kingswood Avenue Thorpe Marriott
    Taverham
    NR8 6UR Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    48 Kingswood Avenue Thorpe Marriott
    Taverham
    NR8 6UR Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish44095510002
    ROYLE, Graham
    2 Whirlow Green
    Whirlow
    S11 9NY Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Whirlow Green
    Whirlow
    S11 9NY Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish89849150001
    WHITAKER, Michael John
    38 Judges Walk
    NR4 7QF Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    38 Judges Walk
    NR4 7QF Norwich
    Norfolk
    British30997170001
    WRIGHT, David Robert
    106 Yarmouth Road
    NR32 4AQ Lowestoft
    Suffolk
    Geschäftsführer
    106 Yarmouth Road
    NR32 4AQ Lowestoft
    Suffolk
    British104544750001
    GEI INTERNATIONAL PLC
    Woodlands
    Aspley Hill, Woburn Sands
    MK17 8NW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Woodlands
    Aspley Hill, Woburn Sands
    MK17 8NW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    70346720001

    Hat GEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 30. Juli 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit(s) being all sums of money in any currency standing to the credit of the account numbered 06033124 s/c 12-01-03 together with all interest. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Two debentures (between the company,gei engineering products limited and the bank of scotland)
    Erstellt am 05. Feb. 2002
    Erworben am 01. März 2002
    Geliefert am 06. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    (I) whiffler rd,norwich; t/no nk 226378; (ii) common lane north,beccles,suffolk; sk 194600.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2002Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 28. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trust deed ("the trust deed") constituting 900,000 guaranteed secured nil rate "a"series loan stock 2005, £100,000 guaranteed secured nil rate"b" series loan stock 2005 and £1,500,000 guaranteed secured nil rate "c"series loan stock 2005
    Erstellt am 05. Feb. 2001
    Geliefert am 23. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of the "a" stock the "b" stock and the "c "stock, under the trust deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J O Hambro Capital Management Limited or If Different the Trustees Ortrustee for the Time Being of the Trust Deed
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Feb. 2001
    Geliefert am 08. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge and amendment to the debenture dated 6 august 1999 made between the company,midland bank PLC as security trustee and gei international PLC (the "parent")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gei International PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession made between midland bank PLC acting as trustee for the beneficiaries (the "security trustee") and dg bank deutsche genossenschaftsbank ag (the "member of the workout group") and the company (the "deed")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deed is made supplemental to a debenture dated 27 may 1999 made between the company and the security trustee (the "debenture") as amended by a deed of charge and amendment dated 6 august 1999 made between the company,the security trustee and gei international PLC (the "deed of amendment").the debenture as amended by the deed of amendment is referred to as the "amended debenture".all monies and liabilities due or to become due from the company to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dg Bank Deutsche Genossenschaftsbank Ag
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession made between midland bank PLC acting as trustee for the beneficiaries (the "security trustee") and midland bank PLC (the "member of the workout group") and the company (the "deed")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deed is made supplemental to a debenture dated 27 may 1999 made between the company and the security trustee (the "debenture") as amended by a deed of charge and amendment dated 6 august 1999 made between the company,the security trustee and gei international PLC (the "deed of amendment").the debenture as amended by the deed of amendment is referred to as the "amended debenture".all monies and liabilities due or to become due from the company to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession made between midland bank PLC acting as trustee for the beneficiaries (the "security trustee") and bhf-bank A.G. (the "member of the workout group") and the company (the "deed")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deed is made supplemental to a debenture dated 27 may 1999 made between the company and the security trustee (the "debenture") as amended by a deed of charge and amendment dated 6 august 1999 made between the company,the security trustee and gei international PLC (the "deed of amendment").the debenture as amended by the deed of amendment is referred to as the "amended debenture".all monies and liabilities due or to become due from the company to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank A.G.
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession made between midland bank PLC acting as trustee for the beneficiaries (the "security trustee") and brown,shipley & co.limited (the "member of the workout group") and the company (the "deed")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deed is made supplemental to a debenture dated 27 may 1999 made between the company and the security trustee (the "debenture") as amended by a deed of charge and amendment dated 6 august 1999 made between the company,the security trustee and gei international PLC (the "deed of amendment").the debenture as amended by the deed of amendment is referred to as the "amended debenture".all monies and liabilities due or to become due from the company to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Brown,Shipley & Co.Limited
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession made between midland bank PLC acting as trustee for the beneficiaries (the "security trustee") and kbc bank N.V.,london branch (the "member of the workout group") and the company (the "deed")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deed is made supplemental to a debenture dated 27 may 1999 made between the company and the security trustee (the "debenture") as amended by a deed of charge and amendment dated 6 august 1999 made between the company,the security trustee and gei international PLC (the "deed of amendment").the debenture as amended by the deed of amendment is referred to as the "amended debenture".all monies and liabilities due or to become due from the company to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank N.V.,London Branch
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession made between midland bank PLC acting as trustee for the beneficiaries (the "security trustee") and barclays bank PLC (the "member of the workout group") and the company (the "deed")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deed is made supplemental to a debenture dated 27 may 1999 made between the company and the security trustee (the "debenture") as amended by a deed of charge and amendment dated 6 august 1999 made between the company,the security trustee and gei international PLC (the "deed of amendment").the debenture as amended by the deed of amendment is referred to as the "amended debenture".all monies and liabilities due or to become due from the company to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession made between midland bank PLC acting as trustee for the beneficiaries (the "security trustee") and credit lyonnais commercial finance limited (the "member of the workout group") and the company (the "deed")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deed is made supplemental to a debenture dated 27 may 1999 made between the company and the security trustee (the "debenture") as amended by a deed of charge and amendment dated 6 august 1999 made between the company,the security trustee and gei international PLC (the "deed of amendment").the debenture as amended by the deed of amendment is referred to as the "amended debenture".all monies and liabilities due or to become due from the company to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession made between midland bank PLC acting as trustee for the beneficiaries (the "security trustee") and aib group (UK) P.L.C.(the "member of the workout group") and the company (the "deed")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deed is made supplemental to a debenture dated 27 may 1999 made between the company and the security trustee (the "debenture") as amended by a deed of charge and amendment dated 6 august 1999 made between the company,the security trustee and gei international PLC (the "deed of amendment").the debenture as amended by the deed of amendment is referred to as the "amended debenture".all monies and liabilities due or to become due from the company to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession made between midland bank PLC acting as trustee for the beneficiaries (the "security trustee") and fleet bank N.A.(the "member of the workout group") and the company (the "deed")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deed is made supplemental to a debenture dated 27 may 1999 made between the company and the security trustee (the "debenture") as amended by a deed of charge and amendment dated 6 august 1999 made between the company,the security trustee and gei international PLC (the "deed of amendment").the debenture as amended by the deed of amendment is referred to as the "amended debenture".all monies and liabilities due or to become due from the company to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fleet Bank N.A.
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession made between midland bank PLC acting as trustee for the beneficiaries (the "security trustee") and fortis bank N.V.-S.A.(the "member of the workout group") and the company (the "deed")
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 20. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The deed is made supplemental to a debenture dated 27 may 1999 made between the company and the security trustee (the "debenture") as amended by a deed of charge and amendment dated 6 august 1999 made between the company,the security trustee and gei international PLC (the "deed of amendment").the debenture as amended by the deed of amendment is referred to as the "amended debenture".all monies and liabilities due or to become due from the company to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank N.V.-S.A.
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 14. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All chattels specified in schedule to form 395 relative to the charge numbered 1 to 113 inclusive. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Mai 1999
    Geliefert am 04. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 04. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 1963
    Geliefert am 11. Nov. 1963
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due etc.
    Kurze Angaben
    Land & premises in leonard street, & rose yard, norwich, norfolk. (See doc 55 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1963Registrierung einer Belastung
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 1954
    Geliefert am 29. Dez. 1954
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due etc
    Kurze Angaben
    Freehold property botolph street and rose yard and freehold land at rose yard, norwich.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1954Registrierung einer Belastung
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 1953
    Geliefert am 29. Jan. 1953
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due etc
    Kurze Angaben
    Raeville beaumont road, costessey, norfolk.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1953Registrierung einer Belastung
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 1953
    Geliefert am 29. Jan. 1953
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due etc.
    Kurze Angaben
    "Inchmey" 212 middleton lane, hellesdon,norfolk.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1953Registrierung einer Belastung
    • 10. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GEI PROCESSING & PACKAGING MACHINERY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. März 2010Beginn der Verwaltung
    18. März 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Edward Williams
    Donington Court Pegasus Business Park
    DE74 2UZ Castle Donington
    East Midlands
    Praktiker
    Donington Court Pegasus Business Park
    DE74 2UZ Castle Donington
    East Midlands
    Stuart David Maddison
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castel Donnington East Midlands
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castel Donnington East Midlands

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0