ELECNATION LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ELECNATION LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00453920 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ELECNATION LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ELECNATION LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O MAZARS LLP 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ELECNATION LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MALDEN TIMBER LIMITED | 21. Feb. 1990 | 21. Feb. 1990 |
W B S TWO LIMITED | 09. Feb. 1989 | 09. Feb. 1989 |
WICKES BUILDING SUPPLIES LIMITED | 10. Mai 1948 | 10. Mai 1948 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELECNATION LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ELECNATION LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton Northamptonshire NN5 7UG zum 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX am 28. Sept. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Notification of Travis Perkins Financing Company No.3 Limited as a person with significant control on 27. Aug. 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Md (1995) Limited as a person with significant control on 27. Aug. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 16. Juli 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Deborah Grimason als Geschäftsführer am 06. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Peter Carter als Geschäftsführer am 18. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Deborah Grimason als Direktor am 18. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony David Buffin als Geschäftsführer am 11. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ELECNATION LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS, Alan Richard | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 137582690004 | ||||||||
TP DIRECTORS LTD | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
PIKE, Andrew Stephen | Sekretär | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | Secretary | 65678800002 | |||||||||
RIMMER, Barbara | Sekretär | 28 Chapel Lane Hale Barns WA15 0HN Altrincham Cheshire | British | 76973560002 | ||||||||||
STOKES-SMITH, Keith Reginald | Sekretär | 5a The Broadway Penn Road HP9 2PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | 75650590001 | ||||||||||
BARRY, Tom | Geschäftsführer | 131 Rectory Lane Tooting SW17 9PX London | British | Purchasing Director | 71348430001 | |||||||||
BATTERSBY, Geoffrey Brian | Geschäftsführer | 15 High Street Weedon HP22 4NW Aylesbury Buckinghamshire | British | Financial Controller | 41548740002 | |||||||||
BHOTE, Sanaya Homi | Geschäftsführer | 50 Bonnersfield Lane HA1 2LE Harrow Middlesex | British | Director Of Finance | 72716110002 | |||||||||
BIRD, Jeremy | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | Director | 111434190001 | ||||||||
BIRD, Jeremy | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | Director | 111434190001 | ||||||||
BIRD, Richard Sidney | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | British | Director | 111500210001 | |||||||||
BRENNAN, Rachel | Geschäftsführer | 30 Lammas Park Road Ealing W5 5JB London | British | Financial Executive | 51563330001 | |||||||||
BUFFIN, Anthony David | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | England | British | Company Director | 178011680002 | ||||||||
BUTCHER, Steven | Geschäftsführer | 11 Goose Eye Laycock BD22 0PD Keighley West Yorkshire | British | Director & General Manager | 41830700003 | |||||||||
BYKHOVSKY, Arkadi | Geschäftsführer | Flat 66 90 Kingston House South Ennismore Gardens Knightsbridge SW7 London | Canadian | Company Director | 36446950003 | |||||||||
CARTER, John Peter | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | Director | 46226920007 | ||||||||
CLAXTON, David Ian | Geschäftsführer | 21 Chatsworth Heights GU15 1NH Camberley Surrey | British | Sales Director | 12819530001 | |||||||||
COPPOCK, Lawrence Patrick | Geschäftsführer | The Close Church Lane SO51 0QH Braishfield Hampshire | England | United Kingdom | Finance Director | 152718990001 | ||||||||
DOROW, Stephen Derek | Geschäftsführer | The Gables 418 Station Road Dorridge B93 8EU Solihull West Midlands | British | Human Resources Director | 39583150001 | |||||||||
EVANS, Mark Stephen | Geschäftsführer | 181 Old Bedford Road LU2 7EH Luton Bedfordshire | British | Marketing Director | 77554430001 | |||||||||
GIFFITHS, Emrys John | Geschäftsführer | Thurlby Main Street Gawcott MK18 4HZ Buckingham Buckinghamshire | British | Operations Director | 58268120001 | |||||||||
GOLDRICK, Patrick Kieran | Geschäftsführer | The Bourne Kingston Lane Hillingdon UB8 3PN Uxbridge Middlesex | British | Director | 41383910001 | |||||||||
GRIFFITHS, Emrys John | Geschäftsführer | Ashridge Newport GL13 9PY Berkeley Gloucestershire | British | Director | 58268120002 | |||||||||
GRIMASON, Deborah | Geschäftsführer | Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | England | British | Company Secretary | 185755960002 | ||||||||
HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Geschäftsführer | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 72135950007 | ||||||||
HORNE, Nicholas Paul Stewart | Geschäftsführer | 4 Braemar Close GU7 1SA Godalming Surrey | British | Financial Executive | 983490001 | |||||||||
HOSKINS, William John | Geschäftsführer | 3 Homewood Road AL1 4BE St. Albans Hertfordshire | British | Finance Director | 49295070002 | |||||||||
HUNTER, David | Geschäftsführer | 129 Wilbury Road SG6 4JG Letchworth Hertfordshire | British | Sales Director | 64164380001 | |||||||||
KNIGHT, Robert Glen | Geschäftsführer | Ocean Heights 21 Sandown Road TQ4 7RL Paignton South Devon | British | Company Director | 813680002 | |||||||||
MCGRATH, William Joseph | Geschäftsführer | Manor House DN10 4RG Gringley On The Hill | United Kingdom | British | Company Director | 127106690001 | ||||||||
PENNY, Michael William Harrison | Geschäftsführer | Windrush 9 Downsway GU1 2YA Guildford Surrey | United Kingdom | British | Director | 144262470001 | ||||||||
SCULLION, Richard | Geschäftsführer | Mayfield Lilliesleaf TD6 9JD Melrose Roxburghshire | British | Finance Director | 67598780001 | |||||||||
STOKES-SMITH, Keith Reginald | Geschäftsführer | 5a The Broadway Penn Road HP9 2PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | Company Secretary | 75650590001 | |||||||||
TILNEY, Richard Neil | Geschäftsführer | Fairwoods Woodrock Hill AL4 9EB Sandridge Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 983480001 | |||||||||
WILLIAMS, David Grey | Geschäftsführer | Orchard House Shootersway Lane HP4 3NW Berkhamsted Hertfordshire | England | British | Managing Director | 33840400001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ELECNATION LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Perkins Financing Company No.3 Limited | 27. Aug. 2021 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Md (1995) Limited | 06. Apr. 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ELECNATION LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Jan. 1997 Geliefert am 15. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Limited recourse guarantee and debenture | Erstellt am 12. Dez. 1996 Geliefert am 20. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all or any of the oother companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks as defined) under the facilities agreement (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from lobe LTD and/or all or any of the companies named in the schedule to the mortgage to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land and buildings adjoining plough lane wimbledon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wickes properties LTD to the chargee on any account whatsoever under the terms of the principal deed dated 28.6.83 as varied by the variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben L/H land at angel road edonton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wickes properties LTD to the chargee on any account whatsoever under the terms of the principal deed dated 31.9.81 a further charge dated 5.3.82 as varied by a variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben L/H land 47-61 (odd nos) south road southall. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wickes properties LTD to the chargee on any account whatsoever under the terms of the principal deed dated 17.6.81 a further charge dated 5.3.82 as varied by a variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben L/H land at wilton st.dewsbury. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wickes properties LTD to the chargee on any account whatsoever under the terms of the principal deed dated 14.7.82 and a further charge dated 14.7.82 as varied by a variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben L/H land at station road sutton-in-ashfield. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wickes properties LTD to the chargee on any account whatsoever under the terms of the principal deed dated 14.7.82 and a further charge dated 14.7.82 as varied by a variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben L/H land at princeville road bradford. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wicks properties LTD to the chargee on any account whatsoever under the terms of the principle deed dated 30.1.81 and a further charge dated 5.3.82 as varied by a variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben L/H land at mulberry street/wakefield road huddersfield. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wicks properties LTD to the chargee on any account whatsoever under the terms of the principle deed dated 30/1/81 and a further charge dated 5.3.82 as varied by a variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben L/H land at winterton road scunthorpe. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wickes properties LTD to the chargee on any account whatsoever under the terms of the principle deed dated 30.1.81 and a further charge dated 5.3.82 as varied by a variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben L/H land at greetwell road/outer circle road lincoln. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wickes properties LTD to the chargee under the terms of the principal deed dated 30/01/81 and a further charge dated 5.3.82 as varied by a variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben L/H land and buildings on the south east side of plough lane wimbledon l/b of merton.t/no.sgl 226480. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wickes properties LTD to the chargee under the terms of the principal deed dated 30.1.81 and a further charge dated 5.3.82 as varied by a variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben L/H land at old lane beeston leeds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from wickes properties LTD to the chargee under the terms of the principal deed dated 30.1.81 and a further charge dated 5.3.82 as varied by a variation deed dated 16.9.83 | |
Kurze Angaben Land at west bawtry road rotherham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 20. Juli 1984 Geliefert am 25. Juli 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys now due or hereafter to become due or from time to time accruing due from lobe limited & the other principal debtors named in the charge to the chargee | |
Kurze Angaben L/H land & bldgs adjoining high road,chadwell heath essex.rental income from parts of rental mortgaged property.(as described). Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Juni 1983 Geliefert am 29. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from lobe limited and/or any of the other companies named in the charge to the chargee | |
Kurze Angaben L/H land and buildings on south side of the north circular road,edmonton. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Juni 1983 Geliefert am 29. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from lobe limited and/or any of the other companies named in the charge to the chargee | |
Kurze Angaben L/H land and buildings on south side of the north circular road,edmonton.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further legal charge | Erstellt am 14. Juli 1982 Geliefert am 15. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from crura limited and/or genea limited to the chargee pursuant to a legal charge dated 14/7/82 | |
Kurze Angaben L/H premises at ingleby road bradford west yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. Juli 1982 Geliefert am 15. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due from lobe limited and/or all or any of the companies named in the charge to the chargee | |
Kurze Angaben L/H premises at ingleby road,bradford west yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further legal charge | Erstellt am 14. Juli 1982 Geliefert am 15. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from crura limited and/or genea limited to the chargee pursuant to a legal charge dated 14/7/82 | |
Kurze Angaben L/H premises at ingleby road,bradford west yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. Juli 1982 Geliefert am 15. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from lobe limited and/or all or any of the companies named in the charge | |
Kurze Angaben L/H premises at ingleby road bradford west yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 29. Apr. 1982 Geliefert am 11. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property on the southside of hedon road,kingston upon hull,humberside described in a lease dated 29.9.75. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 29. Apr. 1982 Geliefert am 11. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 120/138 station road,harrow,middlesex.t/no.ngl 264734. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 29. Apr. 1982 Geliefert am 07. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property situate on the south side of hedon rd.,kingston upon hull,humberside. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 29. Apr. 1982 Geliefert am 07. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property situate at 120-138 station rd.,harrow,middlesex.t/no.ngl 264734. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ELECNATION LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0