ENODIS INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ENODIS INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00455541 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENODIS INVESTMENTS LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich ENODIS INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St Ann's Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENODIS INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BERISFORD INVESTMENTS LIMITED | 05. Dez. 1996 | 05. Dez. 1996 |
| BERISFORD PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 26. Sept. 1991 | 26. Sept. 1991 |
| BERISFORD (CREDIT RESOURCES) LIMITED | 11. Juni 1987 | 11. Juni 1987 |
| J.H. RAYNER (HOLDINGS) LIMITED | 25. März 1983 | 25. März 1983 |
| ZWANENBERG ASSOCIATED FOOD COMPANIES LIMITED | 15. Juni 1948 | 15. Juni 1948 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENODIS INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENODIS INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 36 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 28 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Jan. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Esyllt John-Featherby als Direktor am 19. Juni 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Albert James Rourke als Geschäftsführer am 19. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Cessation of Enodis Property Group Limited as a person with significant control on 27. Feb. 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Change of details for Enodis Group Limited as a person with significant control on 27. Feb. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Feb. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 6 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 32 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENODIS INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Sekretär | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Geschäftsführer | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JOHN-FEATHERBY, Esyllt | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf | England | British | 273323780001 | |||||||||
| HOOPER, David Ross | Sekretär | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| BOWKETT, Alan John | Geschäftsführer | Croxton Park Croxton PE19 6SY St Neots Cambridgeshire | England | British | 33301630002 | |||||||||
| CUTHBERTSON, George Brian | Geschäftsführer | 39 The Gardens WD1 3DN Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | 6996370001 | |||||||||
| DOERR, Thomas | Geschäftsführer | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| FINDLER, Jonathan Paul | Geschäftsführer | Westwood House Heathfield Avenue SL5 0AL Ascot Berkshire | British | 45532880003 | ||||||||||
| GORDON, Alastair Neil | Geschäftsführer | 64 Castelnau SW13 9EX London | England | British | 61620710001 | |||||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| JONES, Maurice Delon | Geschäftsführer | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| KACHMER, Michael James | Geschäftsführer | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| LEE, Paul Allan | Geschäftsführer | Clifton Park Road Caversham RG4 7PD Reading 4 Berkshire | England | British | 70564410001 | |||||||||
| MITCHELL, Graham Ramsay | Geschäftsführer | 53 Goodhart Place E14 8EQ London | England | British | 105501360001 | |||||||||
| NOBLE, Andrew Villiers | Geschäftsführer | 386 Malden Road KT4 7NJ Worcester Park Surrey | British | 64593020001 | ||||||||||
| O'CONNOR, Patrick Finbarr | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 66 Cumberland Mills Square Saunders Ness Road E14 3BJ Isle Of Dogs London | British/Irish | 900010100001 | ||||||||||
| ROURKE, John Albert James | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf | United Kingdom | British | 77646900002 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| WINTON, Adam Howard | Geschäftsführer | 23 Armitage Road Golders Green NW11 8QT London | England | British | 50077250001 | |||||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310650003 | |||||||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENODIS INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enodis Property Group Limited | 06. Apr. 2016 | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Enodis Group Limited | 06. Apr. 2016 | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ENODIS INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Erstellt am 11. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Erstellt am 20. Feb. 2002 Geliefert am 08. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Erstellt am 22. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 16. Sept. 1993 Geliefert am 20. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each of the indebtedness agreements (as defined) | |
Kurze Angaben The f/h property k/a bredbury industrial park stockport t/n gm 625224. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment | Erstellt am 01. Nov. 1991 Geliefert am 15. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee (the security agent) and the banks or any of them under the terms of each of the indebtedness agreements and under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Okt. 1991 Geliefert am 14. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the chargee (the second security agent) and the banks (as defined therein) or any of them under the terms of the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from the company under the subordinated guarantee and under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All that f/h land and buildings south side of bulsbrook road, hayes t/no. ALCH3721 - see form 395 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Okt. 1991 Geliefert am 14. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due form each obligor (as defined therein) to the chargee (the security agent) and the banks (as defined therein) or any of them under the terms of each of the indebtedness agreements and under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All f/h land and buildings south side of bulsbrook road, hayes t/no. ALCH3721 and all f/h land k/a 3 and 4 the square, petersfield, hampshire - see form 395 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 30. Juli 1991 Erworben am 31. Jan. 1992 Geliefert am 11. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the refinancing agreement dated 21/09/90 | |
Kurze Angaben Units 51, 52, 53, 54, 56 and 57 the maltings, bath street, gravesend, kent title numbers: K709759; K709757; K709758; K709762; K709761; and K709760 land previously k/a the depot, 44 and 45 west street, gravesend, gravesham, kenttitle number: K608279. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 30. Juli 1991 Erworben am 31. Jan. 1992 Geliefert am 11. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the refinancing agreement dated 21/09/90 | |
Kurze Angaben Units 51, 52, 53, 54, 56, and 57 the maltings, bath street, gravesend, kent title numbers: K709759; K709757; K709758; K709762; K709761; and K709760 land previously k/a the depot, 44 and 45 west street, gravesend, gravesham, kent title number: K608279. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 09. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the second security agent) and the banks (as therein defined) or any of them under the terms of the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from berksford international PLC under the subordinated guarantee | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Sept. 1990 Geliefert am 09. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the security agent) and the banks (as therein defined) or any of them under each of the indebtedness agreements | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 09. Feb. 1990 Erworben am 30. Sept. 1991 Geliefert am 21. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies | |
Kurze Angaben 13 lower bristol road, avon bath title no av 190171. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Juli 1988 Erworben am 30. Sept. 1991 Geliefert am 21. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies | |
Kurze Angaben Land on the north & south side of lower bristol road bath, avon title no av 92613. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0