ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00460836 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Acumen Distribution Services Ltd Boundary Way Lufton Trading Estate, Lufton BA22 8HZ Yeovil Somerset |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MANSPED LIMITED | 02. Jan. 1996 | 02. Jan. 1996 |
| UNITED CARRIERS AUTOMOTIVE LOGISTICS LIMITED | 18. Jan. 1994 | 18. Jan. 1994 |
| MANN & SON LONDON (HOLDINGS) LIMITED | 31. Dez. 1978 | 31. Dez. 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 3 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 23. Sept. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 12. Sept. 2014
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Feb. 2015 bis 30. Nov. 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Harris als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr David Francis Harris als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr William Stobart als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Avril Palmer-Baunack als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Light als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 28. Feb. 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS, David Francis | Sekretär | Boundary Way Lufton Trading Estate, Lufton BA22 8HZ Yeovil Acumen Distribution Services Ltd Somerset United Kingdom | British | 130075020001 | ||||||
| LAMPERT, Timothy Giles | Geschäftsführer | Boundary Way Lufton Trading Estate, Lufton BA22 8HZ Yeovil Acumen Distribution Services Ltd Somerset United Kingdom | England | British | 74811520007 | |||||
| STOBART, William | Geschäftsführer | Langford Way Appleton WA4 4TQ Warrington Stobart Group England | United Kingdom | British | 153344800001 | |||||
| ARMSTRONG, Colin | Sekretär | 200 Worle Parkway Worle BS22 6WA Weston Super Mare Somerset | British | 77327430003 | ||||||
| ARMSTRONG, Philippa | Sekretär | 162 Muller Road Horfield BS7 9QX Bristol Avon | British | 108400480001 | ||||||
| LIGHT, John Michael Heathcote | Sekretär | Mambury Manor East Putford EX22 7UH Holsworthy Devon | British | 50795850001 | ||||||
| NIZAN, Jacqueline Kay | Sekretär | 11 Medway Close MK16 9DT Newport Pagnell Buckinghamshire | British | 30038330001 | ||||||
| SMITH, Thomas Martyn | Sekretär | 3 Winston Drive Isham NN14 1HS Kettering Northamptonshire | British | 522060001 | ||||||
| ALEXANDER, William Norman | Geschäftsführer | 10 Park Road Hampton Hill TW12 1HB Hampton Middlesex | British | 66253860001 | ||||||
| ASTON, Anthony Lynn | Geschäftsführer | Eildon Seal Hollow Road TN13 3RZ Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 9012370001 | |||||
| BINKS, Allan William Spence | Geschäftsführer | Barton House The Green Clipston LE16 9RS Market Harborough Leicestershire | British | 33252740001 | ||||||
| BROWN, Russell Stephen | Geschäftsführer | Staplehay Trull TA3 7EZ Taunton Westways House Somerset | England | British | 132668460001 | |||||
| CARDLE, David Anthony | Geschäftsführer | Bakersfield School Road School Road CO9 2RY Little Maplestead Essex | British | 31944920001 | ||||||
| ELLIS, Stephen James | Geschäftsführer | 10 School Lane Lubenham LE16 9TW Market Harborough Leicestershire | British | 54329470001 | ||||||
| GARVEY, Kevin John | Geschäftsführer | 8 Nightingale Crescent New Bradwell MK13 7UE Milton Keynes Buckinghamshire | British | 57718780001 | ||||||
| GUINCHARD, Gilles | Geschäftsführer | 5 Upper St Martin's Lane WC2H 9EA London | French | 93757990002 | ||||||
| HARRIS, David Francis | Geschäftsführer | Boundary Way Lufton BA22 8HZ Yeovil Stobart Automotive Somerset England | England | British | 130075020001 | |||||
| LIGHT, John Michael Heathcote | Geschäftsführer | 5 Grange Park Roman Way NN4 5EA Northampton Autologic House United Kingdom | England | British | 50795850001 | |||||
| MERRY, John Charles | Geschäftsführer | Walon Boundary Way Lufton BA22 8HZ Yeovil Somerset | British | 9807640012 | ||||||
| NUTTALL, Philip James | Geschäftsführer | 5 Upper St Martins Lane WC2H 9EA London | British | 63716970003 | ||||||
| PAINTER, James | Geschäftsführer | Stoneleigh House Burley Lane DE22 5JR Quarndon Derbyshire | British | 41731410001 | ||||||
| PALMER-BAUNACK, Avril | Geschäftsführer | 5 Grange Park Roman Way NN4 5EA Northampton Autologic House United Kingdom | England | British | 196667380002 | |||||
| SHUTER, Adam John | Geschäftsführer | Tudor Cottage 11 Manor Road, Kilsby CV23 8XS Rugby Warwickshire | British | 59297260002 | ||||||
| SMITH, James Fergus Neil | Geschäftsführer | Stone End Chapel Close Towcester Road NN12 8JA Litchborough Northamptonshire | British | 17332750002 | ||||||
| SMITH, Thomas Martyn | Geschäftsführer | 3 Winston Drive Isham NN14 1HS Kettering Northamptonshire | England | British | 522060001 | |||||
| SOMERVILLE, Andy Forbes | Geschäftsführer | 5 Grange Park Roman Way NN4 5EA Northampton Autologic House United Kingdom | England | British | 200512970001 | |||||
| TOYNE, John Richard | Geschäftsführer | Kingsmoor House 83 Mill Lane NN2 6RQ Northampton | British | 63406940001 | ||||||
| WARLOW, Roger | Geschäftsführer | Applewood Faringdon Road Southmoor OX13 5AF Abingdon Oxfordshire | British | 45977210001 | ||||||
| WOOD, Terry George | Geschäftsführer | 26 The Old Yews DA3 7JS Longfield Kent | British | 56487950001 |
Hat ACUMEN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite all assets guarantee and debenture | Erstellt am 28. Apr. 2006 Geliefert am 12. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 27. Apr. 2006 Geliefert am 08. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed to a composite guarantee and debenture | Erstellt am 09. Okt. 1998 Geliefert am 17. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness liabilities and obligations owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee by any group company under the terms of the charge | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 26. Mai 1989 Geliefert am 16. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to became due from each obligor (as defined in each of the credit agreement and the subordenated loan agreement both dated 26.5.89) to the charge as agent and trustee for itself and the lenders (as defined in the charge) on anny account whatsoever under the terms of the finance documents (as defined in the charge). | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 17. Jan. 1986 Geliefert am 30. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys now on hereafter to the credit of any accounts of the company with the bank. Barclays bank PLC remann & son london (holdings) LTD. Cash security account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemmental legal mortgage | Erstellt am 14. März 1984 Geliefert am 15. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversupplemental to an agreement and & debenture dated 15/12/80 | |
Kurze Angaben Fixed charge over all book debts and other debts due or ouing to the company present ad future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Dez. 1980 Geliefert am 31. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. Tog with all fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery. (See doc M65). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Dez. 1980 Geliefert am 19. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, stock-in-trade work in progress, repayments investments & all cash. Tog with all buildings & fixtures, fixed plant & machenary (please see doc M64). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0