MARR FOODS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMARR FOODS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00467148
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MARR FOODS LIMITED?

    • Verarbeitung und Konservierung von Fisch, Krusten- und Weichtieren (10200) / Verarbeitendes Gewerbe
    • Großhandel mit anderen Nahrungsmitteln, einschließlich Fisch, Krebs- und Schalentieren (46380) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich MARR FOODS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MARR FOODS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MARR FROZEN FOODS LIMITED01. Okt. 198101. Okt. 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MARR FOODS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MARR FOODS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MARR FOODS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Dez. 2015

    6 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW zum 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH am 07. Mai 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 16. Apr. 2015

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 01. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 3,500,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Hamish Forbes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Jenny Nancy Loncaster als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 05. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 3,500,000
    SH01

    Erfüllung der Belastung 26 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 25 vollständig

    5 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    9 SeitenAA

    Ernennung von Mr Malcolm Herbert Lofts als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Leadbeater als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Hamish Drummond Forbes als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    12 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Christopher Britton als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    18 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Company business 20/09/2012
    RES13

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2012 bis 30. Sept. 2012

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    15 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Seventh senior amendment and restatement deed and other company business 11/06/2012
    RES13

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MARR FOODS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    PO BOX 16
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Sekretär
    PO BOX 16
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02249348
    75197930001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    EnglandBritish205633180001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Sekretär
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    British1031110002
    BERRY, Peter Sidney
    18 St Georges Place
    The Mount
    YO2 2DR York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    18 St Georges Place
    The Mount
    YO2 2DR York
    North Yorkshire
    British48690810001
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Geschäftsführer
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    EnglandBritish1031110002
    CULPIN, Malcolm
    17 High Wheatley
    Ben Rhydding
    LS29 8RX Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    17 High Wheatley
    Ben Rhydding
    LS29 8RX Ilkley
    West Yorkshire
    British37654460001
    DEE, Frank Rigby
    4 West View
    LS29 9JG Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    4 West View
    LS29 9JG Ilkley
    West Yorkshire
    British780440002
    EVANS, Thomas Jeffrey
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    Geschäftsführer
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    EnglandBritish2183390002
    FORBES, Hamish Drummond
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish66295550001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanish127032620001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    MILLSON, Steven Roland
    1 The Row
    Walesby
    LN8 3UW Market Rasen
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    1 The Row
    Walesby
    LN8 3UW Market Rasen
    Lincolnshire
    British49260600003
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    RAINES, Gerald Hector
    19 Marlborough Way
    Country Park
    DN35 0TR Cleethorpes
    South Humberside
    Geschäftsführer
    19 Marlborough Way
    Country Park
    DN35 0TR Cleethorpes
    South Humberside
    British44675880002
    VICKERS, David
    89 Northfield
    Swanland
    HU14 3RE Hull
    Geschäftsführer
    89 Northfield
    Swanland
    HU14 3RE Hull
    British2183410001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001

    Hat MARR FOODS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. Okt. 2008
    Geliefert am 01. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2008
    Geliefert am 04. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (Security Agent)
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. März 2007
    Geliefert am 31. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale the Security Agent
    Transaktionen
    • 31. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. März 2006
    Geliefert am 25. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transaktionen
    • 25. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2005
    Geliefert am 17. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All material premises being f/h interest in land and buildings on the north side of clive sullivan way, kingston upon hull t/no HS262846; l/h interest in land to the east of havelock street, kingston upon hull, land on the west side of gillett street and land and buildings on the south west side of gillett street; l/h interest in land and buildings on the south side of the scarborough street, kingston upon hull, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security accession deed
    Erstellt am 30. Juni 2004
    Geliefert am 10. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee, both present and future by way of first legal mortgage the property specified in schedule 1 to the accession deed, together with all buildings and fixtures and all the subsidiary shares and investments specified in schedule 2 to the accession deed;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securityagent)
    Transaktionen
    • 10. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 02. Mai 2003
    Geliefert am 15. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 02. Mai 2003
    Geliefert am 14. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 1997
    Geliefert am 09. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land and buildings on the west side of gillett street kingston upon hull.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 1997
    Geliefert am 04. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south of scarborough street, kingston upon hull, city of kingston upon hull.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Nov. 1996
    Geliefert am 18. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 30. Okt. 1995
    Geliefert am 31. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal sum of £36,900.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    A first fixed charge over:1 x yamato sdw 323 WH2 multihead machine,serial no:WG950396.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 31. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Dez. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Jan. 1995
    Geliefert am 27. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land south of hall street sandwell west midlands. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Sept. 1994
    Geliefert am 04. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at the south of scarborough street kingston upon hull humberside.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 24. Sept. 1994
    Geliefert am 28. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 5 of a sale agreement dated 24 september 1994
    Kurze Angaben
    Floating charge all the stock in trade both present and future wheresoever situated of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ub (Ross Youngs) Limited
    Transaktionen
    • 28. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Mai 1991
    Geliefert am 04. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south side of hermitage way, mansfield, nottinghamshire. Title no nt 247625.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Mai 1990
    Geliefert am 18. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the east of havelock street, kingston upon hull, humberside. Title no hs 169178.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 25. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Mai 1990
    Geliefert am 08. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the east of havelock street, kingston upon hull, humberside, title no hs 169179.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 25. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debenture
    Erstellt am 14. Apr. 1989
    Geliefert am 28. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from pinegain limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    For full details of property see form 395 ref M219C.
    Berechtigte Personen
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 20. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debenture
    Erstellt am 14. Apr. 1989
    Geliefert am 20. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from pinegain limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    (For full list of properties charged see form 395 ref:M613C and attached schedule a). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 20. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debenture
    Erstellt am 14. Apr. 1989
    Geliefert am 19. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/o rpinegain limited to the chargee under the terms of the secured loan and subscription agreement dated 14.4.89 and this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Marr International Limited
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 05. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debenture
    Erstellt am 14. Apr. 1989
    Geliefert am 19. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or pinegain limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Leslie Marr
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 05. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture.
    Erstellt am 14. Apr. 1989
    Geliefert am 26. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company pinegain limited. To the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 25. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 1985
    Geliefert am 24. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land on the west side of gillett st.kingston-upon-hull, humberside, togetherwith all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    • 05. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Nov. 1980
    Geliefert am 22. Nov. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all fixtures and fittings, fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transaktionen
    • 22. Nov. 1980Registrierung einer Belastung
    • 05. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MARR FOODS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. März 2016Aufgelöst am
    16. Apr. 2015Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian Green
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praktiker
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0