MARR FOODS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MARR FOODS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00467148 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MARR FOODS LIMITED?
- Verarbeitung und Konservierung von Fisch, Krusten- und Weichtieren (10200) / Verarbeitendes Gewerbe
- Großhandel mit anderen Nahrungsmitteln, einschließlich Fisch, Krebs- und Schalentieren (46380) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich MARR FOODS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Princes Parade L3 1QH Liverpool Merseyside |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MARR FOODS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MARR FROZEN FOODS LIMITED | 01. Okt. 1981 | 01. Okt. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MARR FOODS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MARR FOODS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MARR FOODS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Dez. 2015 | 6 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW zum 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH am 07. Mai 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hamish Forbes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jenny Nancy Loncaster als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 26 vollständig | 6 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 25 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Malcolm Herbert Lofts als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Leadbeater als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Hamish Drummond Forbes als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Britton als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 18 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2012 bis 30. Sept. 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 15 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MARR FOODS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | PO BOX 16 Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire |
| 75197930001 | ||||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Geschäftsführer | Princes Parade L3 1QH Liverpool 8 Merseyside | England | British | 177239110001 | |||||||||
| LONCASTER, Jenny Nancy | Geschäftsführer | Princes Parade L3 1QH Liverpool 8 Merseyside | England | British | 205633180001 | |||||||||
| CHEESEMAN, David Benjamin | Sekretär | 83 Newland Park HU5 2DR Hull | British | 1031110002 | ||||||||||
| BERRY, Peter Sidney | Geschäftsführer | 18 St Georges Place The Mount YO2 2DR York North Yorkshire | British | 48690810001 | ||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Geschäftsführer | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| CHEESEMAN, David Benjamin | Geschäftsführer | 83 Newland Park HU5 2DR Hull | England | British | 1031110002 | |||||||||
| CULPIN, Malcolm | Geschäftsführer | 17 High Wheatley Ben Rhydding LS29 8RX Ilkley West Yorkshire | British | 37654460001 | ||||||||||
| DEE, Frank Rigby | Geschäftsführer | 4 West View LS29 9JG Ilkley West Yorkshire | British | 780440002 | ||||||||||
| EVANS, Thomas Jeffrey | Geschäftsführer | Tudor Lodge 308 Beverley Road Anlaby HU10 7BG Hull | England | British | 2183390002 | |||||||||
| FORBES, Hamish Drummond | Geschäftsführer | Ross House Wickham Road DN31 3SW Grimsby North East Lincolnshire | England | British | 66295550001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan | Geschäftsführer | Hawerby Hall DN36 5PX Hawerby Cum Beesby Lincolnshire | United Kingdom | British | 58713750002 | |||||||||
| HARKJAER, Per | Geschäftsführer | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Geschäftsführer | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| MILLSON, Steven Roland | Geschäftsführer | 1 The Row Walesby LN8 3UW Market Rasen Lincolnshire | British | 49260600003 | ||||||||||
| PARKER, Michael | Geschäftsführer | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| RAINES, Gerald Hector | Geschäftsführer | 19 Marlborough Way Country Park DN35 0TR Cleethorpes South Humberside | British | 44675880002 | ||||||||||
| VICKERS, David | Geschäftsführer | 89 Northfield Swanland HU14 3RE Hull | British | 2183410001 | ||||||||||
| WARD, Peter Selwyn | Geschäftsführer | 155 Eastgate LN11 8DB Louth Lincolnshire | United Kingdom | British | 33803400001 |
Hat MARR FOODS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. Okt. 2008 Geliefert am 01. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Sept. 2008 Geliefert am 04. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. März 2007 Geliefert am 31. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. März 2006 Geliefert am 25. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Dez. 2005 Geliefert am 17. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All material premises being f/h interest in land and buildings on the north side of clive sullivan way, kingston upon hull t/no HS262846; l/h interest in land to the east of havelock street, kingston upon hull, land on the west side of gillett street and land and buildings on the south west side of gillett street; l/h interest in land and buildings on the south side of the scarborough street, kingston upon hull, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed | Erstellt am 30. Juni 2004 Geliefert am 10. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben With full title guarantee, both present and future by way of first legal mortgage the property specified in schedule 1 to the accession deed, together with all buildings and fixtures and all the subsidiary shares and investments specified in schedule 2 to the accession deed;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 02. Mai 2003 Geliefert am 15. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 02. Mai 2003 Geliefert am 14. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Dez. 1997 Geliefert am 09. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a land and buildings on the west side of gillett street kingston upon hull. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. März 1997 Geliefert am 04. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the south of scarborough street, kingston upon hull, city of kingston upon hull. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 08. Nov. 1996 Geliefert am 18. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 30. Okt. 1995 Geliefert am 31. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal sum of £36,900.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben A first fixed charge over:1 x yamato sdw 323 WH2 multihead machine,serial no:WG950396. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Jan. 1995 Geliefert am 27. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land south of hall street sandwell west midlands. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Sept. 1994 Geliefert am 04. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings at the south of scarborough street kingston upon hull humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 24. Sept. 1994 Geliefert am 28. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 5 of a sale agreement dated 24 september 1994 | |
Kurze Angaben Floating charge all the stock in trade both present and future wheresoever situated of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Mai 1991 Geliefert am 04. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the south side of hermitage way, mansfield, nottinghamshire. Title no nt 247625. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Mai 1990 Geliefert am 18. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land to the east of havelock street, kingston upon hull, humberside. Title no hs 169178. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Mai 1990 Geliefert am 08. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land to the east of havelock street, kingston upon hull, humberside, title no hs 169179. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 14. Apr. 1989 Geliefert am 28. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from pinegain limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben For full details of property see form 395 ref M219C. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 14. Apr. 1989 Geliefert am 20. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from pinegain limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben (For full list of properties charged see form 395 ref:M613C and attached schedule a). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 14. Apr. 1989 Geliefert am 19. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/o rpinegain limited to the chargee under the terms of the secured loan and subscription agreement dated 14.4.89 and this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 14. Apr. 1989 Geliefert am 19. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or pinegain limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture. | Erstellt am 14. Apr. 1989 Geliefert am 26. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company pinegain limited. To the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Jan. 1985 Geliefert am 24. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land on the west side of gillett st.kingston-upon-hull, humberside, togetherwith all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Nov. 1980 Geliefert am 22. Nov. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all fixtures and fittings, fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MARR FOODS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0