TOM PARKER DAIRIES

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTOM PARKER DAIRIES
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 00469790
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TOM PARKER DAIRIES?

    • (7499) /
    • (9305) /

    Wo befindet sich TOM PARKER DAIRIES?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Wallops Wood Farm
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TOM PARKER DAIRIES?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für TOM PARKER DAIRIES?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    7 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    5 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2004

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2003

    6 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2002

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten353

    Wer sind die Geschäftsführer von TOM PARKER DAIRIES?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PARKER, Elizabeth Mary Hilliard
    Wallops Wood House
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Geschäftsführer
    Wallops Wood House
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    EnglandBritish34426670001
    PARKER, John Humphrey
    Wallops Wood House
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Wallops Wood House
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish17452470001
    GRAHAM, Thomas Brendan
    Coolgrange
    Dunningstown Road
    IRISH Kilkenny
    County Kilkenny
    Ireland
    Sekretär
    Coolgrange
    Dunningstown Road
    IRISH Kilkenny
    County Kilkenny
    Ireland
    Irish975420001
    ROBERTS, Dilwyn
    86 Pont Adam
    Ruabon
    LL14 6EF Wrexham
    Clwyd
    Sekretär
    86 Pont Adam
    Ruabon
    LL14 6EF Wrexham
    Clwyd
    British31395530001
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Sekretär
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    38915800008
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    Harbour Court Compass Road
    North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    900001990001
    GRAHAM, Thomas Brendan
    Coolgrange
    Dunningstown Road
    IRISH Kilkenny
    County Kilkenny
    Ireland
    Geschäftsführer
    Coolgrange
    Dunningstown Road
    IRISH Kilkenny
    County Kilkenny
    Ireland
    Irish975420001
    HUMPHREY, David
    Broom Farm
    PO7 Hambledon
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Broom Farm
    PO7 Hambledon
    Hampshire
    British27459530001
    O'MAHONEY, Rory Edna
    7 Newpark Lawn
    Castlecomer Road
    Kilkennny
    County Kilkenny
    Ireland
    Geschäftsführer
    7 Newpark Lawn
    Castlecomer Road
    Kilkennny
    County Kilkenny
    Ireland
    Irish36033480001
    O'NEILL, Patrick Anthony
    Ossiry Grove
    Castle Road
    Kilkenny
    County Kilkenny
    Ireland
    Geschäftsführer
    Ossiry Grove
    Castle Road
    Kilkenny
    County Kilkenny
    Ireland
    Irish36288310001
    PARKER, John Humphrey
    Wallops Wood House
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Wallops Wood House
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish17452470001
    ROBERTS, Dilwyn
    86 Pont Adam
    Ruabon
    LL14 6EF Wrexham
    Clwyd
    Geschäftsführer
    86 Pont Adam
    Ruabon
    LL14 6EF Wrexham
    Clwyd
    British31395530001

    Hat TOM PARKER DAIRIES Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 17. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,523,910 and all other moneys due or to become due from tom parker farms and davis limited to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Second floating charge over the undertaking and property both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Tom Parker Farms
    Transaktionen
    • 17. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south side of hambledon lane, soberton, winchester, hampshire t/no. Hp 152627 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property K.a 13 beech rd (formerly 12A beech rd) fareham and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    78 priory rd gosport, hampshire t/no. Hp 289359. and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property K.A. stokewood house hambledon hampshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property K.A. broom farm soberton hampshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    6 norset road fareham, hampshire t/no. Hp 62997. and the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    79 & 81 priory rd gosport previously K.A. 81 priory rd gosport, hampshire t/no. Hp 289361 and the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    42 russell st gosport, hampshire t/no. Hp 289360 and the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    4 woodhall way fareham; t/no. Hp 72883. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property K.A. land adjoining copse rd, linchmere K.A. milk distribution depot haslemere and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    3 norset rd formerly K.A. plot 34 highlands rd estate, fareham hampshire,t/no hp 62466 and the proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    277 fareham rd gosport, hampshire t/no. Hp 289364 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1991
    Geliefert am 16. Mai 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k-a hoe cross farm hambledon hampshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 1965
    Geliefert am 10. Dez. 1965
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due etc
    Kurze Angaben
    All the lands and hereditaments comprised in or affected by all or any of the deeds or documents described in the schedule of the instrument together with etc.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank LTD
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1965Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 1965
    Geliefert am 10. Dez. 1965
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due etc.
    Kurze Angaben
    All the lands and hereditaments comprised in or affected by all or any of the deeds or documents described in the schedule of the instrument together with plant machinery fixtures (for details see doc 32).
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank LTD
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1965Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 1965
    Geliefert am 10. Dez. 1965
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due etc.
    Kurze Angaben
    All the lands and hereditaments comprised in or affected by all or any of the deeds or documents described in the schedule of the instrument together with plant machinery fixtures (for details see doc 31).
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank LTD
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1965Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 1965
    Geliefert am 10. Dez. 1965
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due etc.
    Kurze Angaben
    All the lands and hereditaments comprised in or affected by all or any of the deeds or documents described in the schedule of the instrument together with plant machinery fixtures (for detail see doc 30).
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank LTD
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1965Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 1965
    Geliefert am 10. Dez. 1965
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due etc
    Kurze Angaben
    All the lands and hereditaments comprised in or affected by all or any of the deeds or documents. Described in the schedule of the instrument together with plant machinery fixtures (for details see doc 29).
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank LTD
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1965Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0