RING LAMP COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRING LAMP COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00470202
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RING LAMP COMPANY LIMITED?

    • (5143) /

    Wo befindet sich RING LAMP COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o ERNST & YOUNG LLP
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RING LAMP COMPANY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    J.RIVLIN LIMITED28. Juni 194928. Juni 1949

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RING LAMP COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für RING LAMP COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Mai 2016

    13 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    13 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Feb. 2016

    13 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Feb. 2015

    14 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Feb. 2014

    13 Seiten4.68

    legacy

    3 SeitenMG04

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Überarbeiteter Vorschlag des Verwalters

    3 Seiten2.22B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Juli 2012

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Jan. 2012

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Juli 2011

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Feb. 2011

    21 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    8 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    31 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Ring House Gelderd Road Leeds West Yorkshire LS12 6NB England* am 31. Aug. 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Andrerw Rhodes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David James Robert Gutfreund als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Änderung der Details des Direktors für Mr David James Robert Gutfreund am 28. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Bruce Davidson als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von David Green als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von RING LAMP COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GUTFREUND, David James Robert
    c/o Ernst & Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Sekretär
    c/o Ernst & Young Llp
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    152671890001
    GUTFREUND, David James Robert
    Marie Louise Gardens
    Holme Road
    M20 2UP Didsbury
    The Lodge
    Manchester
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Marie Louise Gardens
    Holme Road
    M20 2UP Didsbury
    The Lodge
    Manchester
    United Kingdom
    United KingdomBritish70964170002
    MORRIS, Anthony Edwin
    Delf Field Fold
    Kebroyd Lane, Kebroyd
    HX6 3HT Sowerby Bridge
    Geschäftsführer
    Delf Field Fold
    Kebroyd Lane, Kebroyd
    HX6 3HT Sowerby Bridge
    EnglandBritish105158910004
    DAVIDSON, Bruce Wood Hardy
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    British117111790001
    DAVIDSON, Bruce Wood Hardy
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    British117111790001
    LAX, Noel Geoffrey
    5 Haweswater Close
    LS22 6FG Wetherby
    West Yorkshire
    Sekretär
    5 Haweswater Close
    LS22 6FG Wetherby
    West Yorkshire
    British51487610001
    WELHAM, Anthony Frederick
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    British21912090001
    WELHAM, Anthony Frederick
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    British21912090001
    YATES, John Martyn
    5 Melia Close
    BB4 6RQ Rossendale
    Lancashire
    Sekretär
    5 Melia Close
    BB4 6RQ Rossendale
    Lancashire
    British7608780001
    BLUTH, Thomas
    289 Landines Blvd
    Weston
    33327
    Usa
    Geschäftsführer
    289 Landines Blvd
    Weston
    33327
    Usa
    American70476630001
    BORZILLO, Anthony David
    4026 N. Ocean Drive
    Hollywood
    Florida
    33019
    Usa
    Geschäftsführer
    4026 N. Ocean Drive
    Hollywood
    Florida
    33019
    Usa
    American113811410001
    DAVIDSON, Bruce Wood Hardy
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish117111790001
    DAVIES, Colin Ernest
    14 Dower Park
    Escrick
    YO4 6JN York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    14 Dower Park
    Escrick
    YO4 6JN York
    North Yorkshire
    British78759470001
    FOX, Patrick Adam Charles
    30 Dorville Crescent
    W6 0HJ London
    Geschäftsführer
    30 Dorville Crescent
    W6 0HJ London
    British34607130001
    GREEN, David
    Forest Ridge
    East Ardsley
    WF3 2EU Wakefield
    7
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Forest Ridge
    East Ardsley
    WF3 2EU Wakefield
    7
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish140193220001
    HALL, John Maddison
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish61236690001
    HERSH, Robert
    6700 Sw 88 Terrace
    Miami
    FOREIGN Florida
    33156
    United States
    Geschäftsführer
    6700 Sw 88 Terrace
    Miami
    FOREIGN Florida
    33156
    United States
    United States72215110001
    LAX, Noel Geoffrey
    5 Haweswater Close
    LS22 6FG Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Haweswater Close
    LS22 6FG Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish51487610001
    MARBLE, Stephen Gerald
    10430 Sw 20 Street
    Davie
    Florida
    Fl33324
    Usa
    Geschäftsführer
    10430 Sw 20 Street
    Davie
    Florida
    Fl33324
    Usa
    American86928580001
    MEYER, Arnold Corydon
    Via D'Arezzo Drive
    Bonita Springs
    28607
    Florida 34135
    Usa
    Geschäftsführer
    Via D'Arezzo Drive
    Bonita Springs
    28607
    Florida 34135
    Usa
    American118011210003
    PRICE, William Anthony
    34 Lea Drive
    Shepley
    HD8 8HA Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    34 Lea Drive
    Shepley
    HD8 8HA Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish45498850001
    RAPPAPORT, Dean
    11988 Classic Drive
    Coral Springs
    Florida 33071
    Usa
    Geschäftsführer
    11988 Classic Drive
    Coral Springs
    Florida 33071
    Usa
    American71410030001
    RHODES, Andrew
    Elder Close
    WF17 0DD Birstall
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Elder Close
    WF17 0DD Birstall
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritish155554560001
    RIVLIN, Daniel Raphael
    272 Alwoodley Lane
    LS17 7DH Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    272 Alwoodley Lane
    LS17 7DH Leeds
    West Yorkshire
    British22980380001
    RODNEY, Gary
    3101 Pierson Drive
    FLORIDA Delray Beach
    33483
    Usa
    Geschäftsführer
    3101 Pierson Drive
    FLORIDA Delray Beach
    33483
    Usa
    American102721900001
    SASNETT, David Warren
    16254 S.W.67 Court
    Fort Lauderdale
    Florida 33331
    Usa
    Geschäftsführer
    16254 S.W.67 Court
    Fort Lauderdale
    Florida 33331
    Usa
    American76805900001
    SKILLEN, Robert Lynn
    Apt 510
    7345 Fairway Drive
    FOREIGN Miami Lakes
    Florida 33014
    United States
    Geschäftsführer
    Apt 510
    7345 Fairway Drive
    FOREIGN Miami Lakes
    Florida 33014
    United States
    British80493540001
    VARAKIAN, Robert
    17555 Collins Avenue Apt 1703
    FLORIDA Sunny Isles Beach
    33160
    America
    Geschäftsführer
    17555 Collins Avenue Apt 1703
    FLORIDA Sunny Isles Beach
    33160
    America
    American102721240001
    WELHAM, Anthony Frederick
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish21912090001
    WOELCKE, Gerald
    12637 Little Palm Lane
    Boca Raton
    Florida 33428
    Usa
    Geschäftsführer
    12637 Little Palm Lane
    Boca Raton
    Florida 33428
    Usa
    Canadian119073850001

    Hat RING LAMP COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2009
    Geliefert am 08. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage its interest if any in the additional mortgaged property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Saberasu Japan Investments Ii B.V.
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 25. Sept. 2009
    Geliefert am 29. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Interest in the additional mortgaged property- l/h property land and buildings k/a ring house, gelderd road, leeds see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Sept. 2009
    Geliefert am 06. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Saberasu Japan Investments Ii B.V.
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Apr. 2013Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 18. Sept. 2009
    Geliefert am 25. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Charge of deposit
    Erstellt am 14. Sept. 2009
    Geliefert am 18. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation 45937362 (606005) with the bank and any deposit account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Book debts and accounts charge
    Erstellt am 27. Juli 2009
    Geliefert am 28. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The ring euro blocked account, the ring usd blocked account each of its other blocked accounts and all monies standing to the credit of the accounts and the debts represented by them, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wachovia Bank, National Association
    Transaktionen
    • 28. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture (supplementing and amending a guarantee and debenture dated 23 december 2003)
    Erstellt am 23. Dez. 2004
    Geliefert am 04. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the sterling blocked accounts, non-sterling blocked accounts, sterling and non-sterling book debts,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Congress Financial Corporation (Florida) as Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 23. Dez. 2003
    Geliefert am 24. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Congress Financial Corporation (Florida) (the Agent) as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Lenders
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Loan and security agreement
    Erstellt am 23. Dez. 2003
    Geliefert am 09. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any or all of borrowers to agent or any lender and/or any of their affiliates under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The collateral being all accounts all general intangibles including without limitation all intellectual property all goods all real property and fixtures all chattel paper all instruments all documents and all deposit accounts * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Congress Financial Corporation (Florida), in Its Capacity as Agent for Lenders (the Agent)
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Mai 2002
    Geliefert am 14. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilites due owing or incurred by each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as marlborough works marlborough road accrington england BB5 5BE title number LA858360. Freehold property known as beza road hunslet leeds england LS10 2BR title number WYK569370. The leasehold property known as broadway broadway industrial estate hyde greater manchester SK14 5BE title number GM12514. For further details of properties charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Suntrust Bank as Trustee and Agent for the Banks
    Transaktionen
    • 14. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Aug. 2000
    Geliefert am 01. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilites due owing or incurred by each obligor to the chargee under or in connection with the facilities or any document given as security therefor by any such obligor on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Suntrust Bank as Trustee and Agent for the Banks (As Defined) ("Administrative Agent")
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Nov. 1998
    Geliefert am 12. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Aug. 1995
    Geliefert am 25. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Aug. 1994
    Geliefert am 17. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 1989
    Geliefert am 23. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Nina works. Gelderd road beeston roads leeds west yorkshire and all singular the buildings and erections now or hereafter erected on or affixed to the property.
    Berechtigte Personen
    • W.M. Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 03. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 04. Juni 1987
    Geliefert am 24. Juni 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £90,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    A first fixed charge over:- two medium speed semi-automatic legs iv/v lines for the production of gls- loups (for full details see form 395 ref: M376/10JUL/cf).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 24. Juni 1987Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. März 1987
    Geliefert am 30. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north east side of pontefract lane cross green leeds W. yorkshire T.n wyk 218676 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 1987Registrierung einer Belastung
    • 09. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed
    Erstellt am 05. Okt. 1981
    Geliefert am 17. Okt. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 17/9/80
    Kurze Angaben
    1) fixed charge on all book debts & other debts or claims. 2) fixed charge on all stock shares securities & interests in any subsidiary company.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank Limited
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1981Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 1980
    Geliefert am 24. Sept. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital, all buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank Limited
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1980Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 17. Sept. 1980
    Geliefert am 24. Sept. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as nina works gelderd road leeds west yorkshire, with buildings & appurtenances. Title no ywe 49960.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank Limited
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1980Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 1980
    Geliefert am 24. Sept. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital, all buildings fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • N.M. Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1980Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 17. Sept. 1980
    Geliefert am 24. Sept. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as nina works, gelderd road leeds west yorkshire, with buildings & appurtenances. Title no ywe 49960.
    Berechtigte Personen
    • N.M. Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1980Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 31. Dez. 1975
    Geliefert am 06. Jan. 1976
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Nina works, gelderd road, leeds LS12 6NB.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1976Registrierung einer Belastung
    • 03. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat RING LAMP COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Aug. 2010Beginn der Verwaltung
    11. Feb. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    2
    DatumTyp
    11. Feb. 2013Beginn der Liquidation
    15. Okt. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0