00475198 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | 00475198 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00475198 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 00475198 LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich 00475198 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Barn Close Yattendon RG18 0UX Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 00475198 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DILLONS NEWSAGENTS LIMITED. | 13. Juni 1984 | 13. Juni 1984 |
| T. DILLON & COMPANY LIMITED | 19. Nov. 1949 | 19. Nov. 1949 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 00475198 LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Sept. 2021 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2022 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für 00475198 LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Okt. 2022 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 27. Okt. 2022 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Okt. 2021 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für 00475198 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in freiwilliger Mitgliederliquidation | 2 Seiten | REST-MVL | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed hil\certificate issued on 18/03/24 | Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2021 bis 30. Sept. 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Okt. 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. Apr. 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von 00475198 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEMING, Catherine Elinor, Mrs. | Sekretär | Barn Close Yattendon RG18 0UX Berkshire | 171727590001 | |||||||
| FLEMING, Catherine Elinor | Geschäftsführer | Barn Close Yattendon RG18 0UX Berkshire | United Kingdom | British | 57034510002 | |||||
| SADLER, Stephen Paul | Geschäftsführer | Burnt Hill Yattendon RG18 0UX Thatcham Barn Close England England | England | British | 90689640003 | |||||
| BREMNER, George Alan | Sekretär | Barn Close Yattendon RG18 0UX Berkshire | British | 18157680002 | ||||||
| HERBERT, Graham | Sekretär | Staffords 12 Denehurst Close Barnt Green B45 8HR Birmingham Worcestershire | British | 41163430001 | ||||||
| REEVE, David John | Sekretär | 11 Eastbrook Close B76 1DD Sutton Coldfield West Midlands | British | 21969310001 | ||||||
| BATTMAN, Geoffrey Neil | Geschäftsführer | Wakeley Cottage The Green Tanworth In Arden B94 5AL Solihull West Midlands | British | 2326960001 | ||||||
| BREMNER, George Alan | Geschäftsführer | Barn Close Yattendon RG18 0UX Berkshire | United Kingdom | British | 18157680002 | |||||
| ILIFFE, Robert Peter Richard, The Right Honourable | Geschäftsführer | Barn Close Yattendon RG18 0UX Berkshire | United Kingdom | British | 174353160001 | |||||
| MORRIS, Timothy Denis | Geschäftsführer | Edgefield Mearse Lane Barnt Green B45 8HW Birmingham | British | 3289150001 | ||||||
| MORTON, Anthony Robert | Geschäftsführer | Dial House West Levington EN10 4LD Devizes Wiltshire | United Kingdom | British | 74065470001 | |||||
| PRICHARD, John Robert | Geschäftsführer | Church House Sellman Street Gnosall ST20 0EP Stafford Staffordshire | British | 5123210001 | ||||||
| RICHARDS, Sonya Lorraine | Geschäftsführer | Barn Close Yattendon RG18 0UX Berkshire | Uk | British | 101953320001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei 00475198 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartridge Investments Limited | 06. Apr. 2016 | Burnt Hill Yattendon RG18 0UX Thatcham Barn Close England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat 00475198 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 02. Aug. 2012 Geliefert am 14. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any present or future accounts of the companies with the bank, whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more of the companies including any accounts in the bank's name with any designation which includes the name(s) of any one or more of the companies, whether such accounts be denominated in sterling or any other currency or currency unit, and the debt or debts from time to time owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a "credit balance"). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 01 april 1992 | Erstellt am 24. Sept. 2007 Geliefert am 02. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 1/4/1992 | Erstellt am 20. Jan. 2006 Geliefert am 31. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. März 2004 Geliefert am 26. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower, each chargor and/or any other member of the restricted group to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the scheduled property, by way of first fixed charge the unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, rights as tenant, book debts, other debts, bank accounts and deposits, securities, uncalled capital, goodwill, intellectual property, other I.P. rights, by way of a first floating charge the undertaking, all other property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 01/04/1992 | Erstellt am 30. Juli 2003 Geliefert am 01. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Apr. 1993 Geliefert am 05. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 19. Nov. 1970 Geliefert am 03. Dez. 1970 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £ 20,000 | |
Kurze Angaben 609 walsall road great barr birmingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 03. Dez. 1964 Geliefert am 10. Dez. 1964 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben 73, queen elizabeth avenue, bentley, darlaston, staffordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 13. Dez. 1963 Geliefert am 01. Jan. 1964 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben 1, shakespear avenue, studley road, redditch, worcs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 10. Dez. 1963 Geliefert am 17. Dez. 1963 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben Plot 227, lodge park estate, redditch, worcs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat 00475198 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0