TERMINUS 11 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTERMINUS 11 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00478774
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TERMINUS 11 LIMITED?

    • (2222) /

    Wo befindet sich TERMINUS 11 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TERMINUS 11 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    POLESTAR COLCHESTER LIMITED06. Nov. 199806. Nov. 1998
    BPC COLCHESTER LTD26. Nov. 199626. Nov. 1996
    BPC MAGAZINES (COLCHESTER) LTD18. Jan. 199418. Jan. 1994
    BPCC MAGAZINES (COLCHESTER) LTD 07. Mai 199107. Mai 1991
    BPCC BUSINESS MAGAZINES (COLCHESTER) LIMITED04. Mai 198904. Mai 1989
    BPCC COLCHESTER WEB OFFSET LTD21. Apr. 198721. Apr. 1987
    Q B LIMITED25. Feb. 195025. Feb. 1950

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TERMINUS 11 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Sept. 2010
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Juni 2011
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für TERMINUS 11 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed polestar colchester LIMITED\certificate issued on 12/05/11
    5 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 09. Mai 2011

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 20. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 10,220,001
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Alan Goodwin am 31. Juli 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Alan Goodwin am 31. Juli 2009

    2 SeitenCH01

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    13 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von TERMINUS 11 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Sekretär
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    BritishCompany Secretary98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Geschäftsführer
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritishCompany Secretary98921850003
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGroup Hr Director83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    Geschäftsführer
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritishFinance Director138015860001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Sekretär
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    ALGAR, James Ian
    4 Webbs Close
    Combs
    IP14 2NZ Stowmarket
    Suffolk
    Geschäftsführer
    4 Webbs Close
    Combs
    IP14 2NZ Stowmarket
    Suffolk
    United KingdomBritishPrinter112317930001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishChief Executive Officer16105360002
    HOLLORAN, Peter John
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive61418710001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Geschäftsführer
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    BritishGroup Finance Director83714120001
    RICHARDSON, Douglas
    12 Keeble Close
    Tiptree
    CO5 0NU Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    12 Keeble Close
    Tiptree
    CO5 0NU Colchester
    Essex
    BritishPrinter90947730001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive44908110001
    SCHOLFIELD, Peter
    White House
    Nacton
    IP10 0ES Ipswich
    Suffolk
    Geschäftsführer
    White House
    Nacton
    IP10 0ES Ipswich
    Suffolk
    BritishPrinter73239120001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    Geschäftsführer
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritishDirector127238050003
    WELLS, Stephen David
    7 Jacksons Meadow
    Bidford On Avon
    B50 4HQ Alcester
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    7 Jacksons Meadow
    Bidford On Avon
    B50 4HQ Alcester
    Warwickshire
    BritishGeneral Manager53321720002

    Hat TERMINUS 11 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 26. Nov. 2008
    Geliefert am 08. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to the form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited as Agent and Trustee for the Benefit of the Lenders
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Amendment agreement relating to the security agreement dated 13 december 2006 and
    Erstellt am 25. Nov. 2008
    Geliefert am 08. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For properties charged please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited as Agent and Trustee for the Benefit of the Lenders
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental security agreement
    Erstellt am 09. März 2007
    Geliefert am 19. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The real estate being l/h land situated between brunel way and newcomen way colchester. L/h petty house whitehall road & coleman street leeds t/n WYK767996. L/h unit 2 lockwood house lockwood way parkside industrial estate leeds. For further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 19. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 13. Dez. 2006
    Geliefert am 22. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P.Morgan Europe Limited for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 19TH june 1998
    Erstellt am 27. Sept. 2006
    Geliefert am 30. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 23. Juni 2005
    Geliefert am 30. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Various equipment described in the schedule ferag line 2 comprising 10 s/no 13.71.0601 part no. Udr-420-ZF7, 20 s/no 13.32.1001 part no. HFA6-420-udr, 30 s/no 27.09.0201 part no. Sbs-usr for details of further equipment please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) or Such Otherperson as May from Time to Time Be Appointed Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 15. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) l/hold over unit B5 blenheim industrial park estate,bury st edmunds,suffolk; (ii) l/hold unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; BD77546; (iii) l/hold over wigman rd,aspley,nottingham; t/nos NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trstee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    Erstellt am 26. Okt. 2001
    Geliefert am 14. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Jan. 2001
    Geliefert am 09. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and all liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security agent) and the other secured parties (as defined in the debenture ) under or pursuant to the following documents:(a) a facilities agreement dated 5 may 1998 as amended by a first supplemental agreement dated 17 june 1998 and further amended by a second supplemental agreement dated 1 september 2000(b) a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998(c) any and all other mortgages(d) the other finance documents
    Kurze Angaben
    L/H property k/a premises at newcomen way colchester essex (and all buildings and fixtures (including trade fixtures) on the property.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 19. Juni 1998
    Geliefert am 10. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents
    Kurze Angaben
    F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 08. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chemical Investment Bank Limitedas Security Agent (As Defined Therein)
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 05. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as defined therein) and this deed
    Kurze Angaben
    Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank Therein)as Agent and Trustee for the Lenders (As Defined
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Feb. 1989
    Geliefert am 13. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from bucksmere limited under a facilities agreement dated 21/12/88 all monies from the company under a facilities agreement in respect of overdraft facilities as defined in the deed and all moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the governor and company of the bank of scotland as agent and trustee for the banks and the overdraft bank as defined on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    (See form 395 ref m 279 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 22. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Feb. 1989
    Geliefert am 13. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bucksmere limited under the terms of the mezzanine facilities agreement dated 21ST dec. '88 all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as defined in the deed.
    Kurze Angaben
    (For full details see form 395 ref m 295).. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Lenders
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0