YATES GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameYATES GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00478794
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von YATES GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich YATES GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Zolfo Cooper Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von YATES GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    YATES GROUP PLC27. Juli 200027. Juli 2000
    YATES BROTHERS WINE LODGES PLC25. Okt. 199625. Okt. 1996
    YATES BROTHERS WINE LODGES P.L.C.25. Feb. 195025. Feb. 1950

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von YATES GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis25. Feb. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für YATES GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    7 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. März 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. März 2011

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Sept. 2010

    6 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    17 Seiten2.34B

    legacy

    1 Seiten287

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. März 2009

    19 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Sept. 2008

    15 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von YATES GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Sekretär
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    KEEN, Christian
    The Paddock
    Alverton
    NG13 9PB Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Paddock
    Alverton
    NG13 9PB Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector117424240001
    BEE, John Derek
    Hollowforth Mill Cottage
    Hollowforth Lane Woodplumpton
    PR4 0BD Preston
    Lancashire
    Sekretär
    Hollowforth Mill Cottage
    Hollowforth Lane Woodplumpton
    PR4 0BD Preston
    Lancashire
    British46464230001
    COOPER, Andrew James
    9 Grenfell Road
    M20 6TG Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    9 Grenfell Road
    M20 6TG Manchester
    Lancashire
    BritishSolicitor63484760001
    HODDINOTT, Ruth Elizabeth
    12 Waterside House Chandlers Row
    Worsley
    M28 2BW Manchester
    Sekretär
    12 Waterside House Chandlers Row
    Worsley
    M28 2BW Manchester
    British56095180001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Sekretär
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    BritishCompany Secretary2739650001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Sekretär
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    NEWHALL NOMINEES LIMITED
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    Sekretär
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    18182520002
    BAKER, Suzanne Louise
    Lincoln House
    Rouse Court
    SL9 0NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Lincoln House
    Rouse Court
    SL9 0NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector35409580006
    BARNES, Michael John
    28 Old Lane
    Bramhope
    LS16 9AZ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    28 Old Lane
    Bramhope
    LS16 9AZ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director11951630001
    BEE, John Derek
    Hollowforth Mill Cottage
    Hollowforth Lane Woodplumpton
    PR4 0BD Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hollowforth Mill Cottage
    Hollowforth Lane Woodplumpton
    PR4 0BD Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director46464230001
    BROWN, Aaron Maxwell
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    Geschäftsführer
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    United KingdomBritishBusiness Consultant98928830002
    BROWN, Stephen John
    17 Mill Road
    SL7 1PX Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    17 Mill Road
    SL7 1PX Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector102228010001
    DICKSON, Peter Alan
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director13332510001
    ENEVOLDSON, Charles
    35 Richmond Grove
    BD19 4AG Gomersal
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    35 Richmond Grove
    BD19 4AG Gomersal
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector146869550001
    FISHER, Christopher Charles
    11 Burcote Road
    SW18 3LQ London
    Geschäftsführer
    11 Burcote Road
    SW18 3LQ London
    BritishInvestment Banker28790670001
    FOGLIO II, Alfred Louis
    3 Victoria Grove Mews
    Notting Hill Gate
    W2 4LN London
    Geschäftsführer
    3 Victoria Grove Mews
    Notting Hill Gate
    W2 4LN London
    United KingdomAmericanFund Manager90685630002
    FOWLER, Stevan Lloyd
    The Tower House
    Kirkless Hall Clifton
    HD6 4DH Brighouse
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Tower House
    Kirkless Hall Clifton
    HD6 4DH Brighouse
    Yorkshire
    BritishDirector88380470001
    FRASER, Angus Hugh
    Hornton Hall
    OX15 6DF Banbury
    Oxon
    Geschäftsführer
    Hornton Hall
    OX15 6DF Banbury
    Oxon
    BritishCompany Director5267460001
    GREEN, Jeremy John
    Hunters Wood
    Northwich Road,Cranage
    CW4 8HL Holmes Chapel
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Hunters Wood
    Northwich Road,Cranage
    CW4 8HL Holmes Chapel
    Cheshire
    United KingdomBritishChartered Accountant2718520003
    GRUNNELL, Mark
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    Geschäftsführer
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    United KingdomBritishDirector94144450002
    HENNESSY, Michael John Windsor
    Barn Close Riddings Lane
    Curbar Calver
    S32 3YT Hope Valley
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Barn Close Riddings Lane
    Curbar Calver
    S32 3YT Hope Valley
    South Yorkshire
    BritishCompany Director34175020002
    JONES, Mark Vincent
    The Hollies
    Hawley Lane, Halebarns
    WA15 0DR Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Hollies
    Hawley Lane, Halebarns
    WA15 0DR Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector84725550002
    KAZIEWICZ, Philip Bernard, Dr
    17 The Mount
    NW3 6SZ London
    Geschäftsführer
    17 The Mount
    NW3 6SZ London
    BritishInvestment Banker65659800001
    KERR-MUIR, James Rodier
    Flat 8 71 Elm Park Gardens
    SW10 9QE London
    Geschäftsführer
    Flat 8 71 Elm Park Gardens
    SW10 9QE London
    BritishCompany Director37895700002
    LEWIS, Michael Collin
    Broxburn 12 Salisbury Street
    S75 2TL Barnsley
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Broxburn 12 Salisbury Street
    S75 2TL Barnsley
    South Yorkshire
    BritishCompany Director16901800002
    MARCALL, Raymond George
    The Pines
    Heybridge Lane
    SK10 4ER Prestbury
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Pines
    Heybridge Lane
    SK10 4ER Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director3977340001
    MCLEOD, Gerald John Moreton
    Frolesworth House
    Main Street Frolesworth
    LE17 5EG Lutterworth
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Frolesworth House
    Main Street Frolesworth
    LE17 5EG Lutterworth
    Leicestershire
    BritishDirector1448320001
    MEGGITT, Timothy Andrew
    7 Park House
    Kirklees Hall, Clifton
    HD6 4HD Brighouse
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 Park House
    Kirklees Hall, Clifton
    HD6 4HD Brighouse
    West Yorkshire
    BritishCompany Director57975880002
    PAYNE, Ian Timothy
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    EnglandBritishChairman78974110003
    ROWLINSON, Colin
    Copt Hill Shaw
    Alcocks Lane
    KT20 6BB Kingswood
    Surrey
    Geschäftsführer
    Copt Hill Shaw
    Alcocks Lane
    KT20 6BB Kingswood
    Surrey
    BritishChartered Accountant77454060001
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Geschäftsführer
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritishBank Manager102593650002
    SYMONDS, Paul
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector80167420001
    TAGLIAFERRI, Mark Lee
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    EnglandBritishDirector106792270001
    WILLMOTT, Amanda Jane
    11 Britannia Square
    WR1 3DG Worcester
    Geschäftsführer
    11 Britannia Square
    WR1 3DG Worcester
    BritishCompany Director59211070002

    Hat YATES GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 21. Aug. 2007
    Geliefert am 24. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Promenade house, clarence parade cheltenham t/no GR181729, 3 the blob shop, dalton square lancaster t/no LA806315, ha ha, 13-17 new street york t/no NYK235252, for details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 2006
    Geliefert am 03. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    2-3 pavilion buildings brighton t/no ESX235090, english street carlisle t/no CU127453 and 15-23 frodsham street chester t/no CH355948 for details of other property charged please refer to form 395.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Feb. 2006
    Geliefert am 28. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee or to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    30 skinnergate darlington t/no DU198412,11 parliament street harrogate,67-71 high street lewisham t/no TGL137682 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag London Branch (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 20 may 2005
    Erstellt am 21. Nov. 2005
    Geliefert am 25. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    132-134 victoria road, aldershot t/n HP562374, 54/56 parsons street, banbury, oxon t/n ON227341 and 8 shambles street, barnsley t/n SYK355063 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge supplemental to a debenture dated the 20TH may 2005 and
    Erstellt am 02. Sept. 2005
    Geliefert am 15. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee or to any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Citadel corporation street birmingham title no WM515598, units 1-3 colston centre bristol t/no BL52542 and parklane/st james street burnley t/no LA561697 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security presented for registration in scotland on the 27TH may 2005 and
    Erstellt am 20. Mai 2005
    Geliefert am 08. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    134 and 136 west george street glasgow t/no GLA111651 together with the whole mines metals and minerals the whole buildings fittings and fixtures the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture creating fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Mai 2005
    Geliefert am 03. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee (whether for its own account or as agent or trustee for the secured parties) or to any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Yates opco security and undertaking agreement
    Erstellt am 20. Mai 2005
    Geliefert am 02. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the security is created in favour of the facility agent; and is security for the payment and satisfaction of all the secured liabilities; all estates and interests in any property now owned by it not situated in scotland and all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery on that property;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Finance Parties(The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 02. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 22. Okt. 2004
    Geliefert am 28. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 30 september 2004 and
    Erstellt am 21. Sept. 2004
    Geliefert am 07. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects known as 134 and 136 west george street glasgow t/n GLA111651.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Target group debenture
    Erstellt am 10. Sept. 2004
    Geliefert am 15. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 24. Feb. 1998
    Geliefert am 03. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for sale dated 27TH january 1998 and of a transfer of even date
    Kurze Angaben
    Equity in respect of the f/h property k/a 34 queens square wolverhampton t/no: WM556630.
    Berechtigte Personen
    • Blu Property Management Limited
    Transaktionen
    • 03. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of subordination
    Erstellt am 17. Dez. 1997
    Geliefert am 22. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from licensed retail properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All present and future liabilities of the borrower to the company whatso ever(whether principal or interest) the "junior debt" as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 17. Dez. 1997
    Geliefert am 22. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money obligations and liabilities due and owing or incurred by licensed retail properties limited to the chargee under or pursuant to or in connection with the financing documents
    Kurze Angaben
    All dividends interest and other moneys which may be received by the company in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charging documentation
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 25. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 20TH december 1996 over the property known as the alwoodley,618 harrogate road,alwoodley,leeds LS17 8EH
    Kurze Angaben
    The alwoodley 618 harrogate rd,alwoodley leeds LS17 8EH.
    Berechtigte Personen
    • Whitbread PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 1993
    Geliefert am 24. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a yates wine lodge (formerly the red lion hotel) promenade south shore blackpool lancashire t/no la 603356 & the proceeds of sale with a the goodwill of the business & the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 1993
    Geliefert am 24. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a yates wine lodge (formerly the talbot hotel) long row nottingham & the proceeds of sale with a the goodwill of the business & the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 1993
    Geliefert am 24. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property yates wine lodge 19/21 silver street halifax calderdale west yorkshire t/no wyk 153277 & the proceeds of sale and a the goodwill of the business & the full benefit of all licences held. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 1993
    Geliefert am 24. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Yates wine lodge oliver street birkenhead wirral merseyside t/no ms 2715136 & the proceeds of sale with a the goodwill of the business & the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 1993
    Geliefert am 24. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Premises k/a yates wine lodge (formerly the ghrey horse) no 144 & 146 church street preston & 13 bottons court preston t/no la 663155 & the proceeds of sale & athe goodwill of the business & the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat YATES GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Sept. 2009Ende der Verwaltung
    27. März 2008Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Simon Jonathan Appell
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    James John Gleave
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DatumTyp
    03. Jan. 2013Aufgelöst am
    28. Sept. 2009Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    James John Gleave
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0