VENUS FLEXIBLE PACKAGING
Überblick
Unternehmensname | VENUS FLEXIBLE PACKAGING |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
Unternehmensnummer | 00481376 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VENUS FLEXIBLE PACKAGING?
- (7499) /
Wo befindet sich VENUS FLEXIBLE PACKAGING?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VENUS FLEXIBLE PACKAGING?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MCG VENUS PACKAGING LIMITED | 03. Apr. 1989 | 03. Apr. 1989 |
METAL CLOSURES VENUS PACKAGING LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
VENUS PACKAGING LIMITED | 22. Apr. 1950 | 22. Apr. 1950 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VENUS FLEXIBLE PACKAGING?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2002 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VENUS FLEXIBLE PACKAGING?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 652a | ||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 5 Seiten | MAR | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 49(8)(b) | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 49(8)(a) | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 49(1) | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2002 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2001 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2000 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(288) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 1999 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 |
Wer sind die Geschäftsführer von VENUS FLEXIBLE PACKAGING?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHFORTH, Stephen Andrew | Sekretär | 12 Craigmount Grove EH12 8BP Edinburgh Lothian Scotland | British | 55018430002 | ||||||
GUNN, Ian Hugh Alexander | Geschäftsführer | Baylaw 2a Parrys Lane Stoke Bishop BS9 1AA Bristol | England | British | Managing Director Uk & Eire Re | 38956820001 | ||||
MAITLAND, David Young | Geschäftsführer | 8 Frankscroft EH45 9DX Peebles Peeblesshire | British | Finance Director | 64728520001 | |||||
NICHOL, Colin Miller | Sekretär | Duneasbuig Wester Balgedie KY13 7HE Kinross | British | Company Secretary | 52140002 | |||||
STANGER, John Anthony | Sekretär | 21 Bathwood Drive NG17 5FX Sutton In Ashfield Nottinghamshire | British | 18463870001 | ||||||
ASHFORTH, Stephen Andrew | Geschäftsführer | 12 Craigmount Grove EH12 8BP Edinburgh Lothian Scotland | British | Director | 55018430002 | |||||
BARLOW, Michael | Geschäftsführer | 33 Spenbeck Drive Allestree DE22 2UH Derby Derbyshire | British | Manufacturing Director | 18463880001 | |||||
BODIE, Ian Ross | Geschäftsführer | 8 Farington Terrace DD2 1LP Dundee Tayside | British | Company Director | 280310001 | |||||
BODIE, Ian Ross | Geschäftsführer | 8 Farington Terrace DD2 1LP Dundee Tayside | British | Company Director | 280310001 | |||||
BREWILL, Arthur Desmond | Geschäftsführer | Byre House The Green Church Lane NG13 9HG Langar Nottingham | British | Business Development Director | 18463900001 | |||||
DALTON, Andrew John | Geschäftsführer | 3 St Chads Rise LS6 3QE Leeds Yorkshire | British | Managing Director | 41800960001 | |||||
ELLIOTT, Jack | Geschäftsführer | 32 Shelford Road Radcliffe On Trent NG12 1AF Nottingham Nottinghamshire | British | Director | 18463910001 | |||||
MORROW, Digby Wilson | Geschäftsführer | Mannerston House EH49 7ND Linlithgow West Lothian | British | Company Director | 52677780001 | |||||
MORROW, Digby Wilson | Geschäftsführer | 5 Albany Road DD5 1NS West Ferry Dundee | British | Company Director | 18463920001 | |||||
NICHOL, Colin Miller | Geschäftsführer | Duneasbuig Wester Balgedie KY13 7HE Kinross | British | Company Secretary | 52140002 | |||||
PRICHARD, Barry Peter | Geschäftsführer | Stokeswold Warren Drive Kingswood Surrey | British | Divisional Chairman | 18463930001 | |||||
STANGER, John Anthony | Geschäftsführer | 21 Bathwood Drive NG17 5FX Sutton In Ashfield Nottinghamshire | England | British | Financial Director | 18463870001 | ||||
TAYLOR, Daniel Hamilton | Geschäftsführer | Millheath 267 Wollaton Vale NG8 2PX Wollaton Nottinghamshire | England | British | Divisional Finance Director | 119709450001 | ||||
TYSON, David Montague | Geschäftsführer | 1 Harby Lane Plungar NG13 0JH Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Sales And Marketing Director | 17953460001 |
Hat VENUS FLEXIBLE PACKAGING Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 08. Aug. 1990 Geliefert am 29. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financing documents (as defined therein) | |
Kurze Angaben (See doc). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of postponement | Erstellt am 25. Aug. 1961 Geliefert am 15. Sept. 1961 | Ausstehend | Gesicherter Betrag For postponing and debenture dated 26TH sep 1959 so that 2 charges dated respectively 25 sep 1959 and 25 aug 1961 shall rank in priority to the said debenture to the extent of £50,000 | |
Kurze Angaben Factory, outbuildings land & premises at 1 cheston junction, cossall, notts & all buildings fixed plant, machinery & other fixtures thereon excluding any fixed plant fixed machinery or fixtures in the nature of tenants or trade fixtures or fittings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0