MERRYCHEF LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MERRYCHEF LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00487712 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MERRYCHEF LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MERRYCHEF LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St Ann's Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MERRYCHEF LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MAX-ARC LIMITED | 27. Okt. 1950 | 27. Okt. 1950 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MERRYCHEF LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MERRYCHEF LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Mai 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 19 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Arthey als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 23 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Graham Philip Brisley Veal am 30. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Blades als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Robert Michael Arthey am 08. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Prima Secretary Limited am 08. Mai 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 23 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Doerr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Adrian David Gray als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MERRYCHEF LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Sekretär | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Geschäftsführer | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| HOBBS, Jeremy David | Geschäftsführer | 160 Bridgetown Road CV37 7JA Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 30245730001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Geschäftsführer | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| HOOPER, David Ross | Sekretär | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| JELLY, Jennifer | Sekretär | Wychanger Hook Lane Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | British | 1745390001 | ||||||||||
| KEYWOOD, Joyce Rosalyn | Sekretär | 22 York Gardens KT12 3EP Walton On Thames Surrey | British | 50397900001 | ||||||||||
| AIREY, Andrew Robert | Geschäftsführer | Heywood House Mark Way GU7 2BB Godalming Surrey | England | British | 54515590004 | |||||||||
| ARTHEY, Robert Michael | Geschäftsführer | 6 Fullerton Close GU51 1BJ Fleet Hampshire | England | British | 106616280002 | |||||||||
| BARKER, Simon Charles | Geschäftsführer | Timberdene Cottage Chalk Road, Ifold RH14 0UD Billingshurst West Sussex | British | 113730600001 | ||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| BRAY, Kenneth Ivor | Geschäftsführer | Nether Hall Main Street, Denton NG32 1JR Grantham Lincolnshire | British | 45153770002 | ||||||||||
| CAMPBELL, James | Geschäftsführer | Rent Street Cottages 60 Chipperfield Road HP3 0JW Bovingdon Hertfordshire | British | 53496740001 | ||||||||||
| DOERR, Thomas | Geschäftsführer | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| EATON, Derek James | Geschäftsführer | 53 Cedars Road BR3 4JG Beckenham | England | British | 112945120001 | |||||||||
| FINDLER, Jonathan Paul | Geschäftsführer | Westwood House Heathfield Avenue SL5 0AL Ascot Berkshire | British | 45532880003 | ||||||||||
| GALE, Robert Geoffrey | Geschäftsführer | Hurlands Lane GU8 4NT Dunsfold Hurst Hill Lodge Surrey Uk | United Kingdom | British | 138375430001 | |||||||||
| GEORGE, Alan | Geschäftsführer | Oak Tree Cottage Robin Hood Lane Sutton Green GU4 7QG Guildford Surrey | British | 1745400001 | ||||||||||
| GREEN, Robert Anthony | Geschäftsführer | Yew Tree Cottage South Lane Nomansland SP5 2BZ Salisbury Wiltshire | England | British | 10281810001 | |||||||||
| HAMPTON, Mark Richard | Geschäftsführer | Bankside 5 Parsonage Road HP8 4JW Chalfont St. Giles Buckinghamshire | British | 80408810001 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||||||
| HOUGHTON, Reece | Geschäftsführer | 5 St Barbe Close SO51 5RH Romsey Hampshire | British | 27953100001 | ||||||||||
| JELLY, Aubrey Bruce, Mr. | Geschäftsführer | Wychanger GU5 9QQ Shere Surrey | United Kingdom | British | 82764370003 | |||||||||
| JELLY, Jennifer | Geschäftsführer | Wychanger Hook Lane Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | British | 1745390001 | ||||||||||
| KEYWOOD, Joyce Rosalyn | Geschäftsführer | 22 York Gardens KT12 3EP Walton On Thames Surrey | British | 50397900001 | ||||||||||
| LEE, Paul Allan | Geschäftsführer | Clifton Park Road Caversham RG4 7PD Reading 4 Berkshire | England | British | 70564410001 | |||||||||
| MCCULLOCH, David Swinton | Geschäftsführer | 920 Westwinds Boulevard Tarpon Springs Florida 34689 Usa | Canadian British | 78976850002 | ||||||||||
| MILLER, Stuart Purves | Geschäftsführer | 1 Meadway Park SL9 7NN Gerards Cross Buckinghamshire | England | British | 98718070001 | |||||||||
| OSBORNE, Ian | Geschäftsführer | Yorkshire Place Warfield RG42 3XF Bracknell 59 Berkshire Uk | British Canadian | 137173190001 | ||||||||||
| ROLT, Jeremy Charles | Geschäftsführer | 4 Sycamore Close St Ippolyts SG4 7SN Hitchin Hertfordshire | England | British | 35716980001 | |||||||||
| SHUR, Irwin Michael | Geschäftsführer | 10007 Tree Tops Lake Road FOREIGN Tampa Florida 33626 Usa | Us | 124062640002 | ||||||||||
| THORNEYWORK, Nigel | Geschäftsführer | Malden Dale Bailes Lane Normandy GU3 2AX Guildford Surrey | England | British | 9730100001 | |||||||||
| TONER, Robert Anthony | Geschäftsführer | 29 Lamb Close WD25 0TB Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | 70516300002 |
Hat MERRYCHEF LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Erstellt am 11. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Erstellt am 20. Feb. 2002 Geliefert am 08. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Erstellt am 20. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 20. Dez. 1996 Geliefert am 03. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 20. Dez. 1996 Geliefert am 27. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold premises at station road west,ashvale,aldershot,hampshire GU12 5XA; see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 26. Jan. 1983 Geliefert am 11. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts. Uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 10. Dez. 1982 Geliefert am 31. Dez. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 03. März 1981 Geliefert am 10. März 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to and/or all or any of the othher companies named therein to barclays bank LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All that property undertaking & assets charged by the principal deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0