PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00490152 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?
- Andere Reinigungsdienste (81299) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ground Floor Suite River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Kent |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GORTON BROS,LIMITED | 03. Jan. 1951 | 03. Jan. 1951 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 004901520008 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 8 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 13 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 004901520008, erstellt am 30. Aug. 2016 | 46 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Simon Kenneth Giles als Sekretär am 28. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Ian Saunders als Geschäftsführer am 28. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Saunders als Sekretär am 28. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Stephen Levine als Direktor am 28. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Kenneth Giles als Direktor am 09. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Dudley als Geschäftsführer am 12. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILES, Simon Kenneth | Sekretär | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | 201339390001 | |||||||
| GILES, Simon Kenneth | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | England | British | 196768780001 | |||||
| LEVINE, Jonathan Stephen | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | England | British | 19162600001 | |||||
| BRIDGWOOD, Dennis Henry | Sekretär | 22 Bronington Close Northenden M22 4ZQ Manchester | British | 18005670003 | ||||||
| DOWE, Stephen William | Sekretär | 10 Breary Lane East Bramhope LS16 9BJ Leeds West Yorkshire | British | 88908400002 | ||||||
| MCGIVERN, James Patrick | Sekretär | The Ridge CH60 6SP Wirral 3 Merseyside | British | 120346770001 | ||||||
| SAUNDERS, Mark | Sekretär | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | 167359580001 | |||||||
| SCOBIE, James Martin | Sekretär | Eastcote BR6 0AU Orpington 1 Kent England | 149576830001 | |||||||
| STRATFORD, Frederick | Sekretär | Adair Street M1 2NQ Manchester Aero Works | 162167080001 | |||||||
| BOYLE, Eugene Daniel | Geschäftsführer | Teach Ban Parkside Drive PR6 7PL Whittle Le Woods Chorley Lancashire | United Kingdom | British | 86492920001 | |||||
| BRIDGWOOD, Dennis Henry | Geschäftsführer | 22 Bronington Close Northenden M22 4ZQ Manchester | British | 18005670003 | ||||||
| DOWE, Stephen William | Geschäftsführer | 10 Breary Lane East Bramhope LS16 9BJ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 88908400002 | |||||
| DUDLEY, Scott | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | England | British | 166551090001 | |||||
| GORTON, Janice | Geschäftsführer | Deepdale 33 Jacksons Edge Road Disley SK12 2LN Stockport Cheshire | British | 19948440001 | ||||||
| GORTON, Jeffrey William | Geschäftsführer | 2 Whalley Road Hale WA15 9DF Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 6307420001 | |||||
| GORTON, Kenneth Rodney | Geschäftsführer | Deepdale 33 Jacksons Edge Road Disley SK12 2LN Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 16289860001 | |||||
| GORTON, Patricia | Geschäftsführer | 2 Whalley Road WA15 9DF Hale Cheshire | British | 84528730001 | ||||||
| HARDY-WILSON, Nigel Andrew | Geschäftsführer | Adair Street M1 2NQ Manchester Aero Works | England | British | 149590930001 | |||||
| HOWROYD, David Rowan | Geschäftsführer | Bay Tree House East Street TN20 6TY Mayfield East Sussex | British | 72333480002 | ||||||
| MCGIVERN, James Patrick | Geschäftsführer | The Ridge CH60 6SP Wirral 3 Merseyside | England | British | 120346770002 | |||||
| PICKUP, James | Geschäftsführer | Crooklands Farm Goosnargh Lane Goosnargh PR3 2JU Preston Lancashire | British | 35926750001 | ||||||
| SAUNDERS, Mark Ian | Geschäftsführer | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent England | England | British | 139588670003 | |||||
| SCOBIE, James Martin | Geschäftsführer | 1 Eastcote BR6 0AU Orpington Kent | United Kingdom | British | 73982880001 | |||||
| STRATFORD, Frederick Anthony | Geschäftsführer | Adair Street M1 2NQ Manchester Aero Works | United Kingdom | British | 151871680001 | |||||
| WINSTANLEY, Michael, Lord | Geschäftsführer | 93 Bankhall Lane Hale WA15 0NW Altrincham Cheshire | British | 21499330001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Roger Leonard Burdett | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Jonathan Stephen Levine | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr David Mundell | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Simon Giles | 06. Apr. 2016 | River House Maidstone Road DA14 5RH Sidcup Ground Floor Suite Kent | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat PARAGON HYGIENE SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 30. Aug. 2016 Geliefert am 01. Sept. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Okt. 2008 Geliefert am 05. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed & floating charge | Erstellt am 30. Okt. 2008 Geliefert am 04. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Okt. 2008 Geliefert am 04. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Nov. 2004 Geliefert am 16. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Aug. 1988 Geliefert am 12. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H - 72 to 76 (even) laindon road, rusholme manchester. Title no. Gm 345742. by way of fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. März 1988 Geliefert am 07. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Sept. 1978 Geliefert am 10. Okt. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land with buildings known as cumber works, bennett street, ardwick, manchester, greater manchester, title no. Gm 155045 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0