DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00496972 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED?
- Herstellung von anderen Metallwaren (25990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Forge Lane Killamarsh S21 1BA Sheffield England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| IEP DONCASTERS LIMITED | 24. Dez. 1990 | 24. Dez. 1990 |
| DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED | 28. Juni 1951 | 28. Juni 1951 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Change of details for Doncasters Limited as a person with significant control on 18. Sept. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2023 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Repton House Bretby Business Park, Ashby Road Burton upon Trent Staffordshire DE15 0YZ England zum Forge Lane Killamarsh Sheffield S21 1BA am 20. Sept. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 2 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Simon David Martle als Geschäftsführer am 01. Aug. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 1 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2022 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Helen Barrett-Hague am 29. Sept. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung von Mrs Helen Barrett-Hague als Direktor am 28. Sept. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ian Molyneux als Sekretär am 28. Sept. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mrs Helen Barrett-Hague als Sekretär am 28. Sept. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Ian Molyneux als Geschäftsführer am 28. Sept. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon David Martle am 09. Sept. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Simon David Martle als Direktor am 01. Sept. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Michael Joseph Quinn als Direktor am 13. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Lisa Marie Oxnard als Geschäftsführer am 13. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRETT-HAGUE, Helen | Sekretär | Killamarsh S21 1BA Sheffield Forge Lane England | 287748710001 | |||||||
| BARRETT-HAGUE, Helen | Geschäftsführer | Killamarsh S21 1BA Sheffield Forge Lane England | England | British | 287804380001 | |||||
| QUINN, Michael Joseph | Geschäftsführer | Killamarsh S21 1BA Sheffield Forge Lane England | Ireland | Irish | 268174890001 | |||||
| JACKSON, Howard Watson | Sekretär | Red House Farm CV35 0EB Little Kineton Warwickshire | British | 34443700002 | ||||||
| KAYSER, Michael Arthur | Sekretär | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | British | 141893610001 | ||||||
| MOLYNEUX, Ian | Sekretär | Bretby Business Park, Ashby Road DE15 0YZ Burton Upon Trent Repton House Staffordshire England | British | 164531860001 | ||||||
| TILLEY, Michael John | Sekretär | Silver Birches 189 Main Street LE67 1AH Thornton Leicestershire | British | 60728390001 | ||||||
| ASTON, Stephen Mark | Geschäftsführer | The Gables Rowley Avenue ST17 9AA Stafford | United Kingdom | British | 287327450002 | |||||
| BULL, George | Geschäftsführer | 3 Murdoch Close Ferndale Manor NG22 8FE Farnsfield Nottinghamshire | British | 47402550004 | ||||||
| DILLAMORE, Ian Leslie | Geschäftsführer | 65 Monmouth Drive B73 6JH Sutton Coldfield West Midlands | British | 35534570001 | ||||||
| ELLIS, William Michael | Geschäftsführer | Manor Drive Worthington LE65 1RN Ashby-De-La-Zouch The Manor House Leicestershire | United Kingdom | American | 134919220003 | |||||
| HINKS, Duncan Andrew | Geschäftsführer | Millennium Court First Avenue DE14 2WH Burton-On-Trent Doncasters Group Limited Staffordshire United Kingdom | England | British | 164530200005 | |||||
| JACKSON, Howard Watson | Geschäftsführer | Red House Farm CV35 0EB Little Kineton Warwickshire | United Kingdom | British | 34443700002 | |||||
| KAYSER, Michael Arthur | Geschäftsführer | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | 141893610001 | |||||
| LEWIS, Eric James | Geschäftsführer | Rowan House 32 Nursery Lane, Hopwas B78 3AS Tamworth Staffordshire | England | British | 75455450001 | |||||
| MARTLE, Simon David | Geschäftsführer | Bretby Business Park, Ashby Road DE15 0YZ Burton Upon Trent Repton House Staffordshire England | England | British | 151541840002 | |||||
| MOLYNEUX, Ian | Geschäftsführer | Bretby Business Park, Ashby Road DE15 0YZ Burton Upon Trent Repton House Staffordshire England | United Kingdom | British | 75284220004 | |||||
| OXNARD, Lisa Marie | Geschäftsführer | Bretby Business Park, Ashby Road DE15 0YZ Burton Upon Trent Repton House Staffordshire England | England | British | 253562580001 | |||||
| SCHURCH, Michael John | Geschäftsführer | Millennium Court First Avenue DE14 2WH Burton-On-Trent Doncasters Group Limited Staffordshire | England | British | 42065200003 | |||||
| TILLEY, Michael John | Geschäftsführer | Silver Birches 189 Main Street LE67 1AH Thornton Leicestershire | British | 60728390001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doncasters Limited | 06. Apr. 2016 | Killamarsh S21 1BA Sheffield Forge Lane England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Daniel Doncaster & Sons Limited | 06. Apr. 2016 | Bretby Business Park, Ashby Road DE15 0YZ Burton Upon Trent Repton House Staffordshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 06. Sept. 2016 | 28. Feb. 2017 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat DONCASTERS MONK BRIDGE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 04. Mai 2006 Geliefert am 16. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A supplemental composite guarantee and debenture between the company,doncasters limited ("doncasters") and the security agent (the "supplemental deed"). The supplemental deed is supplemental to a composite guarantee and debenture dated 20 august 2001 made between,amongst others,the company,doncasters and the security agent (the "debenture") | Erstellt am 07. Dez. 2001 Geliefert am 18. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies,obligations and liabilities due or to become due from the company to the security agent (as defined) and the other lenders (as defined) in each case pursuant to the common terms agreement,the senior facilities agreement,the mezzanine bridge facility agreement and the ancillary facilities letter (each as defined) and all other monies, obligations and liabilities due,owing and incurred under or pursuant to various other documents and agreements (all as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 20. Aug. 2001 Geliefert am 29. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies, obligations and liabilities from time to time due, owing or incurred by the company to the finance parties or any of them, including, without limitation, all monies, obligations and liabilities due, owing and incurred under or pursuant to the finance documents (all terms as defined). | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Apr. 1999 Geliefert am 27. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due on any account whatsoever from each obligor (as defined) to the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben All rights and benefits under the intercompany convertible bond documents, all group shares as specified in schedule 1 to the form 395 and all dividends and other distributions payable on the group shares and all rights money or property accruing by way of redemption bonus option or otherwise and a floating charge. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0