BLACKWOOD HODGE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BLACKWOOD HODGE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00507019 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BLACKWOOD HODGE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BLACKWOOD HODGE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | First Floor Times Place 45 Pall Mall SW1Y 5GP London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLACKWOOD HODGE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BLACKWOOD HODGE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Konten für ein ruhendes Unternehmen erstellt bis 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AAMD | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas James Tarn am 07. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Richard Russell am 07. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von James Richard Russell als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John King als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 25 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s |
Wer sind die Geschäftsführer von BLACKWOOD HODGE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSSELL, James Richard | Sekretär | 45 Pall Mall SW1Y 5GP London First Floor Times Place | British | 904390002 | ||||||
RUSSELL, James Richard | Geschäftsführer | First Floor Times Place 45 Pall Mall SW1Y 5GP London | England | British | Chartered Secretary | 904390002 | ||||
TARN, Nicholas James | Geschäftsführer | First Floor Times Place 45 Pall Mall SW1Y 5GP London | England | British | Accountant | 113629970001 | ||||
KING, John Alan Gibbs | Sekretär | 10 Ashvale Close Nailsea BS48 1QH Bristol | British | 9313920001 | ||||||
GLEAVE, Clinton John Raymond | Geschäftsführer | 14 Kenneth Crescent Willesden Green NW2 4PT London | England | British | Accountant | 48349150003 | ||||
KING, John Alan Gibbs | Geschäftsführer | 10 Ashvale Close Nailsea BS48 1QH Bristol | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 9313920001 | ||||
LOFTUS, David John | Geschäftsführer | 48 Oakdale Road Downend BS16 6EA Bristol | England | British | Chartered Accountant | 34443080001 | ||||
PETERSEN, Ronald John | Geschäftsführer | Picket Piece Hale Lane Wendover HP22 6NQ Aylesbury Buckinghamshire | England | American | Director | 59083320001 | ||||
SHUTE, Roger Blair | Geschäftsführer | Chase View Winsley BA15 2LX Bradford On Avon Wiltshire | British | Director | 5692100001 | |||||
SUTTON, Howard | Geschäftsführer | High Hedges Elms Cross BA15 2AD Bradford On Avon Wiltshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 48653870001 | ||||
WALKER, Tom Clifford | Geschäftsführer | Hepburn House Frankleigh BA15 2PF Bradford On Avon Wiltshire | British | Director | 34992860002 | |||||
YOUNG, Carleton Adrian | Geschäftsführer | The Old Rectory Castle Combe SN14 7HU Chippenham Wiltshire | British | Chartered Accountant | 36543060001 | |||||
CLAYHILL NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | First Floor Times Place 45 Pall Mall SW1Y 5GP London | 42533440002 | |||||||
GUINNESS PEAT GROUP PLC | Geschäftsführer | First Floor Times Place 45 Pall Mall SW1Y 5GP London | 42533420003 |
Hat BLACKWOOD HODGE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage of shares | Erstellt am 17. Dez. 1993 Geliefert am 05. Jan. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of any finance document or intercompany loans (as defined) | |
Kurze Angaben The shares and dividends as defined. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of shares | Erstellt am 27. Sept. 1993 Geliefert am 18. Okt. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a group facilities agreement dated 21/9/93 the finance documents (as defined) and/or this charge | |
Kurze Angaben Mortgaged pledged and charged the shares to the security trustee (for its own account in its capacity as scurity trustee and as agent and trustee for the benefit of the other finance parties) the same to be a security by way of a first priority pledge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of pledge of registered shares | Erstellt am 27. Sept. 1993 Geliefert am 18. Okt. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the group facilities agreement (as defined) and/or this charge | |
Kurze Angaben The right of pledge in shares including dividend rights,stock bonuses and any other money. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 27. Sept. 1993 Geliefert am 14. Okt. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the finance parties and to the inter-company chargor lenders (each as defined) under the finance documents and under the assigned inter-company loans | |
Kurze Angaben Legal mortgage over certain of the company's real property and over certain of the shares held by it, assignment of company's rights under certain intercompany loans made by it as lender. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Feb. 1990 Geliefert am 13. Feb. 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blackwood hodge PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north west side of hunsbury hill avenue (formerly euclid avenue) northampton northamptonshire title no. Nn 47606. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Feb. 1990 Geliefert am 13. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or blackwood hodge PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Land and offices of hunsbury hill avenue northampton northamptonshire titl no. NN57678. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0