THE OUTDOOR GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE OUTDOOR GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00507794 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE OUTDOOR GROUP LIMITED?
- Einzelhandel mit Bekleidung in spezialisierten Geschäften (47710) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Einzelhandel mit Schuhen in spezialisierten Geschäften (47721) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich THE OUTDOOR GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o KPMG LLP St. James's Square M2 6DS Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE OUTDOOR GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THE OUTDOOR GROUP (TRADING) LIMITED | 05. März 1999 | 05. März 1999 |
| THE OUTDOOR GROUP LIMITED | 05. März 1997 | 05. März 1997 |
| MILLETS LEISURE LIMITED | 12. Jan. 1987 | 12. Jan. 1987 |
| MILLETS OF BRISTOL LIMITED | 25. Okt. 1984 | 25. Okt. 1984 |
| MILLETS OF BRISTOL (HOLDINGS) LIMITED | 09. Mai 1952 | 09. Mai 1952 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE OUTDOOR GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. Feb. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE OUTDOOR GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 0 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 25. Juni 2013 | 22 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Mai 2013 | 23 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Nov. 2012 | 25 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 25 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Juli 2012 | 26 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 43 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 43 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B | 15 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 440-450 Cob Drive Swan Valley Northampton NN4 9BB am 12. Jan. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marcello Lombardo als Geschäftsführer am 16. Dez. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Dominic Joseph Lavelle als Direktor am 21. Nov. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Gillis als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Julia Reynolds als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 39 Seiten | MA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE OUTDOOR GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEACHAM, Mark Derrick | Sekretär | c/o Kpmg Llp St. James's Square M2 6DS Manchester | British | 135313320001 | ||||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | c/o Kpmg Llp St. James's Square M2 6DS Manchester | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| REYNOLDS, Julia | Geschäftsführer | c/o Kpmg Llp St. James's Square M2 6DS Manchester | England | British | 127468460001 | |||||
| FOOT, Peter John Lewis | Sekretär | 1 Normanton Lane Stanford On Soar LE12 5PZ Loughborough Leicestershire | British | 51176110002 | ||||||
| HEATHER, John Langdale | Sekretär | 32 Beauchamp Avenue CV32 5TA Leamington Spa Warwickshire | British | 33307810001 | ||||||
| O'KEEFFE, Mark John | Sekretär | 5 Fowey Close NN8 5WW Wellingborough Northamptonshire | British | 57880430001 | ||||||
| PILLAY, Paul Vijayasingam | Sekretär | 69 Lilleshall Avenue Monkston MK10 9HU Milton Keynes | Other | 79416150001 | ||||||
| REECE, David Alexander | Sekretär | 6 Plough Steep Main Road Itchen Abbas SO21 1BQ Winchester Hampshire | British | 37124410001 | ||||||
| SIMKINS, Paul Charles | Sekretär | 49 Hazel Crescent NN12 6UQ Towcester Northamptonshire | British | 37115350001 | ||||||
| SEARS SPORTS AND LEISUREWEAR PLC | Sekretär | Sunningdale Road LE3 1TP Leicester | 16600870001 | |||||||
| ASTLEY, Brian Martin | Geschäftsführer | Woodend Farmhouse Woodend SL7 2HW Medmenham Buckinghamshire | England | British | 75795040002 | |||||
| ASTLEY, Brian Martin | Geschäftsführer | 25 Marjorie Grove SW11 5SH London | British | 75795040001 | ||||||
| BENTLEY, Simon Anthony | Geschäftsführer | Glen Wood House 5 Cedars Close NW4 1TR London | United Kingdom | British | 3007630001 | |||||
| CLIFFE, Nigel John | Geschäftsführer | 40 Queens Avenue N10 3NR London | British | 60195630001 | ||||||
| COOPER, Andrea | Geschäftsführer | 23b Green Lane Wootton NN4 6LH Northampton | British | 106515750002 | ||||||
| CROSLAND, Roy Nicholson | Geschäftsführer | 35 Addison Avenue W11 4QS London | British | 30882970002 | ||||||
| DAWSON, Nicola Marie | Geschäftsführer | The Greys The Green, Cavendish CO10 8BB Sudbury Suffolk | British | 127468760001 | ||||||
| FALLON, John Edward | Geschäftsführer | Gardeners Cottage Old Hall Drive Widmerpool Keyworth NG12 5PZ Nottingham | British | 52124910001 | ||||||
| FERGUSON, Fiona Claire | Geschäftsführer | Cleveland Cottage Main Street NG23 5BA Claypole Nottinghamshire | British | 55116100001 | ||||||
| FLEMING, Keith | Geschäftsführer | Brookmead House The Warren, East Horsley KT24 5RH Leatherhead Surrey | England | British | 112723440002 | |||||
| FORREST, Annabel | Geschäftsführer | 1 Henderson Road Wandsworth Common SW18 3RR London | British | 85480920001 | ||||||
| FORREST, Annabel Claire | Geschäftsführer | 35 Louisville Road SW17 8RL London | British | 42978640002 | ||||||
| GILLIS, Neil Duncan | Geschäftsführer | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 | England | British | 69204500003 | |||||
| HALL, Andrew James | Geschäftsführer | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | 30306840002 | |||||
| HARDY, Russell Stephen Mons | Geschäftsführer | The Reddings Langley Road, Claverdon CV35 8P Warwick Warwickshire | England | British | 45844210003 | |||||
| HARTLEY, Peter Christopher | Geschäftsführer | 17 Jacobean Lane Knowle B93 9LP Solihull | United Kingdom | British | 96458190001 | |||||
| HERRICK, Susan Elizabeth | Geschäftsführer | 4 Lower Paxton Road AL1 1PG St. Albans Hertfordshire | British | 115256820001 | ||||||
| HITT, Richard John | Geschäftsführer | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 | United Kingdom | British | 127468180001 | |||||
| HOBBS, Sebastian | Geschäftsführer | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 | United Kingdom | British | 124410620002 | |||||
| JOHNSON, Allan | Geschäftsführer | 11 Squarey Street SW17 0AB London | British | 106521530001 | ||||||
| JONES, Anthony David | Geschäftsführer | 32 Howe Lane LE7 7LB Rothley Leicestershire | British | 41640680002 | ||||||
| KERR-MUIR, James Rodier | Geschäftsführer | Flat 8 71 Elm Park Gardens SW10 9QE London | British | 37895700002 | ||||||
| LOASBY, Andrew | Geschäftsführer | 11 Nene Close NN8 5WB Wellingborough Northamptonshire | British | 48081840001 | ||||||
| LOMBARDO, Marcello | Geschäftsführer | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 | England | British | 135699240001 | |||||
| LOVELOCK, Derek John | Geschäftsführer | Oldfields Farm Amersham Road HP9 2UG Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 116560620001 |
Hat THE OUTDOOR GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A rent deposit | Erstellt am 18. Mai 2010 Geliefert am 26. Mai 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The amount from time to time standing to the credit of the tenant in an account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Nov. 2009 Geliefert am 06. Nov. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 18. Feb. 2009 Geliefert am 24. Feb. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 39446298 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 07. Dez. 1999 Geliefert am 14. Dez. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities ( whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of each obligor to the security trustee and the secured parties | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 04. März 1996 Geliefert am 13. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities and obligations due or to become due from the company and any group company to the chargees pursuant to the terms of the hedging arrangements and the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 05. Apr. 1979 Geliefert am 07. Apr. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £35,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee and/or john leopdd spiedmon on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H property known as 3 and 5 king st., Ramsgate kent title no. K 410666. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 05. Dez. 1978 Geliefert am 12. Dez. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H. 9 high street, banbury, oxford. Together with allfixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 15. Nov. 1978 Geliefert am 23. Nov. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land & premises being 2 ainsworth st. Blackburn together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 21. Sept. 1977 Geliefert am 29. Sept. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property known as: 56/57, biggin street, dover together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Apr. 1977 Geliefert am 28. Apr. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H lands & premises being: 205 high street, lewisham, together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Apr. 1977 Geliefert am 28. Apr. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H lands & premises at rear of 205 high street, lewisham, together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Jan. 1977 Geliefert am 03. Feb. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £35,000 | |
Kurze Angaben Shop & other buildings being 104, east street, southampton, hants. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 01. Nov. 1976 Geliefert am 03. Nov. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 31 & 33 friagate walk preston together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 01. Nov. 1976 Geliefert am 03. Nov. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 10I/104 queen street cardiff together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 01. Nov. 1976 Geliefert am 03. Nov. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2, ainsworth street blackburn together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 13. Feb. 1976 Geliefert am 24. Feb. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 19/20 the rhiw bridgent tog. With all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 13. Feb. 1976 Geliefert am 24. Feb. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 102/104 queen street, cardiff tog. With all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 13. Feb. 1976 Geliefert am 03. Nov. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 19/20 the rhiw bridgend together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 18. Sept. 1974 Geliefert am 24. Sept. 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land heredits and premises being 31 & 33 friargate walk, preston (together with all fixtures etc.). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Juli 1973 Geliefert am 09. Aug. 1973 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due, etc. | |
Kurze Angaben Units 9 & 10 the hampshires centre, bournemouth, hants together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Juli 1973 Geliefert am 08. Aug. 1973 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Shop unit no. 2 86/88 above bar street, southampton and all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Juli 1973 Geliefert am 08. Aug. 1973 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 140A commercial street, newport, monmouth and all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Juli 1973 Geliefert am 08. Aug. 1973 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 10 northgate street, gloucester and all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Juli 1973 Geliefert am 08. Aug. 1973 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 the shopping centre, 2 & 3 south street, dorchester and all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Juli 1973 Geliefert am 08. Aug. 1973 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Shop unit no. 2, 5 foee street, poridgwater, somerset and all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat THE OUTDOOR GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0