WGL REALISATIONS 2010 LIMITED

WGL REALISATIONS 2010 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWGL REALISATIONS 2010 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00510283
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    • (2811) /
    • (2875) /
    • (4534) /
    • (5114) /

    Wo befindet sich WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WELCONSTRUCT GROUP LIMITED17. Feb. 200417. Feb. 2004
    GRIMMITT HOLDINGS LIMITED05. Aug. 198805. Aug. 1988
    GRIMMITT FINANCE (HOLDINGS) LIMITED21. Juni 198221. Juni 1982
    WELCONSTRUCT COMPANY LIMITED(THE)02. Aug. 195202. Aug. 1952

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2015

    20 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2014

    20 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2013

    21 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2012

    22 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2012

    7 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. März 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2011

    24 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    24 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2011

    6 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    22 Seiten2.34B

    Beendigung der Bestellung von Frank Lewis als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    21 Seiten2.34B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed welconstruct group LIMITED\certificate issued on 10/08/10
    2 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name10. Aug. 2010

    Beschluss zur Änderung der Firma am 04. Okt. 2009

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Wer sind die Geschäftsführer von WGL REALISATIONS 2010 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MOORE, Duncan James, Mr.
    Atherstone-On-Stour
    CV37 8NE Stratford On Avon
    River House
    Warwickshire
    Sekretär
    Atherstone-On-Stour
    CV37 8NE Stratford On Avon
    River House
    Warwickshire
    BritishCompany Director78671940004
    KENRICK, Christine
    September House
    DY10 4QE Wood Row
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    September House
    DY10 4QE Wood Row
    Worcestershire
    BritishChairman9905930005
    MOORE, Duncan James, Mr.
    Atherstone-On-Stour
    CV37 8NE Stratford On Avon
    River House
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Atherstone-On-Stour
    CV37 8NE Stratford On Avon
    River House
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director78671940004
    REEVE, Adrian
    Stone Meadow
    OX2 6TD Oxford
    95
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Stone Meadow
    OX2 6TD Oxford
    95
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director91896330002
    EVERITT, David William
    4 Swale Road
    Walmley
    B76 2BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    4 Swale Road
    Walmley
    B76 2BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British2262790003
    CHASE, Catherine Elizabeth
    43 Pembroke Croft
    B28 9EY Birmingham
    Geschäftsführer
    43 Pembroke Croft
    B28 9EY Birmingham
    BritishNon Executive Director38992660001
    COLLINS, David
    Woodcot Lawnswood Drive
    Lawnswood
    DY7 5QW Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Woodcot Lawnswood Drive
    Lawnswood
    DY7 5QW Stourbridge
    West Midlands
    BritishNon Executive Director9054250001
    DAVIES, David Charles
    8 Church Lane
    Westbere
    CT2 0HA Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    8 Church Lane
    Westbere
    CT2 0HA Canterbury
    Kent
    BritishNon Executive Director43095130001
    DICKINS, Paul
    86 London Road
    DN22 7DX Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    86 London Road
    DN22 7DX Retford
    Nottinghamshire
    BritishNon Executive Director62756170002
    EVERITT, David William
    4 Swale Road
    Walmley
    B76 2BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    4 Swale Road
    Walmley
    B76 2BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishAccountant2262790003
    FISHER, Michael George
    27 Beechwood Road
    Hollywood Grange
    B47 5QS Wythall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    27 Beechwood Road
    Hollywood Grange
    B47 5QS Wythall
    West Midlands
    BritishProject Sales Director11494270001
    HUMPHREYS, Christopher John
    16 Medici Road
    B60 2RL Bromsgrove
    Geschäftsführer
    16 Medici Road
    B60 2RL Bromsgrove
    EnglandBritishCompany Director47664530002
    HYLAND, Peter Bernard
    44 Huntlands Road
    B63 4LZ Halesowen
    West Midlands
    Geschäftsführer
    44 Huntlands Road
    B63 4LZ Halesowen
    West Midlands
    United KingdomBritishDirectors12329320001
    LEWIS, Frank
    14 Franklin Close
    N20 9QG Whetstone
    London
    Geschäftsführer
    14 Franklin Close
    N20 9QG Whetstone
    London
    United KingdomBritishCompany Director55302020001
    OWEN, Alfred David
    Mill Dam House Mill Lane
    Aldridge
    WS9 0NB Walsall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Mill Dam House Mill Lane
    Aldridge
    WS9 0NB Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishNon Executive Director7038720001
    QUIGLEY, Peter
    Sugars Farm Sugars Lane
    Rock
    DY14 9UW Kidderminster
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Sugars Farm Sugars Lane
    Rock
    DY14 9UW Kidderminster
    Worcestershire
    BritishNon Executive Director7981680001
    SYKES, John Stuart
    Chantry Farm House
    Thorney Lanes, Hoar Cross
    DE13 8QT Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Chantry Farm House
    Thorney Lanes, Hoar Cross
    DE13 8QT Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishMarketing Director11494260002
    WELCH, Marjorie Eileen
    43 Wellington Road
    Edgbaston
    B15 2EP Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    43 Wellington Road
    Edgbaston
    B15 2EP Birmingham
    West Midlands
    BritishNon Executive Director13387380001
    WELCH, Patrick William
    43 Wellington Road
    Edgbaston
    B15 2EP Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    43 Wellington Road
    Edgbaston
    B15 2EP Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishChairman11153750001

    Hat WGL REALISATIONS 2010 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge of deposit
    Erstellt am 11. Jan. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now or in the future credited to account designated 10363484 and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or part from such deposits or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 2006
    Geliefert am 08. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 31. Jan. 2006
    Geliefert am 07. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Pimesco E3/15N 3 wheel truck komatsu MWS10-1R (pedestrian) paint spray kit for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Dickins (The Security Trustee) as Security Trustee for the Noteholders
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 2006
    Geliefert am 07. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Dickins (The Security Trustee) as Security Trustee for the Noteholders
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Jan. 2006
    Geliefert am 07. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 112 greenfell mansions,glaisher street,millenium quay,london.t/n TGL212374 by way of fixed charge and all rents and proceeds of any insurance from time to time and by way of assignment all right to the interest and any rental income.
    Berechtigte Personen
    • Welconstruct Pension & Life Assurance Scheme
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage deed
    Erstellt am 16. Okt. 2002
    Geliefert am 29. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property being plot 412,millennium quays,london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 14. März 1996
    Geliefert am 26. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Juli 1995
    Geliefert am 04. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-124/136 nathan way, thamesmead london t/nos. TGL100878 and LN137615 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Juli 1995
    Geliefert am 04. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-unit 25, pedmore road industrial estate pedmore road dudley west midlands t/n-WM67148 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Juli 1995
    Geliefert am 04. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-land and buildings on the south side of timmis road lye stourbridge dudley west midlands t/n-WM273033 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Juli 1995
    Geliefert am 04. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-land lying on the west side of stafford park, 13 stafford park telford the wrekin, shropshire t/n-SL50763 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Juli 1995
    Geliefert am 04. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-land and buildings on the south side of timms road lye stourbridge dudley west midlands t/n-WM324848 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 27. Feb. 1991
    Geliefert am 28. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Britannia works, ladon road, mirelin in marsh gloucestershire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 17. Mai 1983
    Geliefert am 25. Mai 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1983Registrierung einer Belastung
    • 13. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Dez. 1974
    Geliefert am 10. Jan. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Britannia works moreton in the marsh gloucestershire.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1975Registrierung einer Belastung
    • 02. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 31. Dez. 1974
    Geliefert am 10. Jan. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property in kingston works station rd acocks gn burmingham west midlands.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1975Registrierung einer Belastung
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Dez. 1974
    Geliefert am 10. Jan. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    75/83 brealey street newtown birmingham west midlands.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank LTD
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1975Registrierung einer Belastung
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1974
    Geliefert am 10. Jan. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital together with fixed plant & machinery (see doc 52).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1975Registrierung einer Belastung
    • 13. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WGL REALISATIONS 2010 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Sept. 2010Ende der Verwaltung
    10. Sept. 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praktiker
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Richard James Philpott
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    2
    DatumTyp
    10. Jan. 2017Aufgelöst am
    03. Sept. 2010Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard James Philpott
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0