HIWAVE TECHNOLOGIES PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHIWAVE TECHNOLOGIES PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 00514718
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?

    • Andere Forschung und experimentelle Entwicklung in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen (72190) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NXT PLC02. Nov. 199802. Nov. 1998
    VERITY GROUP PLC16. Okt. 199216. Okt. 1992
    WHARFEDALE PLC19. Jan. 199019. Jan. 1990
    AUDIO FIDELITY PUBLIC LIMITED COMPANY31. Dez. 195231. Dez. 1952

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 02. Sept. 2015

    30 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Juli 2015

    30 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Jan. 2015

    30 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Geoffrey Martin & Co 7-8 Conduit Street London W1S 2XF zum 1 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HD am 28. Jan. 2015

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Juli 2014

    31 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Jan. 2014

    32 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Sept. 2013

    36 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    2 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    3 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B

    110 Seiten2.16B

    legacy

    3 SeitenMG02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the 1840 Barn Fullers Hill Road Little Gransden Sandy Cambridgeshire SG19 3BP England* am 12. März 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2013 ohne Mitgliederliste

    17 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. März 2013

    Kapitalaufstellung am 04. März 2013

    • Kapital: GBP 2,694,890,271
    SH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Regus House 1010 Cambourne Business Park Cambourne Cambridge CB23 6DP* am 17. Jan. 2013

    1 SeitenAD01

    legacy

    7 SeitenMG01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung von Mr Graham William Searle als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Bainbridge Mcintosh als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Edward Simpson als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Katherine Barnes als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Katherine Barnes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SIMPSON, Edward
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    Sekretär
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    170376500001
    CALDERWOOD, David James Anderson
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    Geschäftsführer
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    EnglandBritishDirector29739000004
    LEWIS, James Edwin
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    Geschäftsführer
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    EnglandBritishCompany Director109305180001
    MAYNE, Clive Leonard
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    Geschäftsführer
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    EnglandBritishDirector46386850001
    MCINTOSH, David Bainbridge
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    Geschäftsführer
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    United KingdomBritishDirector89504740001
    SEARLE, Graham William
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    Geschäftsführer
    Westferry Circus
    Canary Wharf
    E14 4HD London
    1
    United KingdomNew ZealandDirector7192420001
    BARNES, Katherine Victoria
    76 Woodfield Lane
    Lower Cambourne
    CB23 6DS Cambridge
    Sekretär
    76 Woodfield Lane
    Lower Cambourne
    CB23 6DS Cambridge
    BritishChartered Accountant123301690001
    DRYSDALE, Brian Douglas
    Corrie Mhor
    Dollerie
    PH7 3NX Crieff
    Perthshire
    Sekretär
    Corrie Mhor
    Dollerie
    PH7 3NX Crieff
    Perthshire
    British65843060001
    JONES, Robert Edward
    Swallows Hill Fredley Park
    Mickleham
    RH5 6DD Dorking
    Surrey
    Sekretär
    Swallows Hill Fredley Park
    Mickleham
    RH5 6DD Dorking
    Surrey
    British5141990001
    THOMS, Peter Young
    2 Park Road
    Flat B, 6th Floor
    Mid Level
    Hong Kong
    China
    Sekretär
    2 Park Road
    Flat B, 6th Floor
    Mid Level
    Hong Kong
    China
    BritishChartered Accountant19514010002
    AZIMA, Farad
    5 Tasker Lodge
    Thornwood Gardens
    W8 7ER London
    Geschäftsführer
    5 Tasker Lodge
    Thornwood Gardens
    W8 7ER London
    United KingdomBritishCompany Director118718940001
    AZIMA, Firouz Henry
    3 Southacre Close
    Chaucer Road
    CB2 2TT Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    3 Southacre Close
    Chaucer Road
    CB2 2TT Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishChief Technology Officer99914080001
    BARKATAKI, Dwijendra Chandra
    43 Cambridge Road
    Little Abingdon
    CB1 6BL Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    43 Cambridge Road
    Little Abingdon
    CB1 6BL Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishAccountant44859750001
    BARNES, Katherine Victoria
    76 Woodfield Lane
    Lower Cambourne
    CB23 6DS Cambridge
    Geschäftsführer
    76 Woodfield Lane
    Lower Cambourne
    CB23 6DS Cambridge
    EnglandBritishChartered Accountant123301690001
    BATCHELOR, Lance
    Ashland House
    RG20 4UW North Sydmonton
    Hants
    Geschäftsführer
    Ashland House
    RG20 4UW North Sydmonton
    Hants
    BritishCompany Director111951550001
    BRAMWELL, David Matthew
    Regus House
    1010 Cambourne Business Park
    CB23 6DP Cambourne
    Cambridge
    Geschäftsführer
    Regus House
    1010 Cambourne Business Park
    CB23 6DP Cambourne
    Cambridge
    EnglandBritishCompany Director4250980001
    BRUNTON, Gordon Charles, Sir
    North Munstead Stud Farm
    North Munstead Lane
    GU8 4AX Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    North Munstead Stud Farm
    North Munstead Lane
    GU8 4AX Godalming
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director573250001
    BUCKLEY, Ian Michael
    Fox Cottage
    Headfoldswood
    RH14 0SY Loxwood
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Fox Cottage
    Headfoldswood
    RH14 0SY Loxwood
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant61303010001
    DAVID, Philip
    58 Chester Square
    SW1W 9EA London
    Geschäftsführer
    58 Chester Square
    SW1W 9EA London
    EnglandAmericanCompany Director37201330001
    DOUGHTY, Tony William
    Cobblers Cottage
    9 Clements Gate Diseworth
    DE74 2QE Derby
    N.W Leicestershire
    Geschäftsführer
    Cobblers Cottage
    9 Clements Gate Diseworth
    DE74 2QE Derby
    N.W Leicestershire
    BritishCompany Director41786120001
    DOUGHTY, Tony William
    Temple Court The Hill
    Freshford
    BA3 6EG Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    Temple Court The Hill
    Freshford
    BA3 6EG Bath
    Avon
    BritishBusiness Consultant41786120002
    DRYSDALE, Brian Douglas
    Corrie Mhor
    Dollerie
    PH7 3NX Crieff
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Corrie Mhor
    Dollerie
    PH7 3NX Crieff
    Perthshire
    BritishCompany Director65843060001
    EDELS, Sydney
    Apartment 5 Bridgemere House
    Mosseley Hill Drive
    L17 0ET Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Apartment 5 Bridgemere House
    Mosseley Hill Drive
    L17 0ET Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishCompany Director113234790001
    FREW, Anita Margaret
    51 Elystan Place
    Chelsea
    SW3 3JY London
    Geschäftsführer
    51 Elystan Place
    Chelsea
    SW3 3JY London
    United KingdomBritishCompany Director24689070002
    GOWRIE, Alexander, Lord
    13 Pembroke Studios
    Pembroke Gardens
    W8 6HX London
    Geschäftsführer
    13 Pembroke Studios
    Pembroke Gardens
    W8 6HX London
    United KingdomBritishCompany Director83438000001
    HAIGH, Helen
    21 Park Place
    Roundhay
    LS1 2SL Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    21 Park Place
    Roundhay
    LS1 2SL Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director23777720001
    KNOX, Anthony Douglas
    Pound Cottage The Street
    West Clandon
    GU4 7TG Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Pound Cottage The Street
    West Clandon
    GU4 7TG Guildford
    Surrey
    BritishPrivate Equity17534760002
    LAU, Wing Hung Johnny
    26 Price Road
    Jardines Lookout
    FOREIGN Hong Kong
    Geschäftsführer
    26 Price Road
    Jardines Lookout
    FOREIGN Hong Kong
    SingaporeanMerchant36991860001
    MACKAY, David Nigel
    Tilbrook Manor
    Station Road
    PE28 0JT Tilbrook
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Tilbrook Manor
    Station Road
    PE28 0JT Tilbrook
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director61423400002
    MELLORS, Keith Michael
    Woodlands Hall
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Woodlands Hall
    West Avenue
    LS8 2JN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director40983870001
    OWEN, Gordon Michael William
    Sutton End House
    RH20 1PY Sutton
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Sutton End House
    RH20 1PY Sutton
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director76695740003
    PEARSON, David Charles
    9 The Warren
    AL5 2NH Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    9 The Warren
    AL5 2NH Harpenden
    Hertfordshire
    UkUkChief Executive60337060001
    RYAN, Graham Christopher
    Eaton House
    100 Blue Pool Road
    KT12 4AP Happy Valley
    Hong Kong
    China
    Geschäftsführer
    Eaton House
    100 Blue Pool Road
    KT12 4AP Happy Valley
    Hong Kong
    China
    BritishChief Commercial Officer105380160002
    STEINER, Bernhard Franz Josef, Dr
    Rossbach Hohe 24
    65232 Taunusstein-Seitzenhahn
    Germany
    Geschäftsführer
    Rossbach Hohe 24
    65232 Taunusstein-Seitzenhahn
    Germany
    ItalianDirector40553490004
    THOMS, Peter Young
    2 Park Road
    Flat B, 6th Floor
    Mid Level
    Hong Kong
    China
    Geschäftsführer
    2 Park Road
    Flat B, 6th Floor
    Mid Level
    Hong Kong
    China
    Hong KongBritishChartered Accountant19514010002

    Hat HIWAVE TECHNOLOGIES PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over shares
    Erstellt am 18. Dez. 2012
    Geliefert am 27. Dez. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the rights which it had at the date of the deed and all of the rights which it obtains at any time thereafter in: the shares; any rights accruing to, derived from or otherwise connected with the shares (including dividends and proceeds of disposal); and any warrants, options and other rights to subscribe for or otherwise acquire shares. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bms Finance Ab Limited
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 20. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 16. Sept. 2009
    Geliefert am 24. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Sept. 2007
    Geliefert am 18. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A fixed charge of the intellectual property rights being the patents and patentapplications, for details of property ch. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr Robert Walters (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A credit agreement entitled "prompt credit application
    Erstellt am 09. Sept. 1991
    Geliefert am 18. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £5399.68 being the total amount payable by the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance. (Please see M395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 01. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Dez. 1990
    Geliefert am 03. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All stocks shares bonds and securities of any kind please see 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Aesop Fund LP.
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 26. Jan. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Letter of offset
    Erstellt am 19. Dez. 1990
    Geliefert am 29. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly fanfare voiceover limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The balances at credit of any accounts and held by the governor and company of the bank of scotland in name of wharfedale PLC.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of offset
    Erstellt am 24. Apr. 1990
    Geliefert am 10. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from wharfedale group lomited and/or palmers limited and/or coppin crest limited and/or wharfedale loudspeakers limited and/or fane acoustics limited and/or mckenzie acoustics limited and/or fanfare electronics limited
    Kurze Angaben
    The balances of credit of any accounts held by chargee in name of company.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transaktionen
    • 10. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Apr. 1990
    Geliefert am 10. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transaktionen
    • 10. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 13. Sept. 1994Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 05. Apr. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 19. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 20. Apr. 1990
    Geliefert am 09. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies due from time to time by virtue of an agreement dated 6.11.89. (see 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transaktionen
    • 09. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 15. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment
    Erstellt am 20. Apr. 1990
    Geliefert am 09. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies due from time to time by virtue of a guarantee dated 15.1.90. (see 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transaktionen
    • 09. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Okt. 1989
    Geliefert am 30. Okt. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Park lorne, park rd, st marylebone demised to mortgagor under a lease dated 8.7.88 and/or the proceeds of sale thereof and all buildings fixtures thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Privatbanken Limited.
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1989Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 13. Okt. 1989
    Geliefert am 30. Okt. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that land at buildings at hick lane, batley and 286 bradford road, batley. T/no. Wyk 281092 & wyk 281093 all buildings fixtures thereon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Privatbanken Limited
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1989Registrierung einer Belastung
    Memorandum of deposit and charge over securities
    Erstellt am 11. Juli 1989
    Geliefert am 28. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee subject to the terms and conditions of a facility letter dated 19 6 89 and any supplemental facility letters
    Kurze Angaben
    All bonds stocks shares & securities in fanfare group PLC, fanfare electronics LTD, fanfare books LTD, fanfare voiceover LTD, fanfare marketing LTD, captain billy's music LTD, realistic sound centres LTD and fane accoustics or their successors in title (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Privatbanken Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 1989
    Geliefert am 28. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Privatbanken Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 06. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Park lorne 111 park road regents park l/b of city of westminster.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 15. Juni 1988
    Geliefert am 22. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Juni 1987
    Geliefert am 19. Juni 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 1987Registrierung einer Belastung
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Apr. 1984
    Geliefert am 10. Apr. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1984Registrierung einer Belastung

    Hat HIWAVE TECHNOLOGIES PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. März 2013Beginn der Verwaltung
    02. Sept. 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Sleight
    7-8 Conduit Street
    W1S 2XF London
    Praktiker
    7-8 Conduit Street
    W1S 2XF London
    Peter Hart
    7-8 Conduit Street
    W1S 2XF London
    Praktiker
    7-8 Conduit Street
    W1S 2XF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0