HIWAVE TECHNOLOGIES PLC
Überblick
Unternehmensname | HIWAVE TECHNOLOGIES PLC |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Unternehmensnummer | 00514718 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?
- Andere Forschung und experimentelle Entwicklung in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen (72190) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Westferry Circus Canary Wharf E14 4HD London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
NXT PLC | 02. Nov. 1998 | 02. Nov. 1998 |
VERITY GROUP PLC | 16. Okt. 1992 | 16. Okt. 1992 |
WHARFEDALE PLC | 19. Jan. 1990 | 19. Jan. 1990 |
AUDIO FIDELITY PUBLIC LIMITED COMPANY | 31. Dez. 1952 | 31. Dez. 1952 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2011 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 02. Sept. 2015 | 30 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Juli 2015 | 30 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Jan. 2015 | 30 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Geoffrey Martin & Co 7-8 Conduit Street London W1S 2XF zum 1 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HD am 28. Jan. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Juli 2014 | 31 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Jan. 2014 | 32 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Sept. 2013 | 36 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 2 Seiten | 2.23B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 3 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B | 110 Seiten | 2.16B | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * the 1840 Barn Fullers Hill Road Little Gransden Sandy Cambridgeshire SG19 3BP England* am 12. März 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2013 ohne Mitgliederliste | 17 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Regus House 1010 Cambourne Business Park Cambourne Cambridge CB23 6DP* am 17. Jan. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Graham William Searle als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Bainbridge Mcintosh als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Edward Simpson als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katherine Barnes als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katherine Barnes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HIWAVE TECHNOLOGIES PLC?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPSON, Edward | Sekretär | Westferry Circus Canary Wharf E14 4HD London 1 | 170376500001 | |||||||
CALDERWOOD, David James Anderson | Geschäftsführer | Westferry Circus Canary Wharf E14 4HD London 1 | England | British | Director | 29739000004 | ||||
LEWIS, James Edwin | Geschäftsführer | Westferry Circus Canary Wharf E14 4HD London 1 | England | British | Company Director | 109305180001 | ||||
MAYNE, Clive Leonard | Geschäftsführer | Westferry Circus Canary Wharf E14 4HD London 1 | England | British | Director | 46386850001 | ||||
MCINTOSH, David Bainbridge | Geschäftsführer | Westferry Circus Canary Wharf E14 4HD London 1 | United Kingdom | British | Director | 89504740001 | ||||
SEARLE, Graham William | Geschäftsführer | Westferry Circus Canary Wharf E14 4HD London 1 | United Kingdom | New Zealand | Director | 7192420001 | ||||
BARNES, Katherine Victoria | Sekretär | 76 Woodfield Lane Lower Cambourne CB23 6DS Cambridge | British | Chartered Accountant | 123301690001 | |||||
DRYSDALE, Brian Douglas | Sekretär | Corrie Mhor Dollerie PH7 3NX Crieff Perthshire | British | 65843060001 | ||||||
JONES, Robert Edward | Sekretär | Swallows Hill Fredley Park Mickleham RH5 6DD Dorking Surrey | British | 5141990001 | ||||||
THOMS, Peter Young | Sekretär | 2 Park Road Flat B, 6th Floor Mid Level Hong Kong China | British | Chartered Accountant | 19514010002 | |||||
AZIMA, Farad | Geschäftsführer | 5 Tasker Lodge Thornwood Gardens W8 7ER London | United Kingdom | British | Company Director | 118718940001 | ||||
AZIMA, Firouz Henry | Geschäftsführer | 3 Southacre Close Chaucer Road CB2 2TT Cambridge Cambridgeshire | British | Chief Technology Officer | 99914080001 | |||||
BARKATAKI, Dwijendra Chandra | Geschäftsführer | 43 Cambridge Road Little Abingdon CB1 6BL Cambridge Cambridgeshire | British | Accountant | 44859750001 | |||||
BARNES, Katherine Victoria | Geschäftsführer | 76 Woodfield Lane Lower Cambourne CB23 6DS Cambridge | England | British | Chartered Accountant | 123301690001 | ||||
BATCHELOR, Lance | Geschäftsführer | Ashland House RG20 4UW North Sydmonton Hants | British | Company Director | 111951550001 | |||||
BRAMWELL, David Matthew | Geschäftsführer | Regus House 1010 Cambourne Business Park CB23 6DP Cambourne Cambridge | England | British | Company Director | 4250980001 | ||||
BRUNTON, Gordon Charles, Sir | Geschäftsführer | North Munstead Stud Farm North Munstead Lane GU8 4AX Godalming Surrey | England | British | Company Director | 573250001 | ||||
BUCKLEY, Ian Michael | Geschäftsführer | Fox Cottage Headfoldswood RH14 0SY Loxwood West Sussex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 61303010001 | ||||
DAVID, Philip | Geschäftsführer | 58 Chester Square SW1W 9EA London | England | American | Company Director | 37201330001 | ||||
DOUGHTY, Tony William | Geschäftsführer | Cobblers Cottage 9 Clements Gate Diseworth DE74 2QE Derby N.W Leicestershire | British | Company Director | 41786120001 | |||||
DOUGHTY, Tony William | Geschäftsführer | Temple Court The Hill Freshford BA3 6EG Bath Avon | British | Business Consultant | 41786120002 | |||||
DRYSDALE, Brian Douglas | Geschäftsführer | Corrie Mhor Dollerie PH7 3NX Crieff Perthshire | British | Company Director | 65843060001 | |||||
EDELS, Sydney | Geschäftsführer | Apartment 5 Bridgemere House Mosseley Hill Drive L17 0ET Liverpool Merseyside | England | British | Company Director | 113234790001 | ||||
FREW, Anita Margaret | Geschäftsführer | 51 Elystan Place Chelsea SW3 3JY London | United Kingdom | British | Company Director | 24689070002 | ||||
GOWRIE, Alexander, Lord | Geschäftsführer | 13 Pembroke Studios Pembroke Gardens W8 6HX London | United Kingdom | British | Company Director | 83438000001 | ||||
HAIGH, Helen | Geschäftsführer | 21 Park Place Roundhay LS1 2SL Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 23777720001 | |||||
KNOX, Anthony Douglas | Geschäftsführer | Pound Cottage The Street West Clandon GU4 7TG Guildford Surrey | British | Private Equity | 17534760002 | |||||
LAU, Wing Hung Johnny | Geschäftsführer | 26 Price Road Jardines Lookout FOREIGN Hong Kong | Singaporean | Merchant | 36991860001 | |||||
MACKAY, David Nigel | Geschäftsführer | Tilbrook Manor Station Road PE28 0JT Tilbrook Cambridgeshire | British | Company Director | 61423400002 | |||||
MELLORS, Keith Michael | Geschäftsführer | Woodlands Hall West Avenue LS8 2JN Leeds West Yorkshire | England | British | Company Director | 40983870001 | ||||
OWEN, Gordon Michael William | Geschäftsführer | Sutton End House RH20 1PY Sutton West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 76695740003 | ||||
PEARSON, David Charles | Geschäftsführer | 9 The Warren AL5 2NH Harpenden Hertfordshire | Uk | Uk | Chief Executive | 60337060001 | ||||
RYAN, Graham Christopher | Geschäftsführer | Eaton House 100 Blue Pool Road KT12 4AP Happy Valley Hong Kong China | British | Chief Commercial Officer | 105380160002 | |||||
STEINER, Bernhard Franz Josef, Dr | Geschäftsführer | Rossbach Hohe 24 65232 Taunusstein-Seitzenhahn Germany | Italian | Director | 40553490004 | |||||
THOMS, Peter Young | Geschäftsführer | 2 Park Road Flat B, 6th Floor Mid Level Hong Kong China | Hong Kong | British | Chartered Accountant | 19514010002 |
Hat HIWAVE TECHNOLOGIES PLC Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge over shares | Erstellt am 18. Dez. 2012 Geliefert am 27. Dez. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the rights which it had at the date of the deed and all of the rights which it obtains at any time thereafter in: the shares; any rights accruing to, derived from or otherwise connected with the shares (including dividends and proceeds of disposal); and any warrants, options and other rights to subscribe for or otherwise acquire shares. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Sept. 2009 Geliefert am 24. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Sept. 2007 Geliefert am 18. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A fixed charge of the intellectual property rights being the patents and patentapplications, for details of property ch. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A credit agreement entitled "prompt credit application | Erstellt am 09. Sept. 1991 Geliefert am 18. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £5399.68 being the total amount payable by the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement | |
Kurze Angaben All its right, title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance. (Please see M395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Dez. 1990 Geliefert am 03. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All stocks shares bonds and securities of any kind please see 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of offset | Erstellt am 19. Dez. 1990 Geliefert am 29. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly fanfare voiceover limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben The balances at credit of any accounts and held by the governor and company of the bank of scotland in name of wharfedale PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of offset | Erstellt am 24. Apr. 1990 Geliefert am 10. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from wharfedale group lomited and/or palmers limited and/or coppin crest limited and/or wharfedale loudspeakers limited and/or fane acoustics limited and/or mckenzie acoustics limited and/or fanfare electronics limited | |
Kurze Angaben The balances of credit of any accounts held by chargee in name of company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Apr. 1990 Geliefert am 10. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment | Erstellt am 20. Apr. 1990 Geliefert am 09. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies due from time to time by virtue of an agreement dated 6.11.89. (see 395 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment | Erstellt am 20. Apr. 1990 Geliefert am 09. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies due from time to time by virtue of a guarantee dated 15.1.90. (see 395 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 13. Okt. 1989 Geliefert am 30. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Park lorne, park rd, st marylebone demised to mortgagor under a lease dated 8.7.88 and/or the proceeds of sale thereof and all buildings fixtures thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 13. Okt. 1989 Geliefert am 30. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that land at buildings at hick lane, batley and 286 bradford road, batley. T/no. Wyk 281092 & wyk 281093 all buildings fixtures thereon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of deposit and charge over securities | Erstellt am 11. Juli 1989 Geliefert am 28. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee subject to the terms and conditions of a facility letter dated 19 6 89 and any supplemental facility letters | |
Kurze Angaben All bonds stocks shares & securities in fanfare group PLC, fanfare electronics LTD, fanfare books LTD, fanfare voiceover LTD, fanfare marketing LTD, captain billy's music LTD, realistic sound centres LTD and fane accoustics or their successors in title (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Juli 1989 Geliefert am 28. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Jan. 1989 Geliefert am 06. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Park lorne 111 park road regents park l/b of city of westminster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 15. Juni 1988 Geliefert am 22. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 03. Juni 1987 Geliefert am 19. Juni 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 03. Apr. 1984 Geliefert am 10. Apr. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat HIWAVE TECHNOLOGIES PLC Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0