CAMEC (CREDIT) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCAMEC (CREDIT) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00516085
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CAMEC (CREDIT) LIMITED?

    • Glücksspiel- und Wettbetriebe (92000) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich CAMEC (CREDIT) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KPMG LLP
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CAMEC (CREDIT) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MECCA BOOKMAKERS (CREDIT) LIMITED19. Jan. 198819. Jan. 1988
    WM. MCKEOWN & CO. LIMITED13. Feb. 195313. Feb. 1953

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAMEC (CREDIT) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für CAMEC (CREDIT) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Greenside House 50 Station Road Wood Green London N22 7TP am 17. Apr. 2012

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. März 2012

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 20. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 654
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Neil Cooper als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Simon Lane als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Jan. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Dez. 2006

    4 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    5 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von CAMEC (CREDIT) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    READ, Dennis
    Greenside House
    50 Station Road Wood Green
    N22 7TP London
    Sekretär
    Greenside House
    50 Station Road Wood Green
    N22 7TP London
    British125938390001
    COOPER, Neil
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Greenside House
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector151902940001
    STEELE, Anthony David
    Greenside House
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Geschäftsführer
    Greenside House
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    United KingdomBritishChartered Surveyor193930220001
    ANDERSON, Sarah
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Sekretär
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    British100326820003
    BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    Sekretär
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    British63851130001
    HOGAN, Kevin Matthew Joseph Christopher
    Willow House
    121 Upper Hoyland Road
    S74 9NL Hoyland
    South Yorkshire
    Sekretär
    Willow House
    121 Upper Hoyland Road
    S74 9NL Hoyland
    South Yorkshire
    British4502520001
    MACQUEEN, Andrea Louise
    10 Eglington Road
    Chingford
    E4 7AN London
    Sekretär
    10 Eglington Road
    Chingford
    E4 7AN London
    British98483080001
    MOTT, Matthew John Spencer
    25 Princess Court
    105 Hornsey Lane Highgate
    N6 5XD London
    Sekretär
    25 Princess Court
    105 Hornsey Lane Highgate
    N6 5XD London
    BritishCompany Secretary19710010002
    BROWN, John Michael
    Milford Court Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    Geschäftsführer
    Milford Court Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    BritishCompany Director889800001
    HAYGARTH, William Leslie
    9 Hillside
    Burghfield Common
    RG7 3BQ Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    9 Hillside
    Burghfield Common
    RG7 3BQ Reading
    Berkshire
    BritishDirector11592110002
    LAMBERT, Robert
    Red Roof
    Tithe Barn Lane, Bardsey
    LS17 9DX Wetherby
    Geschäftsführer
    Red Roof
    Tithe Barn Lane, Bardsey
    LS17 9DX Wetherby
    United KingdomBritishChartered Accountant153968320001
    LANE, Simon Paul
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Geschäftsführer
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    BritishDirector117893540001
    MCGUIGAN, Liam John
    9 Park Drive
    Thorntonhall
    G74 5AS Glasgow
    Geschäftsführer
    9 Park Drive
    Thorntonhall
    G74 5AS Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director62685050001
    NORRIS, Michael William
    9 Highthorne Court
    Shadwell
    LS17 8NW Leeds
    Geschäftsführer
    9 Highthorne Court
    Shadwell
    LS17 8NW Leeds
    BritishCompany Director71004120002
    OLIVE, Stephen Gerard
    4 High Park Road
    Kew
    TW9 4BH Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 High Park Road
    Kew
    TW9 4BH Richmond
    Surrey
    BritishDirector38206770002
    SINGER, Thomas Daniel
    27 Observatory Road
    SW14 7QB East Sheen
    London
    Geschäftsführer
    27 Observatory Road
    SW14 7QB East Sheen
    London
    BritishCompany Director63386730002
    SPEARING, Ian John
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Geschäftsführer
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    BritishDirector34180750003
    WASANI, Shailen
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Geschäftsführer
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    BritishAccountant102956140003

    Hat CAMEC (CREDIT) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 15. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of this deed,the facility or the charge (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The William Hill Group Limited
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • William Hill Organization Limited
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank Plcaries(As Defined)as Agent and Trustee for Itself and the Benefici
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The William Hill Group Limited
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 03. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of clause 2 of the deed asdefined in this charge
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M203 for full details. All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of guarantee and charge
    Erstellt am 21. Dez. 1989
    Geliefert am 10. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all freehold and leasehold property and rights. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of guarantee and charge
    Erstellt am 21. Dez. 1989
    Geliefert am 10. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all freehold and leasehold property and rights. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limitedas Defined)(As Trustee for Itself and for the Other Banks,
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 14. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CAMEC (CREDIT) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Okt. 2012Aufgelöst am
    30. März 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0