EP PACKAGING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EP PACKAGING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00516832 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EP PACKAGING LIMITED?
- (2522) /
Wo befindet sich EP PACKAGING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Beaufort House 94-96 Newhall Street B3 1PB Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EP PACKAGING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LOWFIELD SECURITIES LIMITED | 15. Mai 1984 | 15. Mai 1984 |
| LOWFIELD LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
| ARTHUR WOOLLACOTT LIMITED | 07. März 1953 | 07. März 1953 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EP PACKAGING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2006 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EP PACKAGING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 3 Seiten | 4.72 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Aug. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Feb. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:sos cert release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:- replacement of liquidator | 30 Seiten | LIQ MISC OC | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 7 Seiten | 2.34B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 4 Seiten | 2.16B | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 2 Seiten | 2.23B | ||
Vorschlag des Verwalters | 29 Seiten | 2.17B | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 17 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
Wer sind die Geschäftsführer von EP PACKAGING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMAS, Emma Jane | Sekretär | 27 Hanbury Green Shobdon HR6 9NS Leominster Herefordshire | British | 123204420001 | ||||||
| MONDON, Peter Nigel | Geschäftsführer | Keepers Cottage Colemore Green WV16 4ST Bridgnorth Shropshire | England | British | 51801010002 | |||||
| RODEN, John Philip Edward | Geschäftsführer | 10 Epsom Way LL13 0LZ Wrexham Clwyd | Wales | British | 126776380001 | |||||
| SIMMONS, Timothy | Geschäftsführer | 4 Malthouse Close Whittington SY11 4NA Oswestry Salop | British | 111681270001 | ||||||
| FARR, Geoffrey | Sekretär | 2 Old Rectory Gardens West Felton SY11 4QE Oswestry Shropshire | British | 76875660003 | ||||||
| HAISELDEN, Alan William | Sekretär | Tatters End 6 Grange Close TN6 1YD Crowborough East Sussex | British | 1608740001 | ||||||
| KARA, Peter Bhupatsingh | Sekretär | 73 Windmill Hill Drive Bletchley MK3 7RJ Milton Keynes | British | 1575610001 | ||||||
| MONDON, Peter Nigel | Sekretär | Keepers Cottage Colemore Green WV16 4ST Bridgnorth Shropshire | British | 51801010002 | ||||||
| BALDWIN, Keith | Geschäftsführer | 15 Green Park LL13 8YE Wrexham Clwyd | British | 41150700001 | ||||||
| CHEESEMAN, John Jeffrey | Geschäftsführer | 31 Haven Close BR8 7JY Swanley Kent | British | 40922460001 | ||||||
| FRANKLIN, Grant Roger | Geschäftsführer | Perton Court Farm Cottage Pattingham Road WV6 7HD Wolverhampton | British | 4876290002 | ||||||
| GAWNE, Christopher William | Geschäftsführer | The Coach House Allerton Hill Westwood Road GU20 6LS Windlesham Surrey | British | 32263200001 | ||||||
| HAISELDEN, Alan William | Geschäftsführer | Tatters End 6 Grange Close TN6 1YD Crowborough East Sussex | British | 1608740001 | ||||||
| HARRAGE, Christopher | Geschäftsführer | 11 Meadowcroft Cross Lanes LL13 0UJ Wrexham Clwyd | British | 41150780001 | ||||||
| KARA, Peter Bhupatsingh | Geschäftsführer | 73 Windmill Hill Drive Bletchley MK3 7RJ Milton Keynes | England | British | 1575610001 | |||||
| MITCHELL, Neil James | Geschäftsführer | 7 Grange Court Cross Lanes LL13 0SX Wrexham Clwyd | British | 104634730001 | ||||||
| MULLANEY, Stuart David | Geschäftsführer | Wayside Laurels Avenue LL13 0BB Bangor On Dee Wrexham | British | 81819120001 | ||||||
| PRETZLIK, Nicholas Charles | Geschäftsführer | 44 Hornton Street W8 4NT London | British | 1575620001 | ||||||
| STEEL, Robert Emmanual | Geschäftsführer | 8 Hinchley Close Hartford CW8 1SU Northwich Cheshire | British | 37091130003 | ||||||
| THOMPSON, Ronald Arthur | Geschäftsführer | Redriff 44 Ham Shades Lane CT5 1NX Whitstable Kent | United Kingdom | British | 1575630001 | |||||
| UNDERHILL, Peter John | Geschäftsführer | Maes Court Knighton On Teme WR15 8LY Tenbury Wells Worcestershire | British | 17203000001 | ||||||
| UNDERHILL, Peter John | Geschäftsführer | Maes Court Knighton On Teme WR15 8LY Tenbury Wells Worcestershire | British | 17203000001 |
Hat EP PACKAGING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 16. Nov. 2006 Geliefert am 18. Nov. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 15. Dez. 2002 Geliefert am 03. Jan. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 19. Okt. 1998 Geliefert am 21. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal sum of £102,000.00 together with interest due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben A first fixed charge over 1 x GN3021C high speed pressure former machines s/n 81171706525. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 17. Apr. 1998 Geliefert am 21. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £32,393 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed charge over: 1 x ecoair rotary screw air compressor plus accessories including EAA600F filter s/n 2420118. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Sept. 1994 Geliefert am 29. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit 2 challenge road ashford feltham middlesex title no NGL529671. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 28. Jan. 1991 Geliefert am 06. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and building at queensway industrial estate queensway wrexham t/n wa 501074 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 02. Nov. 1990 Geliefert am 07. Nov. 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat EP PACKAGING LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0