CDW PRODUCTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CDW PRODUCTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00519049 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CDW PRODUCTS LIMITED?
- Herstellung von anderen Kunststoffwaren (22290) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich CDW PRODUCTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency St John's Terrace 11-15 New Road M26 1LS Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CDW PRODUCTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CARADON DOORS & WINDOWS LIMITED | 27. Nov. 1995 | 27. Nov. 1995 |
CARADON DURAFLEX LIMITED | 18. Feb. 1994 | 18. Feb. 1994 |
DURAFLEX LIMITED | 01. Apr. 1984 | 01. Apr. 1984 |
DURAFLEX HOUSECRAFTS LIMITED | 25. Apr. 1953 | 25. Apr. 1953 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CDW PRODUCTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 01. Nov. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CDW PRODUCTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Talbot House Talbot Skyline Raynes Lane Harrow London HA2 7HA zum C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency St John's Terrace 11-15 New Road Manchester M26 1LS am 06. Dez. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Juli 2022 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency St Johns Terrace 11-15 New Road Manchester M26 1LS zum 25 Talbot House Talbot Skyline Raynes Lane Harrow London HA2 7HA am 13. Aug. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Enterprise Works Salthill Road Clitheroe Lancashire BB7 1PE zum C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency St Johns Terrace 11-15 New Road Manchester M26 1LS am 10. Aug. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Slade als Geschäftsführer am 10. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 01. Nov. 2019 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 005190490009, erstellt am 16. Apr. 2020 | 38 Seiten | MR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy John Halpin als Direktor am 15. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 02. Nov. 2018 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 27. Okt. 2017 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 005190490008, erstellt am 19. Dez. 2017 | 37 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Okt. 2016 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Challinor als Geschäftsführer am 30. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CDW PRODUCTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALPIN, Timothy John | Geschäftsführer | St John's Terrace 11-15 New Road M26 1LS Manchester C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency | United Kingdom | British | Finance Director | 260805450001 | ||||
EDWARDS, Wendy Elizabeth Anne | Sekretär | Penfolds 63 Saint Georges Road GL50 3DU Cheltenham Gloucestershire | British | 69378340001 | ||||||
FIELDING, Kelly | Sekretär | 6 Friars Stile Place TW10 6NL Richmond Surrey | British | Company Secretary | 101618800001 | |||||
HARES, Peter James | Sekretär | 9 Shelley Road BA2 4RJ Bath Avon | British | 49112750001 | ||||||
INGRAM, Kevin John | Sekretär | May House Church Road GL17 0LL Longhope Gloucestershire | British | 84194000001 | ||||||
OSBORNE, Stephen Ronald | Sekretär | Milestone Greet Road GL54 5BG Greet Gloucestershire | British | 59894560002 | ||||||
RICHARDSON, Karen | Sekretär | Five Farthings Mansel Road SW19 4AA London | British | 38091040002 | ||||||
THOMSON, Iain | Sekretär | Cross Lane SK9 2DB Wilmslow 1 Glen Cottage Cheshire | British | Director | 130316490001 | |||||
WALLIS, Daren Johnathan | Sekretär | Castleford Drive Prestbury SK10 4BG Macclesfield 11 Cheshire | British | Finance Director | 128094920001 | |||||
BRAYSHAW, Nicholas Paul | Geschäftsführer | 116 Chessetts Wood Roal B94 6EL Lapworth Warwickshire | British | Director | 96985570001 | |||||
CHALLINOR, David John | Geschäftsführer | Salthill Road BB7 1PE Clitheroe Enterprise Works Lancashire Uk | United Kingdom | British | Finance Director | 138870170001 | ||||
COHEN, Daniel Charles | Geschäftsführer | 25 Berwyn Road TW10 5BP Richmond Surrey | British | Company Director | 2421540001 | |||||
DYKINS, Alan John | Geschäftsführer | 40 Sharps Lane HA4 7JQ Ruislip Middlesex | British | Director | 43982050001 | |||||
GARDINER, Stephen James Furse | Geschäftsführer | 10 Longcroft Avenue AL5 2QZ Harpenden Hertfordshire | Gb-Eng | British | Chief Executive | 76915750003 | ||||
GRANT, James | Geschäftsführer | 25 Bisley Road GL51 6AB Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 20552860001 | |||||
HALL, Neil Grahame | Geschäftsführer | Lane End Tarnwater Lane, LA2 0AH Lancaster | England | British | Managing Director | 84026820002 | ||||
HARES, Peter James | Geschäftsführer | 9 Shelley Road BA2 4RJ Bath Avon | British | Accountant & Director | 49112750001 | |||||
HOLLIDGE, Simon | Geschäftsführer | Tudor Cottage High London Lane IP22 2EF Winfarthing Norfolk | England | British | Director | 116888960001 | ||||
HOUGHTON, Richard Alexander | Geschäftsführer | 4 The Quillot Burwood Park KT12 5BY Walton On Thames Surrey | England | Irish | Company Director | 119279790001 | ||||
JOHNSON, Richard Hugh | Geschäftsführer | Mandeville House Longstock SO20 6DP Stockbridge Hampshire | British | Company Director | 37915800004 | |||||
JONES, Michael Richard | Geschäftsführer | Lower Walcot Farm Walcot Road, Drakes Broughton WR10 2AL Pershore Worcestershire | United Kingdom | British | Managing Director | 66720990001 | ||||
KELLY, Mark Jonathan Warwick | Geschäftsführer | The Coblers Aston On Carrant GL20 8HL Tewkesbury Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 103354450001 | ||||
KEMP, Brian Richard Calvert | Geschäftsführer | Olveston Court Olveston BS35 4DU Bristol | England | British | Director | 62809970002 | ||||
KENNEDY, Brian George | Geschäftsführer | Swettenham Hall Swettenham CW12 2JZ Congleton Cheshire | England | British | Company Director | 4067600009 | ||||
KIRK, Adrian Christopher | Geschäftsführer | Salthill Road BB7 1PE Clitheroe Enterprise Works Lancashire Uk | England | British | Finance Director | 93313700001 | ||||
KIRKHAM, Ian | Geschäftsführer | 106 Windingbrook Lane Collingtree Park NN4 0XN Northampton Northamptonshire | British | Director | 34964530002 | |||||
LEES, Stuart | Geschäftsführer | Springfield Macclesfield Road SK9 7BW Alderley Edge Cheshire | England | British | Director | 70032700001 | ||||
MOORE, Roger Graham Anthony | Geschäftsführer | Orchard Lodge Gretton Winchcombe GL54 5EY Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 8513940001 | |||||
MORAN, Mark | Geschäftsführer | Oatlands Glosthorpe Manor East Winch Road PE32 1NA Kings Lynn Norfolk | British | Director | 60066000001 | |||||
MOSS, Andrew John | Geschäftsführer | Field View Ham Lane Aston OX18 2DE Bampton Oxfordshire | British | Chartered Accountant | 55351010001 | |||||
MOSS, Nicholas Arthur | Geschäftsführer | Walnut House Bricklehampton WR10 3HJ Pershore Worcestershire | England | British | Director | 69221070001 | ||||
OSBORNE, Stephen Ronald | Geschäftsführer | Milestone Greet Road GL54 5BG Greet Gloucestershire | British | Chartered Accountant | 59894560002 | |||||
PRICE, Michael | Geschäftsführer | 25 Alders Road Disley SK12 2LJ Stockport Cheshire | England | British | Director | 108822420001 | ||||
SEDDON, Andrew David | Geschäftsführer | 19 Balmuir Gardens Putney SW15 6NG London | British | Finance Director | 68650190001 | |||||
SHELDON, Alan Charles | Geschäftsführer | Woodbine Cottage Old Hill WR7 4DA Flyford Flavell Worcestershire | British | Director | 98898320001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CDW PRODUCTS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Brian George Kennedy | 06. Apr. 2016 | St John's Terrace 11-15 New Road M26 1LS Manchester C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat CDW PRODUCTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 16. Apr. 2020 Geliefert am 02. Mai 2020 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Enterprise works, salthill road, clitheroe (BB7 1PE) LA594802. Land on the east side of lincoln way, clitheroe LA760968. Land on the east side of lincoln way, clitheroe (BB7 1QD) LA804785. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 19. Dez. 2017 Geliefert am 22. Dez. 2017 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Enterprise works, salthill road, clitheroe BB7 1PE. Land on the east side of lincoln way, clitheroe BB7 1QD. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Jan. 2012 Geliefert am 25. Jan. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Nov. 2006 Geliefert am 24. Nov. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 22. Juni 2005 Geliefert am 13. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. März 1999 Geliefert am 12. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the charge or the protection, preservation or enforcement of the rights of any of the security beneficiaries (as defined) thereunder | |
Kurze Angaben L/H land and buildings at new hythe lane aylesford kent the property above is charged by way of legal mortgage; by way of fixed charge all plant machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishing equipment tools or other chattels, the goodwill and the proceeds of any insuarnce.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. März 1999 Geliefert am 12. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the charge or the protection, preservation or enforcement of the rights of any of the security beneficiaries (as defined) thereunder | |
Kurze Angaben F/H orchard industrial estate toddington near cheltenham gloucester t/n-GR90263 the property above is charged by way of legal mortgage; by way of fixed charge all plant machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishing equipment tools or other chattels, the goodwill and the proceeds of any insuarnce.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. März 1999 Geliefert am 12. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the charge or the protection, preservation or enforcement of the rights of any of the security beneficiaries (as defined) thereunder | |
Kurze Angaben F/H lodge farm industrial estate northampton t/n-NN174475 the property above is charged by way of legal mortgage; by way of fixed charge all plant machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishing equipment tools or other chattels, the goodwill and the proceeds of any insuarnce.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 06. März 1999 Geliefert am 12. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the facility documents (as defined) or the protection, preservation or enforcement of the respective rights of the security beneficiaries (as defined) under any facility document, provided that no obligation or liability shall be included in (I) and (ii) above, to the extent that if it were so included, the charge (or any part of it) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all f/h and l/h property (if any) vested in or charged to the company; by way of first fixed charge all plant machinery computeres vehicles office and other equipment, the benefit of the licences, goodwill and uncalled capital; by way of floating charge all its assets and undertaking whatsoever and wheresoever situated both present and future not effectively charged by way of a first fixed mortgage or charge.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat CDW PRODUCTS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0