CDW PRODUCTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCDW PRODUCTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00519049
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CDW PRODUCTS LIMITED?

    • Herstellung von anderen Kunststoffwaren (22290) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich CDW PRODUCTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency St John's Terrace
    11-15 New Road
    M26 1LS Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CDW PRODUCTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CARADON DOORS & WINDOWS LIMITED 27. Nov. 199527. Nov. 1995
    CARADON DURAFLEX LIMITED18. Feb. 199418. Feb. 1994
    DURAFLEX LIMITED01. Apr. 198401. Apr. 1984
    DURAFLEX HOUSECRAFTS LIMITED25. Apr. 195325. Apr. 1953

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CDW PRODUCTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis01. Nov. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für CDW PRODUCTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Talbot House Talbot Skyline Raynes Lane Harrow London HA2 7HA zum C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency St John's Terrace 11-15 New Road Manchester M26 1LS am 06. Dez. 2022

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Juli 2022

    8 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency St Johns Terrace 11-15 New Road Manchester M26 1LS zum 25 Talbot House Talbot Skyline Raynes Lane Harrow London HA2 7HA am 13. Aug. 2021

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Enterprise Works Salthill Road Clitheroe Lancashire BB7 1PE zum C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency St Johns Terrace 11-15 New Road Manchester M26 1LS am 10. Aug. 2021

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 28. Juli 2021

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Julian Slade als Geschäftsführer am 10. Feb. 2021

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 01. Nov. 2019

    18 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 005190490009, erstellt am 16. Apr. 2020

    38 SeitenMR01

    Ernennung von Mr Timothy John Halpin als Direktor am 15. Apr. 2020

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 02. Nov. 2018

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 27. Okt. 2017

    21 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Eintragung der Belastung 005190490008, erstellt am 19. Dez. 2017

    37 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Okt. 2016

    21 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2015

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 01. Mai 2016

    • Kapital: GBP 3,020,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von David John Challinor als Geschäftsführer am 30. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CDW PRODUCTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HALPIN, Timothy John
    St John's Terrace
    11-15 New Road
    M26 1LS Manchester
    C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency
    Geschäftsführer
    St John's Terrace
    11-15 New Road
    M26 1LS Manchester
    C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency
    United KingdomBritishFinance Director260805450001
    EDWARDS, Wendy Elizabeth Anne
    Penfolds
    63 Saint Georges Road
    GL50 3DU Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    Penfolds
    63 Saint Georges Road
    GL50 3DU Cheltenham
    Gloucestershire
    British69378340001
    FIELDING, Kelly
    6 Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    Surrey
    Sekretär
    6 Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    Surrey
    BritishCompany Secretary101618800001
    HARES, Peter James
    9 Shelley Road
    BA2 4RJ Bath
    Avon
    Sekretär
    9 Shelley Road
    BA2 4RJ Bath
    Avon
    British49112750001
    INGRAM, Kevin John
    May House
    Church Road
    GL17 0LL Longhope
    Gloucestershire
    Sekretär
    May House
    Church Road
    GL17 0LL Longhope
    Gloucestershire
    British84194000001
    OSBORNE, Stephen Ronald
    Milestone
    Greet Road
    GL54 5BG Greet
    Gloucestershire
    Sekretär
    Milestone
    Greet Road
    GL54 5BG Greet
    Gloucestershire
    British59894560002
    RICHARDSON, Karen
    Five Farthings
    Mansel Road
    SW19 4AA London
    Sekretär
    Five Farthings
    Mansel Road
    SW19 4AA London
    British38091040002
    THOMSON, Iain
    Cross Lane
    SK9 2DB Wilmslow
    1 Glen Cottage
    Cheshire
    Sekretär
    Cross Lane
    SK9 2DB Wilmslow
    1 Glen Cottage
    Cheshire
    BritishDirector130316490001
    WALLIS, Daren Johnathan
    Castleford Drive
    Prestbury
    SK10 4BG Macclesfield
    11
    Cheshire
    Sekretär
    Castleford Drive
    Prestbury
    SK10 4BG Macclesfield
    11
    Cheshire
    BritishFinance Director128094920001
    BRAYSHAW, Nicholas Paul
    116 Chessetts Wood Roal
    B94 6EL Lapworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    116 Chessetts Wood Roal
    B94 6EL Lapworth
    Warwickshire
    BritishDirector96985570001
    CHALLINOR, David John
    Salthill Road
    BB7 1PE Clitheroe
    Enterprise Works
    Lancashire
    Uk
    Geschäftsführer
    Salthill Road
    BB7 1PE Clitheroe
    Enterprise Works
    Lancashire
    Uk
    United KingdomBritishFinance Director138870170001
    COHEN, Daniel Charles
    25 Berwyn Road
    TW10 5BP Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    25 Berwyn Road
    TW10 5BP Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director2421540001
    DYKINS, Alan John
    40 Sharps Lane
    HA4 7JQ Ruislip
    Middlesex
    Geschäftsführer
    40 Sharps Lane
    HA4 7JQ Ruislip
    Middlesex
    BritishDirector43982050001
    GARDINER, Stephen James Furse
    10 Longcroft Avenue
    AL5 2QZ Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    10 Longcroft Avenue
    AL5 2QZ Harpenden
    Hertfordshire
    Gb-EngBritishChief Executive76915750003
    GRANT, James
    25 Bisley Road
    GL51 6AB Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    25 Bisley Road
    GL51 6AB Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector20552860001
    HALL, Neil Grahame
    Lane End
    Tarnwater Lane,
    LA2 0AH Lancaster
    Geschäftsführer
    Lane End
    Tarnwater Lane,
    LA2 0AH Lancaster
    EnglandBritishManaging Director84026820002
    HARES, Peter James
    9 Shelley Road
    BA2 4RJ Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    9 Shelley Road
    BA2 4RJ Bath
    Avon
    BritishAccountant & Director49112750001
    HOLLIDGE, Simon
    Tudor Cottage
    High London Lane
    IP22 2EF Winfarthing
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Tudor Cottage
    High London Lane
    IP22 2EF Winfarthing
    Norfolk
    EnglandBritishDirector116888960001
    HOUGHTON, Richard Alexander
    4 The Quillot
    Burwood Park
    KT12 5BY Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 The Quillot
    Burwood Park
    KT12 5BY Walton On Thames
    Surrey
    EnglandIrishCompany Director119279790001
    JOHNSON, Richard Hugh
    Mandeville House
    Longstock
    SO20 6DP Stockbridge
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Mandeville House
    Longstock
    SO20 6DP Stockbridge
    Hampshire
    BritishCompany Director37915800004
    JONES, Michael Richard
    Lower Walcot Farm
    Walcot Road, Drakes Broughton
    WR10 2AL Pershore
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Lower Walcot Farm
    Walcot Road, Drakes Broughton
    WR10 2AL Pershore
    Worcestershire
    United KingdomBritishManaging Director66720990001
    KELLY, Mark Jonathan Warwick
    The Coblers
    Aston On Carrant
    GL20 8HL Tewkesbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    The Coblers
    Aston On Carrant
    GL20 8HL Tewkesbury
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector103354450001
    KEMP, Brian Richard Calvert
    Olveston Court
    Olveston
    BS35 4DU Bristol
    Geschäftsführer
    Olveston Court
    Olveston
    BS35 4DU Bristol
    EnglandBritishDirector62809970002
    KENNEDY, Brian George
    Swettenham Hall
    Swettenham
    CW12 2JZ Congleton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Swettenham Hall
    Swettenham
    CW12 2JZ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director4067600009
    KIRK, Adrian Christopher
    Salthill Road
    BB7 1PE Clitheroe
    Enterprise Works
    Lancashire
    Uk
    Geschäftsführer
    Salthill Road
    BB7 1PE Clitheroe
    Enterprise Works
    Lancashire
    Uk
    EnglandBritishFinance Director93313700001
    KIRKHAM, Ian
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector34964530002
    LEES, Stuart
    Springfield
    Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Springfield
    Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    EnglandBritishDirector70032700001
    MOORE, Roger Graham Anthony
    Orchard Lodge
    Gretton Winchcombe
    GL54 5EY Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Orchard Lodge
    Gretton Winchcombe
    GL54 5EY Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector8513940001
    MORAN, Mark
    Oatlands
    Glosthorpe Manor East Winch Road
    PE32 1NA Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Oatlands
    Glosthorpe Manor East Winch Road
    PE32 1NA Kings Lynn
    Norfolk
    BritishDirector60066000001
    MOSS, Andrew John
    Field View Ham Lane
    Aston
    OX18 2DE Bampton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Field View Ham Lane
    Aston
    OX18 2DE Bampton
    Oxfordshire
    BritishChartered Accountant55351010001
    MOSS, Nicholas Arthur
    Walnut House
    Bricklehampton
    WR10 3HJ Pershore
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Walnut House
    Bricklehampton
    WR10 3HJ Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector69221070001
    OSBORNE, Stephen Ronald
    Milestone
    Greet Road
    GL54 5BG Greet
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Milestone
    Greet Road
    GL54 5BG Greet
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant59894560002
    PRICE, Michael
    25 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    25 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector108822420001
    SEDDON, Andrew David
    19 Balmuir Gardens
    Putney
    SW15 6NG London
    Geschäftsführer
    19 Balmuir Gardens
    Putney
    SW15 6NG London
    BritishFinance Director68650190001
    SHELDON, Alan Charles
    Woodbine Cottage
    Old Hill
    WR7 4DA Flyford Flavell
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Woodbine Cottage
    Old Hill
    WR7 4DA Flyford Flavell
    Worcestershire
    BritishDirector98898320001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CDW PRODUCTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Brian George Kennedy
    St John's Terrace
    11-15 New Road
    M26 1LS Manchester
    C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency
    06. Apr. 2016
    St John's Terrace
    11-15 New Road
    M26 1LS Manchester
    C/O Inquesta Corporate Recovery & Insolvency
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat CDW PRODUCTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 16. Apr. 2020
    Geliefert am 02. Mai 2020
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Enterprise works, salthill road, clitheroe (BB7 1PE) LA594802. Land on the east side of lincoln way, clitheroe LA760968. Land on the east side of lincoln way, clitheroe (BB7 1QD) LA804785.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Brian Kennedy
    Transaktionen
    • 02. Mai 2020Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 19. Dez. 2017
    Geliefert am 22. Dez. 2017
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Enterprise works, salthill road, clitheroe BB7 1PE. Land on the east side of lincoln way, clitheroe BB7 1QD.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Brian George Kennedy
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 16. Jan. 2012
    Geliefert am 25. Jan. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Brian George Kennedy
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 14. Nov. 2006
    Geliefert am 24. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 22. Juni 2005
    Geliefert am 13. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1999
    Geliefert am 12. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the charge or the protection, preservation or enforcement of the rights of any of the security beneficiaries (as defined) thereunder
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings at new hythe lane aylesford kent the property above is charged by way of legal mortgage; by way of fixed charge all plant machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishing equipment tools or other chattels, the goodwill and the proceeds of any insuarnce.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for and on Behalf of the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 12. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 2001Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1999
    Geliefert am 12. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the charge or the protection, preservation or enforcement of the rights of any of the security beneficiaries (as defined) thereunder
    Kurze Angaben
    F/H orchard industrial estate toddington near cheltenham gloucester t/n-GR90263 the property above is charged by way of legal mortgage; by way of fixed charge all plant machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishing equipment tools or other chattels, the goodwill and the proceeds of any insuarnce.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for and on Behalf of the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 12. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 2001Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1999
    Geliefert am 12. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the charge or the protection, preservation or enforcement of the rights of any of the security beneficiaries (as defined) thereunder
    Kurze Angaben
    F/H lodge farm industrial estate northampton t/n-NN174475 the property above is charged by way of legal mortgage; by way of fixed charge all plant machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishing equipment tools or other chattels, the goodwill and the proceeds of any insuarnce.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for and on Behalf of the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 12. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 06. März 1999
    Geliefert am 12. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries (as defined) (I) all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each charging company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) (or any of them) under the facility documents (as defined) to which such charging company (as defined) is a party; (ii) all reasonable costs, charges and expenses properly incurred by the security beneficiaries (as defined) (or any of them) in connection with the preperation and negotiation of the facility documents (as defined) or the protection, preservation or enforcement of the respective rights of the security beneficiaries (as defined) under any facility document, provided that no obligation or liability shall be included in (I) and (ii) above, to the extent that if it were so included, the charge (or any part of it) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all f/h and l/h property (if any) vested in or charged to the company; by way of first fixed charge all plant machinery computeres vehicles office and other equipment, the benefit of the licences, goodwill and uncalled capital; by way of floating charge all its assets and undertaking whatsoever and wheresoever situated both present and future not effectively charged by way of a first fixed mortgage or charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for and on Behalf of the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 12. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 2001Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CDW PRODUCTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Mai 2023Soll aufgelöst werden am
    28. Juli 2021Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Wiseglass
    St Johns Terrace 11-15 New Road
    Radcliffe
    M26 1LS Manchester
    Praktiker
    St Johns Terrace 11-15 New Road
    Radcliffe
    M26 1LS Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0