ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00521510 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
- (4521) /
Wo befindet sich ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RYAN UTILITY SERVICES LIMITED | 20. Nov. 2000 | 20. Nov. 2000 |
| D.J. RYAN & SONS LIMITED | 07. Juli 1953 | 07. Juli 1953 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2009 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2010 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Okt. 2016 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 31. Okt. 2016 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Lee James Mills als Geschäftsführer am 28. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Francis George als Sekretär am 28. Sept. 2018 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Wilkins als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 11 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 15 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEY, Stephanie Helen | Sekretär | 53 Kidmore Road Caversham RG4 7LY Reading Berkshire | British | 81328280002 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Sekretär | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Sekretär | Blackbarn House Main Street Bishampton WR10 2NH Pershore Worcestershire | British | 24075160004 | ||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Sekretär | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| MEADOWS, John | Sekretär | 39 Beech Walk Pennington WN7 3LL Leigh Lancashire | British | 101833160001 | ||||||
| STONES, Michael John | Sekretär | 23 Muirfield Close Fulwood PR2 7EA Preston Lancashire | British | 68468490001 | ||||||
| ARMSTRONG, Neil Patrick | Geschäftsführer | 4 Euxton Hall Gardens Euxton PR7 6PB Chorley Lancashire | Irish | 104897110001 | ||||||
| BROOKES, Philip | Geschäftsführer | Tudor House Lime Tree Avenue LS23 6DP Boston Spa West Yorkshire | United Kingdom | British | 89559990001 | |||||
| BROWN, David Robertson | Geschäftsführer | 11 Dorchester Road Fixby HD2 2JZ Huddersfield | United Kingdom | British | 39067610002 | |||||
| BROWN, John Ernest | Geschäftsführer | 10 Stonegate Fold Heath Charnock PR6 9DX Chorley Lancashire | England | British | 11806560001 | |||||
| CAROLAN, Peter Vincent | Geschäftsführer | 272 Leigh Road Worsley M28 1LF Manchester | Irish | 62299930001 | ||||||
| COCKER, Neil David | Geschäftsführer | 5 Rossett Close Kingsmead CW9 8WP Northwich Cheshire | England | British | 260158230001 | |||||
| DARBYSHIRE, John Peter | Geschäftsführer | 12 Salisbury Drive M25 0HU Prestwich Manchester | British | 69930320002 | ||||||
| FOX, Kenneth | Geschäftsführer | 5 Sandiacre Standish WN6 0TJ Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 15540580001 | |||||
| FRASER, Richard | Geschäftsführer | 4 Severn Hill Fulwood PR2 3RD Preston Lancashire | United Kingdom | British | 79090001 | |||||
| GREENHALGH, Donald | Geschäftsführer | The Hayricks Bolton Road PR6 9HN Anderton Lancashire | British | 47084170002 | ||||||
| GREENOUGH, Michael Robert | Geschäftsführer | Millstone Cottage Bolton Road PR6 9HJ Anderton Lancashire | British | 53010640001 | ||||||
| GRICE, Ian Michael | Geschäftsführer | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| JACKSON, Andrew Philip | Geschäftsführer | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| LANSOM, Stewart Paul | Geschäftsführer | 23 Park Street FY8 5LU Lytham Lancashire | British | 79070008 | ||||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LAWLESS, Dennis Arthur | Geschäftsführer | 14 Sevenoaks PR7 3NS Chorley Lancashire | British | 46658890003 | ||||||
| LEACH, William Anthony | Geschäftsführer | 17 Claybank Drive Tottington BL8 4BU Bury Lancashire | British | 66732560001 | ||||||
| MEADOWS, John | Geschäftsführer | 39 Beech Walk Pennington WN7 3LL Leigh Lancashire | England | British | 101833160001 | |||||
| MEMMOTT, Robert William | Geschäftsführer | Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent Culcheth WA3 4DN Warrington Cheshire | British | 109306950001 | ||||||
| MILLS, Lee James | Geschäftsführer | 4 Kings Court CM23 2AA Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| O'BRIEN, Neil Christopher | Geschäftsführer | Alexandra House 11 St Catherine Drive Hartford CW8 2FE Northwich Cheshire | British | 58219210001 | ||||||
| ROWAN, Michael William | Geschäftsführer | Jinbabyne 1 Field Farm Drive Edingale B79 9LF Tamworth Staffordshire | British | 72210350002 | ||||||
| RYAN, Daniel Joseph | Geschäftsführer | Button Mill Inglewhite PR3 2LE Preston Lancashire | British | 1472220001 | ||||||
| RYAN, John Timothy Anthony | Geschäftsführer | Bank Hall Sawley BB7 4RS Clitheroe Lancashire | British | 39428900001 | ||||||
| RYAN, Michael Bernard | Geschäftsführer | Stafford House 102 Victoria Road Fulwood PR2 4NN Preston Lancashire | British | 779240001 | ||||||
| SIMCOCK, Barry | Geschäftsführer | 24 Poplar Drive ST3 3AZ Blurton Staffordshire | British | 74253700001 | ||||||
| WILKINS, Andrew Michael | Geschäftsführer | PR25 | United Kingdom | British | 125411390001 | |||||
| AM NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 34427260007 |
Hat ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Chattels mortgage | Erstellt am 05. Sept. 2001 Geliefert am 05. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the chattles plant machinery, 16 compressor & generator systems, 2 x computer servers (for further details please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 12. Feb. 1992 Geliefert am 21. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises situate in station road pembroke dyfed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Jan. 1992 Geliefert am 05. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the north west side of rough hey road preston lancashire t/n la 585346. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Jan. 1992 Geliefert am 05. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the north east side of rough hey road, preston, lancashire. T/n la 525 287. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Jan. 1992 Geliefert am 05. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All those premises known as longridge foundry, inglewhite road, (formerly higher lane) longridge, lancashire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Jan. 1992 Geliefert am 05. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Please see doc form M395 reference M198C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement | Erstellt am 05. Apr. 1991 Geliefert am 16. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pounds 172590.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement | |
Kurze Angaben All right title & interest in & to all sums payable (including by way of refund) under the insurance whereof are set out on form 395 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 24. Jan. 1990 Geliefert am 08. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future includin book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Aug. 1988 Geliefert am 01. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises situated off rough hey road, preston. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Apr. 1988 Geliefert am 14. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the north east side of rough hey road preston. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 14. Dez. 1971 Geliefert am 22. Dez. 1971 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and premises at longridge foundry, longridge in the county of lancaster with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0