TERMINUS 20 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TERMINUS 20 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00522014 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TERMINUS 20 LIMITED?
- (2222) /
Wo befindet sich TERMINUS 20 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Apex Business Centre Boscombe Road LU5 4SB Dunstable Bedfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TERMINUS 20 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| POLESTAR SPECIALIST COLOUR LIMITED | 06. Nov. 1998 | 06. Nov. 1998 |
| BPC DUNSTABLE LTD | 31. Okt. 1996 | 31. Okt. 1996 |
| BPC MAGAZINES (DUNSTABLE) LTD | 23. Nov. 1995 | 23. Nov. 1995 |
| BPC WATERLOW LTD | 18. Jan. 1994 | 18. Jan. 1994 |
| BPCC WATERLOW LTD | 13. März 1991 | 13. März 1991 |
| BPCC OYEZ WATERLOW DUNSTABLE LTD. | 24. Jan. 1990 | 24. Jan. 1990 |
| BPCC WATERLOW LTD | 04. Mai 1989 | 04. Mai 1989 |
| WATERLOW LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
| WATERLOW (DUNSTABLE) LIMITED | 21. Juli 1953 | 21. Juli 1953 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TERMINUS 20 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TERMINUS 20 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed polestar specialist colour LIMITED\certificate issued on 12/05/11 | 5 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Alan Goodwin am 31. Juli 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alan Goodwin am 31. Juli 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2004 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TERMINUS 20 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOODWIN, Alan | Sekretär | Ensign House Juniper Drive SW18 1TR London 104 | British | 98921850001 | ||||||
| GOODWIN, Alan James | Geschäftsführer | Ensign House Juniper Drive SW18 1TR London 104 | United Kingdom | British | 98921850003 | |||||
| HEARN, Catherine Ann | Geschäftsführer | White Gate House Ellesborough Road HP22 6ES Wendover Buckinghamshire | United Kingdom | British | 83713930001 | |||||
| HIBBERT, Barry Alan | Geschäftsführer | River Steps Gibraltar Lane SL6 9TR Cookham Dean Berkshire | United Kingdom | British | 68122470005 | |||||
| JOHNSTON, Peter Douglas | Geschäftsführer | Peters Lane HP27 OLQ Whiteleaf Tanglewood Bucks | England | British | 138015860001 | |||||
| BRIDGES, Clive | Sekretär | 334 Wendover Road Weston Turville HP22 5TN Aylesbury Buckinghamshire | British | 987230001 | ||||||
| BRIDGES, Clive | Geschäftsführer | 334 Wendover Road Weston Turville HP22 5TN Aylesbury Buckinghamshire | British | 987230001 | ||||||
| BROWN, Frederick James | Geschäftsführer | 61 Handside Lane AL8 6SH Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 16105360002 | ||||||
| DAVIDGE, John David | Geschäftsführer | Little Thatch Park Lane MK44 1LF Sharnbrook Bedfordshire | British | 30567520001 | ||||||
| DICKSON, Peter Heron | Geschäftsführer | The Old Bakery Lower Way, Padbury MK18 2AX Buckingham Buckinghamshire | British | 66484940001 | ||||||
| HOLLORAN, Peter John | Geschäftsführer | Southmoor Farmhouse Stonehill Lane Southmoor OX13 5HU Abingdon Oxfordshire | England | British | 61418710001 | |||||
| JOHNSTON, Peter Douglas | Geschäftsführer | Flat 3 76 Carter Lane EC4V 5EA London | British | 83714120001 | ||||||
| MOUSLEY, Richard Mark | Geschäftsführer | 2 Marlborough Place Toddington LU5 6BU Dunstable Bedfordshire | British | 50489630001 | ||||||
| ROBERTSON, Malcolm Murray | Geschäftsführer | Mardale 85 Harmer Green Lane Digswell AL6 0ER Welwyn Hertfordshire | United Kingdom | British | 39155140002 | |||||
| RUDSTON, Anthony | Geschäftsführer | Minstrels Barn Henton OX9 4AE Chinnor Oxfordshire | England | British | 44908110001 | |||||
| TIMMINS, Richard Keith | Geschäftsführer | 3 Maxey View Deeping Gate PE6 9BE Peterborough | United Kingdom | British | 127238050003 |
Hat TERMINUS 20 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998 | Erstellt am 28. Okt. 2004 Geliefert am 10. Nov. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98 | Erstellt am 28. Okt. 2004 Geliefert am 10. Nov. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited | Erstellt am 28. Jan. 2002 Geliefert am 15. Feb. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities due or to become due from the company to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including (I) unit B5 blenheim industrial park estate,bury st.edmunds,suffolk; (ii) unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; bd 77546; (iii) wigman rd,aspley,nottingham; NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited | Erstellt am 26. Okt. 2001 Geliefert am 14. Nov. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 19. Juni 1998 Geliefert am 10. Juli 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents | |
Kurze Angaben F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 28. Dez. 1995 Geliefert am 08. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 28. Dez. 1995 Geliefert am 05. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as defined therein) and this deed | |
Kurze Angaben Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 26. Jan. 1989 Geliefert am 31. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from bucksmere limited to standard chartered bank as agent and trustee for the lenders under a mezzanine loan agreement dated 21/12/88 on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (See doc M228 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 26. Jan. 1989 Geliefert am 31. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from bucksmere and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks and the overdraft bank under the terms of "the facilities agreement" dated 21/12/88 and the overdraft facilities as defined in this deed on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben (See doc M217 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Apr. 1981 Geliefert am 13. Mai 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/hold and l/hold properties fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 02. März 1981 Geliefert am 16. März 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from bpc LTD not exceeding £13,000,000 under the terms of a deed dated 18-12-81 & deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Floating charges over all see doc M79. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0