TERMINUS 20 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTERMINUS 20 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00522014
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TERMINUS 20 LIMITED?

    • (2222) /

    Wo befindet sich TERMINUS 20 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TERMINUS 20 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    POLESTAR SPECIALIST COLOUR LIMITED06. Nov. 199806. Nov. 1998
    BPC DUNSTABLE LTD31. Okt. 199631. Okt. 1996
    BPC MAGAZINES (DUNSTABLE) LTD23. Nov. 199523. Nov. 1995
    BPC WATERLOW LTD18. Jan. 199418. Jan. 1994
    BPCC WATERLOW LTD13. März 199113. März 1991
    BPCC OYEZ WATERLOW DUNSTABLE LTD.24. Jan. 199024. Jan. 1990
    BPCC WATERLOW LTD04. Mai 198904. Mai 1989
    WATERLOW LIMITED31. Dez. 198131. Dez. 1981
    WATERLOW (DUNSTABLE) LIMITED21. Juli 195321. Juli 1953

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TERMINUS 20 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für TERMINUS 20 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed polestar specialist colour LIMITED\certificate issued on 12/05/11
    5 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 10. Mai 2011

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 20. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 53,899
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Alan Goodwin am 31. Juli 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Alan Goodwin am 31. Juli 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    8 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2004

    15 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von TERMINUS 20 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Sekretär
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    British98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Geschäftsführer
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritish98921850003
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritish68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    Geschäftsführer
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritish138015860001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Sekretär
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British16105360002
    DAVIDGE, John David
    Little Thatch
    Park Lane
    MK44 1LF Sharnbrook
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Little Thatch
    Park Lane
    MK44 1LF Sharnbrook
    Bedfordshire
    British30567520001
    DICKSON, Peter Heron
    The Old Bakery
    Lower Way, Padbury
    MK18 2AX Buckingham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Old Bakery
    Lower Way, Padbury
    MK18 2AX Buckingham
    Buckinghamshire
    British66484940001
    HOLLORAN, Peter John
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish61418710001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Geschäftsführer
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    British83714120001
    MOUSLEY, Richard Mark
    2 Marlborough Place
    Toddington
    LU5 6BU Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    2 Marlborough Place
    Toddington
    LU5 6BU Dunstable
    Bedfordshire
    British50489630001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritish44908110001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    Geschäftsführer
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritish127238050003

    Hat TERMINUS 20 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) or Such Otherperson as May from Time to Time Be Appointed Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 15. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) unit B5 blenheim industrial park estate,bury st.edmunds,suffolk; (ii) unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; bd 77546; (iii) wigman rd,aspley,nottingham; NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    Erstellt am 26. Okt. 2001
    Geliefert am 14. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 19. Juni 1998
    Geliefert am 10. Juli 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents
    Kurze Angaben
    F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 08. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chemical Investment Bank Limitedas Security Agent (As Defined Therein)
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 05. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as defined therein) and this deed
    Kurze Angaben
    Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Lenders (As Defined Therein)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 31. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from bucksmere limited to standard chartered bank as agent and trustee for the lenders under a mezzanine loan agreement dated 21/12/88 on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (See doc M228 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Lenders
    Transaktionen
    • 31. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 31. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bucksmere and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks and the overdraft bank under the terms of "the facilities agreement" dated 21/12/88 and the overdraft facilities as defined in this deed on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    (See doc M217 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 31. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 22. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Apr. 1981
    Geliefert am 13. Mai 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/hold and l/hold properties fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Mai 1981Registrierung einer Belastung
    Deed
    Erstellt am 02. März 1981
    Geliefert am 16. März 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bpc LTD not exceeding £13,000,000 under the terms of a deed dated 18-12-81 & deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    Floating charges over all see doc M79. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 1981Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0