PREPARED FOODS GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PREPARED FOODS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00523009 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PREPARED FOODS GROUP LIMITED?
- Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a.n.g. (10890) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich PREPARED FOODS GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Innovation Centre Warwick Technology Park CV34 6UW Gallows Hill Warwick |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PREPARED FOODS GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BOOKER PREPARED FOODS GROUP LIMITED | 13. Jan. 1997 | 13. Jan. 1997 |
| W.A.TURNER LIMITED | 25. Aug. 1953 | 25. Aug. 1953 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PREPARED FOODS GROUP LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2013 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2013 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PREPARED FOODS GROUP LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 02. Jan. 2017 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 16. Jan. 2017 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PREPARED FOODS GROUP LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PREPARED FOODS GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. März 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. März 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Michael John Russell am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2009 bis 31. März 2010 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Dez. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2006 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Jan. 2005 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PREPARED FOODS GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSELL, Michael John | Sekretär | Holly Cottage The Old Orchard Calcot RG31 7RF Reading Berkshire | British | 48183050001 | ||||||
| RUSSELL, Michael John | Geschäftsführer | Holly Cottage The Old Orchard Calcot RG31 7RF Reading Berkshire | United Kingdom | British | 48183050001 | |||||
| COATES, Philip Edward | Sekretär | 1 Finch Lane Harvington WR11 5DQ Evesham Worcestershire | British | 47902910001 | ||||||
| PLYTE, Mark Edward | Sekretär | 49 Summerheath Road BN27 3DR Hailsham East Sussex | British | 37417370001 | ||||||
| WHILEY, Graham Leonard | Sekretär | Cordoba 21 Bradley Drive ME10 1RB Sittingbourne Kent | British | 61634170001 | ||||||
| ABBOTT, David Charles | Geschäftsführer | 9 Countryside Braunston NN11 7JU Daventry Northamptonshire | British | 61848490001 | ||||||
| ASHWORTH, Paul Francis | Geschäftsführer | 4 Cambridge Park TW1 2PF Twickenham Middlesex | British | 41740830001 | ||||||
| COATES, Philip Edward | Geschäftsführer | 1 Finch Lane Harvington WR11 5DQ Evesham Worcestershire | British | 47902910001 | ||||||
| GREENACRE, Melvyn Walter | Geschäftsführer | 28 The Gill Pembury TN2 4DL Tunbridge Wells Kent | British | 16847180001 | ||||||
| HUNTER, Nigel John | Geschäftsführer | Manor Farm 128 Green Street TW16 6QJ Sunbury On Thames Middlesex | United Kingdom | British | 45026040001 | |||||
| LANGFORD, Michael Rodney | Geschäftsführer | The Orchards School Lane Colsterworth NG33 5NW Grantham Lincolnshire Uk | British | 48961920001 | ||||||
| MCLELLAN, Roger | Geschäftsführer | Appledore House 2 Stace Close, Beacon Oak Road TN30 6RP Tenterden Kent | British | 113718700001 | ||||||
| PLYTE, Mark Edward | Geschäftsführer | 49 Summerheath Road BN27 3DR Hailsham East Sussex | British | 37417370001 | ||||||
| PRICE, Stephen | Geschäftsführer | The Willows Water Stratford MK18 5DU Buckingham Buckinghamshire | England | British | 73146560001 | |||||
| ROBERTS, Mark Duncan | Geschäftsführer | 94 Ruxley Lane Ewell KT19 0HY Epsom Surrey | British | 36027030001 | ||||||
| SIMS, David John | Geschäftsführer | Beech House Main Street Scarrington NG13 9BQ Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 52926050001 | |||||
| STEENHOLDT, Steen | Geschäftsführer | Brookhill Ravensthorpe Road East Haddon NN6 8BY Northampton Northamptonshire | Danish | 16451370001 | ||||||
| TATE, James | Geschäftsführer | 13 Williams Bristow Road CV3 5LN Coventry | British | 79591810001 | ||||||
| THOMSON, George | Geschäftsführer | 17 Blakelaw Road NE66 1AZ Alnwick Northumberland | England | British | 70118650001 | |||||
| TURNER, Kevin | Geschäftsführer | 1 Skippers Hill Criers Lane TN20 6HR Five Ashes East Sussex | British | 85665400001 | ||||||
| WALL, Peter William | Geschäftsführer | 1 Heath Way Heathfield Manor CW6 9HQ Tarporley Cheshire | British | 40946400001 | ||||||
| WHILEY, Graham Leonard | Geschäftsführer | Cordoba 21 Bradley Drive ME10 1RB Sittingbourne Kent | British | 61634170001 |
Hat PREPARED FOODS GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Third party debenture | Erstellt am 14. Jan. 2002 Geliefert am 21. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers to any of the secured parties. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings to the east of broadwater lane tunbridge wells, kent. F/h t/no K828945. Unit 29 castle park ind. Estates, flint, CH6 5XA, f/h CYM35875. Factory, no.1 Land on the north west side of cornhill close, lodge way, northampton f/h t/no HN16610. (For further property charged please refer to the form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Sept. 1998 Geliefert am 25. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the debenture | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage l/h land and buildings at coquet industrial park amble northumberland. L/h t/n-ND106720 and all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery from time to time on the further property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 19. Mai 1997 Geliefert am 06. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The company formerly known as booker prepared foods group limited covenants that it will pay to the security trustee (as defined) all moneys,obligations and liabilities due owing or incurred by it to the finance parties (as defined) or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) when the same become due for payment or discharge; and irrevocably and unconditionally guarantees: the due performance by the parent (as defined) and each of the other members of the group (as defined) of all its obligations under or pursuant to the finance documents to which it is a party; and the payment of all moneys and discharge of all liabilities due to the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents by (x) each other company (as defined) and by (y) any other present or future subsidiary of the parent or of any company | |
Kurze Angaben 1) block 1H and 2H,west kent cold storage estate,sevenoaks,kent;2) bays 7 & 8 block h west kent cold storage estate,rye lane,dunton green,sevenoaks,kent;3) unit 22 eldon way,paddock wood,tunbridge wells,kent.for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Juli 1982 Geliefert am 26. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & premises at east side of broadwater lane, tunbridge wells kent title no. K208653. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 18. Jan. 1973 Geliefert am 24. Jan. 1973 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/P on the east side of broadwater lane, tunbridge wells together with all machinery fixtures therein or thereon (see doc 46 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0