SVITZER HUMBER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSVITZER HUMBER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00524008
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SVITZER HUMBER LIMITED?

    • See- und Küstenfrachtverkehr (50200) / Verkehr und Lagerei
    • Unterstützende Tätigkeiten im Wasserverkehr (52220) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich SVITZER HUMBER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Rowlands House
    Portobello Road
    DH3 2RY Birtley
    Chester Le Street
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SVITZER HUMBER LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ADSTEAM HUMBER LIMITED08. Okt. 200108. Okt. 2001
    HOWARD SMITH (HUMBER) LIMITED01. Jan. 199601. Jan. 1996
    ADSTEAM HUMBER LIMITED01. Jan. 199601. Jan. 1996
    HUMBER TUGS LIMITED26. Sept. 195326. Sept. 1953

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SVITZER HUMBER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für SVITZER HUMBER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    14 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Wynyard Park House Wynyard Avenue Wynyard TS22 5TB zum Rowlands House Portobello Road Birtley Chester Le Street DH3 2RY am 08. Feb. 2018

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Aug. 2017

    15 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    15 SeitenLIQ10

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    4 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Aug. 2016

    12 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 8 High Street Yarm Stockton on Tees TS15 9AE zum Wynyard Park House Wynyard Avenue Wynyard TS22 5TB am 12. Aug. 2016

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tees Wharf, Dockside Road Middlesbrough Cleveland TS3 6AB zum 8 High Street Yarm Stockton on Tees TS15 9AE am 09. Sept. 2015

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 25. Aug. 2015

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Marc Rudolf Pieter Niederer als Geschäftsführer am 24. Aug. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Noakes als Direktor am 24. Aug. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 16. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 8,900,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Marc Rudolf Pieter Niederer am 10. März 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    33 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    32 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 20. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 8,900,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Marc Rudolf Pieter Niederer am 07. Jan. 2013

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nils Rutger Thulin am 01. Sept. 2013

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Nils Rutger Thulin als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von SVITZER HUMBER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NOAKES, David Anthony
    The Village Green
    Sinderby
    YO7 4HY Thirsk
    11
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    The Village Green
    Sinderby
    YO7 4HY Thirsk
    11
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British54380850004
    NOAKES, David
    The Village Green
    Sinderby
    YO7 4HY Thirsk
    11
    North Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    The Village Green
    Sinderby
    YO7 4HY Thirsk
    11
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish200411640001
    THULIN, Nils Rutger
    Portobello Road
    DH3 2RY Birtley
    Rowlands House
    Chester Le Street
    Geschäftsführer
    Portobello Road
    DH3 2RY Birtley
    Rowlands House
    Chester Le Street
    EnglandSwedish174824070002
    ALLEN, Geoffrey
    44 Tetney Lane
    Holton Le Clay
    DN36 5AT Grimsby
    North East Lincolnshire
    Sekretär
    44 Tetney Lane
    Holton Le Clay
    DN36 5AT Grimsby
    North East Lincolnshire
    British19370290001
    MART, Frederick William
    102a Leeds Road
    YO8 4JQ Selby
    North Yorkshire
    Sekretär
    102a Leeds Road
    YO8 4JQ Selby
    North Yorkshire
    British34851760001
    READMAN, Jacqueline
    6 Clydach Grove
    Ingleby Barwick
    TS17 5DE Stockton
    Cleveland
    Sekretär
    6 Clydach Grove
    Ingleby Barwick
    TS17 5DE Stockton
    Cleveland
    British117898800001
    ALLEN, Geoffrey
    44 Tetney Lane
    Holton Le Clay
    DN36 5AT Grimsby
    North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    44 Tetney Lane
    Holton Le Clay
    DN36 5AT Grimsby
    North East Lincolnshire
    British19370290001
    BUCKTIN, Michael
    6 Mill Walk
    HU16 4RP Cottingham
    North Humberside
    Geschäftsführer
    6 Mill Walk
    HU16 4RP Cottingham
    North Humberside
    EnglandBritish37396660001
    CURRY, James Crispin Michael
    17 Leven Road
    TS15 9EY Yarm
    Stockton On Tees
    Geschäftsführer
    17 Leven Road
    TS15 9EY Yarm
    Stockton On Tees
    United KingdomBritish85349690002
    DALRYMPLE, Lawrence Andrew James
    Wold Paddock Rasen Road
    Tealby
    LN8 3XL Market Rasen
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Wold Paddock Rasen Road
    Tealby
    LN8 3XL Market Rasen
    Lincolnshire
    EnglandBritish30321480001
    EASTWOOD, Stephen John
    Threshing Barn
    Brookhouse Court Birch Cross
    ST14 8TU Uttoxeter
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Threshing Barn
    Brookhouse Court Birch Cross
    ST14 8TU Uttoxeter
    Staffordshire
    United KingdomBritish97380710001
    FREDERICK, Clayton James
    80 Parthenia Street
    Dolans Bay
    New South Wales 2229
    Australia
    Geschäftsführer
    80 Parthenia Street
    Dolans Bay
    New South Wales 2229
    Australia
    Australian76016400001
    LACEY, Michael John
    7 Hill Rise
    Elloughton
    HU15 1JG Brough
    North Humberside
    Geschäftsführer
    7 Hill Rise
    Elloughton
    HU15 1JG Brough
    North Humberside
    UkBritish20065770001
    MALONE, Mark, Captain
    Davison Avenue
    NE26 1SD Whitley Bay
    40
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Davison Avenue
    NE26 1SD Whitley Bay
    40
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    UkBritish138898280002
    MARSHALL, Kenneth William
    Rozel Hinsley Lane
    Carlton
    DN14 9PE Goole
    Geschäftsführer
    Rozel Hinsley Lane
    Carlton
    DN14 9PE Goole
    British47326140001
    MOLLER, John Leonard
    5 Magarra Place
    Seaforth
    New South Wales
    Nsw 2092
    Australia
    Geschäftsführer
    5 Magarra Place
    Seaforth
    New South Wales
    Nsw 2092
    Australia
    Australian88653690001
    NIEDERER, Marc Rudolf Pieter
    Tees Wharf, Dockside Road
    Middlesbrough
    TS3 6AB Cleveland
    Geschäftsführer
    Tees Wharf, Dockside Road
    Middlesbrough
    TS3 6AB Cleveland
    EnglandDutch165952450003
    READMAN, Jacqueline
    6 Clydach Grove
    Ingleby Barwick
    TS17 5DE Stockton
    Cleveland
    Geschäftsführer
    6 Clydach Grove
    Ingleby Barwick
    TS17 5DE Stockton
    Cleveland
    EnglandBritish117898800001
    RUTHERFORD, John David
    72 Kintore Street
    2076 Wahroonga
    N.S.W.
    Australia
    Geschäftsführer
    72 Kintore Street
    2076 Wahroonga
    N.S.W.
    Australia
    British15026700003
    RYAN, David John
    Amboise
    140 Osborne Road
    Burradoo
    2576 Nsw
    Australia
    Geschäftsführer
    Amboise
    140 Osborne Road
    Burradoo
    2576 Nsw
    Australia
    Australian76230230004
    WEBB, David Merrick
    50 Nandi Avenue
    Frenchs Forrest
    New South Wales
    Australia
    Geschäftsführer
    50 Nandi Avenue
    Frenchs Forrest
    New South Wales
    Australia
    Australian33951300004

    Hat SVITZER HUMBER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 02. Juli 2003
    Geliefert am 03. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel k/a "lady maria".
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship dated 13TH june 2001 (as defined)
    Erstellt am 03. Juli 2001
    Geliefert am 06. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with (a) the security trust deed, (b) a fixed and floating security document dated 5 june 2001 (as defined) and (c) the other finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    M.V."lady moira",registered in united kingdom,official reg/no 902685. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited,as Security Trustee Under the Securitytrust Deed Dated 1 May 2001 (As Defined)
    Transaktionen
    • 06. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady sarah" registered in the united kingdom and bearing official registration number 709350.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady morag" registered in the united kingdom and bearing official registration number 704400.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady madeleine" registered in the united kingdom and bearing official registration number 728962.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady kathleen" registered in the united kingdom and bearing official registration number 709341.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady josephine" registered in the united kingdom and bearing official registration number 901550.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady emma h" registered in the united kingdom and bearing official registration number 901550.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady elizabeth" registered in the united kingdom and bearing official registration number 389062.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady debbie" registered in the united kingdom and bearing official registration number 376899.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 24. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady constance " registered in the united kingdom and bearing official registration number 389072.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady cecilia " registered in the united kingdom and bearing official registration number 720303.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady brenda" registered in the united kingdom and bearing official registration number 709291.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady alma" registered in the united kingdom and bearing official registration number 730051.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority mortgage of a ship
    Erstellt am 13. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due for payment or which may become due for payment or which remain unpaid by the company to the chargee (for its own account or for the account of the debentureholder) in connection with (a) the security trust deed (b) a fixed and floating security document dated 05/06/01 (c) the other finance documents
    Kurze Angaben
    M.V. "lady anya" registered in the united kingdom and bearing official registration number 709339.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 05. Juni 2001
    Geliefert am 13. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys debts and liabilities due, owing or incurred by the company to any debentureholder (including the chargee as security trustee for the benefit of the debentureholders) under or in connection with any finance document (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited
    Transaktionen
    • 13. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority statutory ships mortgage
    Erstellt am 18. Dez. 1996
    Geliefert am 03. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as regulated by a ship owners agreement consituted by a shipowners form dated 1 november 1996 and the shipowners terms (as defined)
    Kurze Angaben
    Sixty-four sixty-fourth shares in the M.v "lady alma" official number 730051.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of covenant
    Erstellt am 18. Dez. 1996
    Geliefert am 24. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the principal agreement (as defined) and the security documents (as defined) including the deed of covenant
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the mortgaged property being the vessel M.v "lady alma" official number 730051 including the insurances and owners earnings (as deefined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second priority statutory mortgage
    Erstellt am 18. Dez. 1996
    Geliefert am 24. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as regulated by the principal agreement dated 1 november 1996 and the deed of covenant of even date with this deed
    Kurze Angaben
    Sixty-four sixty fourth shares in the vessel M.V. "lady alma" official number 730051.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 01. Nov. 1996
    Geliefert am 04. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal agreement (as defined) dated 1ST november 1996
    Kurze Angaben
    All company's beneficial interest and all its benefits rights and titles in and under the contract including the vessel (which means the marine safety agency class ix tug k/a yard no 118 at mc tay marine limited) and all her engines equipment and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Shipowner's form
    Erstellt am 01. Nov. 1996
    Geliefert am 04. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The company's obligations due from the company to the chargee under the shipowner's form
    Kurze Angaben
    Any moneys which may be payable to the company in accordance with the terms of any of the security documents (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 01. Nov. 1996
    Geliefert am 04. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    All the company's beneficial interest rights and titles in and under the performance guarantee including the rights to make demands and receive payments thereunder and all moneys (if any) payable by the performance gurantor in the company thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First priority statutory mortgage
    Erstellt am 29. Aug. 1991
    Geliefert am 02. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a shipowners agreement dated 4TH may 1990
    Kurze Angaben
    64/64TH shares of and in the mv. Lady josephine registered in the name of the company at the port of grimsby under official number 720314.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 08. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second priority statutory mortgage
    Erstellt am 29. Aug. 1991
    Geliefert am 02. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a financial agreement dated 4 may 1990 and a deed of covenant dated 29 august 1991
    Kurze Angaben
    64/64TH shares of and in the mv "lady josephine" registered in the name of the company at the port of grimsby under official number 720314.
    Berechtigte Personen
    • Westpac Banking Corporation
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 08. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of covenant
    Erstellt am 29. Aug. 1991
    Geliefert am 02. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All the company's interest present and future in a) the mv "lady josephine registered in the name of the company at the port of grimsby under official number 720314 (the ship) (see form 395 document M9 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Westpac Banking Corporation
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 08. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SVITZER HUMBER LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Aug. 2015Beginn der Liquidation
    21. Dez. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kerry Pearson
    Wynyard Park House Wynyard Avenue
    TS22 5TB Wynyard
    Praktiker
    Wynyard Park House Wynyard Avenue
    TS22 5TB Wynyard
    Iain Townsend
    8 High Street
    TS15 9AE Yarm
    Cleveland
    Praktiker
    8 High Street
    TS15 9AE Yarm
    Cleveland
    Peter William Gray
    Rowlands
    8 High Street
    TS15 9AE Yarm
    Stockton On Tees
    Praktiker
    Rowlands
    8 High Street
    TS15 9AE Yarm
    Stockton On Tees
    Andrew Little
    Wynyard Park House Wynyard Avenue
    TS22 5TB Wynyard
    Praktiker
    Wynyard Park House Wynyard Avenue
    TS22 5TB Wynyard

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0