WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED

WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00526365
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED?

    • (2875) /

    Wo befindet sich WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 City Square
    Leeds
    LS1 2AL
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    METRO-FLEX (U.K.) LIMITED31. Dez. 197731. Dez. 1977

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 1997

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Juni 2010

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 14. Dez. 2009

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 14. Dez. 2008

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    4 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    6 Seiten363s

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GREENE, Edward E
    523 Wyndham Hall Way
    TN 37922 Knoxville
    Tennessee
    U S A
    Sekretär
    523 Wyndham Hall Way
    TN 37922 Knoxville
    Tennessee
    U S A
    American63150880001
    SYKES, Christopher Nigel
    18 Langford Close
    Dodworth
    S75 3TP Barnsley
    South Yorkshire
    Sekretär
    18 Langford Close
    Dodworth
    S75 3TP Barnsley
    South Yorkshire
    British58629850001
    GREENE, Edward E
    523 Wyndham Hall Way
    TN 37922 Knoxville
    Tennessee
    U S A
    Geschäftsführer
    523 Wyndham Hall Way
    TN 37922 Knoxville
    Tennessee
    U S A
    American63150880001
    SCHOFIELD, John Trevor
    1245 Lakemont Road
    Villa Nova Pennsylvania
    FOREIGN
    Usa
    Geschäftsführer
    1245 Lakemont Road
    Villa Nova Pennsylvania
    FOREIGN
    Usa
    American8835010001
    TEDONE, Daniel S
    8715 Hopemont Way
    TN 37923 Knoxville
    Tennessee
    Usa
    Geschäftsführer
    8715 Hopemont Way
    TN 37923 Knoxville
    Tennessee
    Usa
    Usa63155150001
    GILL, Paul Michael
    10 Ringinglow Road
    S11 7PP Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    10 Ringinglow Road
    S11 7PP Sheffield
    South Yorkshire
    British30172320001
    HELLER, Carole Anne
    Burgmatt 15
    Postfach 235
    Ch 6340 Baar 1
    Switzerland
    Sekretär
    Burgmatt 15
    Postfach 235
    Ch 6340 Baar 1
    Switzerland
    Swiss56771580002
    JOHNSON, Frederick Charles
    25472 Remesa Drive
    Mission Viejo
    FOREIGN
    California Ca92691
    Usa
    Sekretär
    25472 Remesa Drive
    Mission Viejo
    FOREIGN
    California Ca92691
    Usa
    American18217480001
    LEE, James Edward
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    Sekretär
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    British10085240001
    MACMILLAN, Frederick Wight
    884 Pueblo Drive
    Franklin Lakes
    New Jersey 07417
    America
    Sekretär
    884 Pueblo Drive
    Franklin Lakes
    New Jersey 07417
    America
    American15395010001
    BEAL, Charles Stephen
    30952 Via Mirador
    San Juan Capistrano
    92675 California
    Usa
    Geschäftsführer
    30952 Via Mirador
    San Juan Capistrano
    92675 California
    Usa
    UsaBritish10085250004
    BLANCHFLOWER, Michael Harry
    13 Button Hill
    Ecclesall
    S11 9HF Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    13 Button Hill
    Ecclesall
    S11 9HF Sheffield
    South Yorkshire
    British30247220001
    GILL, Paul Michael
    10 Ringinglow Road
    S11 7PP Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Ringinglow Road
    S11 7PP Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish30172320001
    HEARNDEN, Trevor Henry
    Juniper Fen Street
    Old Buckenham
    NR17 1SR Attleborough
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Juniper Fen Street
    Old Buckenham
    NR17 1SR Attleborough
    Norfolk
    British16467170001
    HELLER, Ralph Nathan
    Burgmatt 15
    Postfach 235
    Ch 6340 Barr 1
    Switzerland
    Geschäftsführer
    Burgmatt 15
    Postfach 235
    Ch 6340 Barr 1
    Switzerland
    SwitzerlandBritish18942930001
    HUTA, Henry Nicholaus
    30001 Hillside Terrace
    San Juan Capistrano
    92675 California
    Usa
    Geschäftsführer
    30001 Hillside Terrace
    San Juan Capistrano
    92675 California
    Usa
    American15737660001
    LEE, James Edward
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    7 Ashford Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 8RQ Dronfield
    Derbyshire
    British10085240001
    LINDLEY, Peter Malcolm
    46 Everard Avenue
    Bradway
    S17 4LZ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    46 Everard Avenue
    Bradway
    S17 4LZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish6351630001
    LOWELL, Michael Joseph
    32942 Barque Way
    92624 Dana Point
    California 92624
    Usa
    Geschäftsführer
    32942 Barque Way
    92624 Dana Point
    California 92624
    Usa
    American38240100001

    Hat WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Juni 1999
    Geliefert am 07. Juli 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 25. Feb. 1999
    Geliefert am 17. März 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee, the lenders (as defined) or any of them under the guarantee dated 28TH july 1995 the loan agreement dated 30TH january 1998 and the security agreements (as defined in the loan agreement) and under this debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wexford Management Llc
    Transaktionen
    • 17. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 1999Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 101. Juli 2010Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Deed of guarantee and assignment
    Erstellt am 13. Jan. 1999
    Geliefert am 03. Feb. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £637,310 due or to become due from mannesmann demag,a german company,with all other sums to the chargee under the merger agreement dated 9TH november 1998 (as defined)
    Kurze Angaben
    All right,title and interest in the net proceeds of the mannesmann receivable and all sums payable thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wexford Management Llc,as Representative of the Shareholders of Wes (As Defined)
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Aug. 1998
    Geliefert am 11. Aug. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed equitable charge on the trade account and the security account and ll RE8CEIVABLES and a floating charge the floating assets and all the undertakings and assets of the company.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile LTD
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on cash deposits
    Erstellt am 06. Aug. 1998
    Geliefert am 11. Aug. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits held for the company on the trade and margin accounts.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile LTD
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 08. Apr. 1998
    Geliefert am 16. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. März 1998
    Geliefert am 01. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 17. Juli 1997
    Geliefert am 18. Juli 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the fixed and floating charge
    Kurze Angaben
    Fixed equitable charge the trade account and the security account and all receivables (all as defined therein) and a floating charge the floating assets and any receivable other than those charged above.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile LTD
    Transaktionen
    • 18. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. Juli 1997
    Geliefert am 05. Juli 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the fixed and floating charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge the trade account & the security account and all receivables; & by way of floating charge the floating assets and any receivable to the extent that the charge thereon specified above shall be ineffective as a fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 23. Mai 1997
    Geliefert am 05. Juni 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies together with interest at 5% above tsb bank base rate per annum from time to time and other monies covenanted to be paid by the company to the chargee under the terms of this fixed and floating charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge the trade account & the security account and all receivables; & by way of floating charge, the floating assets and; any receivable to the extent that the charge thereon specified by way of fixed equitable charge above shall be ineffective as a fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile LTD
    Transaktionen
    • 05. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Mai 1997
    Geliefert am 21. Mai 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the fixed and floating charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge the trade account and the security account ands by way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 21. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 09. Mai 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The trade account & the security account and by way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 09. Mai 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge the trade account & the security account and by way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. März 1997
    Geliefert am 11. März 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of blanket indemnity dated 22ND november 1996 or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed and equitable charge over the trade account and security account and all receivables and by way of floating charge over the floating assets and any receivable to the extent that the charge thereon specified above shall be ineffective as a fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 11. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. März 1997
    Geliefert am 11. März 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the blanket indemnity dated 22ND november 1996 or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed and equitable charge over the trade account and security account and all receivables and by way of floating charge over the floating assets and any receivable to the extent that the charge thereon specified above shall be ineffective as a fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 11. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 11. Dez. 1996
    Geliefert am 12. Dez. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of blanket indemnity dated 22 november 1996 or otherwise
    Kurze Angaben
    The trade account and the security account and all receivables (as therein defined) and a floating charge the floating assets and any receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile LTD
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 25. Sept. 1996
    Geliefert am 26. Sept. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of blanket indemnity dated the 13TH june 1996 or otherwise
    Kurze Angaben
    1. by way of fixed equitable charge the trade account and the security account and all receivables; and 2. by way of floating charge a) the floating assets and; b) any receivable to the extent that the charge thereon specified in clause 1. above shall be ineffective as a fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile LTD
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 25. Sept. 1996
    Geliefert am 26. Sept. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of blanket indemnity dated the 13TH june 1996 or otherwise
    Kurze Angaben
    1. by way of fixed equitable charge the trade account and the security account and all receivables; and 2. by way of floating charge a) the floating assets and; b) any receivable to the extent that the charge thereon specified in clause 1. above shall be ineffective as a fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile LTD
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating
    Erstellt am 06. Aug. 1996
    Geliefert am 13. Aug. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a blanket indemnity dated 13TH june 1996 or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of floating charge the floating assets and any receivable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 14. Juni 1996
    Geliefert am 17. Juni 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of blanket indemnity dated 6/12/94
    Kurze Angaben
    Fixed equitable charge the trade account and the security account and all receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 17. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 13. Juni 1996
    Geliefert am 14. Juni 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of blanket indemnity dated 13TH june 1996 or otherwise
    Kurze Angaben
    Fixed equitable charge the trade account and the security account and all recievables and by way of floating charge the floating assets and any recieva ble to the extent that the charge thereon specified in clause 1 above shall be ineffective as a fixed charge.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 14. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 18. Dez. 1995
    Geliefert am 20. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 13. Jan. 1995
    Geliefert am 20. Jan. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed of blanket indemnity dated 6TH december 1994 or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge the trade account and the security account and all receivables and by way of floating charge the assets & any receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 1994
    Geliefert am 19. Dez. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed of blanket indemnity dated 6TH december 1994 or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge the trade account & the security account & all receivables & by way of floating charge the floating assets & any receivable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London & International Mercantile Limited
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and charge
    Erstellt am 26. Feb. 1993
    Geliefert am 10. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the "loan agreement" as defined in the "charge"
    Kurze Angaben
    See doc ref M114L for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America National Trust and Savings Association
    Transaktionen
    • 10. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WAHLCO ENGINEERED PRODUCTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Feb. 1999Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Angus Matthew Martin
    Deloitte & Touche
    10-12 East Parade
    LS1 2AJ Leeds
    Praktiker
    Deloitte & Touche
    10-12 East Parade
    LS1 2AJ Leeds
    Ian Brown
    10-12 East Parade
    Leeds
    LS1 2AJ
    Praktiker
    10-12 East Parade
    Leeds
    LS1 2AJ

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0