NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00533432 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15th Floor 6 Bevis Marks EC3A 7BA London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lisa Susanne Gray als Geschäftsführer am 15. Juli 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Apr. 2022
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sheraz Afzal als Geschäftsführer am 06. Apr. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Marie-Anne Bousaba als Direktor am 29. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN England zum 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA am 12. Nov. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Lisa Gray als Direktor am 06. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sheraz Afzal als Direktor am 06. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Justin Staadecker als Geschäftsführer am 06. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew James Smith als Geschäftsführer am 08. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tony Deakin als Geschäftsführer am 01. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ England zum Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN am 12. Sept. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHLEY, Jonathan | Geschäftsführer | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor England | England | American | 243850150001 | |||||
| BOUSABA, Marie-Anne | Geschäftsführer | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor England | United Kingdom | Australian | 293005440001 | |||||
| BIONDI, Lorna | Sekretär | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | 196292540001 | |||||||
| FISHER, Mark | Sekretär | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| FISHER, Mark | Sekretär | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| GOLD, Nick | Sekretär | 126 Hamilton Terrace St John's Wood NW8 9UT London | British | 111562560001 | ||||||
| GREGG, Terence Michael | Sekretär | 6 Chilterns End Close RG9 1SQ Henley On Thames Oxfordshire | British | 64357220001 | ||||||
| HARRINGTON, Nicholas Joseph | Sekretär | 9 Kingsmead Avenue KT4 8XB Worcester Park Surrey | British | 1273670001 | ||||||
| MCKENZIE, Robbie | Sekretär | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 195400050001 | |||||||
| PAGE, Elizabeth | Sekretär | Flat 3 5 St Leonards Road, Ealing W13 8PN London | British | 34006010001 | ||||||
| PRIOR, Mark Lee | Sekretär | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 178737250001 | |||||||
| REID, Michael John | Sekretär | 49 Waldemar Avenue W13 9PZ London | Irish | 950490001 | ||||||
| RIVERS, Paul Edward | Sekretär | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | British | 62321110002 | ||||||
| WALTON, Caroline Debra | Sekretär | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | British | 151330230001 | ||||||
| ADAMS, David Alexander Robertson | Geschäftsführer | Applegarth Three Elm Lane Hadlow TN11 0AB Tonbridge Kent | England | British | 55757700003 | |||||
| AFZAL, Sheraz | Geschäftsführer | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor England | United Kingdom | British | 251073350001 | |||||
| ATTALLAH, Naim Ibrahim | Geschäftsführer | Flat 15 51 South Street W1Y 5PA London | United Kingdom | British | 25646240001 | |||||
| BERKMEN, Gillian | Geschäftsführer | Orchard View 27 Woodhill Avenue SL9 8DP Gerrards Cross South Buckinghamshire | Gb | British | 92154270001 | |||||
| BROWN, Andrew Saville | Geschäftsführer | 123 Edenfield Gardens KT4 7DX Worcester Park Surrey | United Kingdom | British | 69874610002 | |||||
| BRYAN, Robert Andrew | Geschäftsführer | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | British | 122733810001 | |||||
| CLAYMAN, Paul Sidney | Geschäftsführer | 18 Keepier Wharf 12 Narrow Street E14 8DH London | British | 14436120006 | ||||||
| COOPER, Caroline | Geschäftsführer | 222 Caraway 2 Cayenne Court 32 Shad Thames SE1 2PP London | British | 92733900001 | ||||||
| COREPAL, Sanjiv Kumar | Geschäftsführer | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | United Kingdom | British | 205239750001 | |||||
| DAHL, Ian Xavier | Geschäftsführer | 2 Heathfield Lodge Carron Lane GU29 9LD Midhurst West Sussex | British | 66486140001 | ||||||
| DEAKIN, Tony | Geschäftsführer | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | United Kingdom | British | 210862440001 | |||||
| ERICKSON, Eric George | Geschäftsführer | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | Usa | 224104020001 | |||||
| EVANS, Nicholas David | Geschäftsführer | 6 Raddington Road W10 5TF London | United Kingdom | British | 57490310002 | |||||
| FILECCIA, Piero | Geschäftsführer | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | British | 116096800001 | |||||
| FISHER, Mark | Geschäftsführer | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| GOLD, Nicholas Paul | Geschäftsführer | 126 Hamilton Terrace St Johns Wood NW8 9UT London | England | British | 53606570002 | |||||
| GRAY, Lisa Susanne | Geschäftsführer | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor England | England | British | 262153810001 | |||||
| GREGG, Terence Michael | Geschäftsführer | 6 Chilterns End Close RG9 1SQ Henley On Thames Oxfordshire | British | 64357220001 | ||||||
| HIBBERD, Roy Wayne | Geschäftsführer | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | Usa | United States | 158609380001 | |||||
| HOWARD, Stuart John | Geschäftsführer | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | England | British | 192909600002 | |||||
| JOHNSON-POENSGEN, Douglas Howard | Geschäftsführer | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | England | British | 192481000001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmwsl 488 Limited | 06. Apr. 2016 | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat NATHAN & CO (BIRMINGHAM) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 22. Nov. 2005 Geliefert am 06. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties | Erstellt am 05. Juni 2001 Geliefert am 13. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company amnd the agent | Erstellt am 24. Dez. 1998 Geliefert am 02. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 24. Dez. 1998 Geliefert am 02. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (and each of them) which shall for the avoidance of doubt include the debenture and guarantee set out therein | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 29. Juni 1995 Geliefert am 06. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All of each charging companys right title and interest in and to "the real property" as defined in 395 together with fixed charge all right title and interest in and to the "investments" (as defined in the security assignment) and all rights and assets belonging to the relevant charging company deriving from such investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0