VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00535340 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VIBROPLANT LIMITED | 03. Juli 1954 | 03. Juli 1954 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Keith John Winstanley als Direktor am 01. Jan. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Anna Catherine Bielby als Direktor am 01. Jan. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2023
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Andrew Stothard als Geschäftsführer am 30. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Sarah Elizabeth Jones als Sekretär am 01. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Andrew Stothard als Sekretär am 30. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2023 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Sarah Elizabeth | Sekretär | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | 314182540001 | |||||||
| BIELBY, Anna Catherine | Geschäftsführer | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 309437440001 | |||||
| PILKINGTON, Jeremy Frederic George | Geschäftsführer | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 3408250002 | |||||
| WINSTANLEY, Keith John | Geschäftsführer | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 318037220001 | |||||
| PARTRIDGE, Neil Russell | Sekretär | Cranford Lands Lane HG5 8DH Knaresborough North Yorkshire | British | 43666120001 | ||||||
| STOTHARD, Neil Andrew | Sekretär | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | British | 40008250003 | ||||||
| SWARBRICK, Rodney Victor | Sekretär | 7 Mulberry Avenue Penwortham PR1 0LL Preston | British | 44604310001 | ||||||
| WOOLLEY, Eric Ryhs | Sekretär | 8 Hereford Road HG1 2NP Harrogate North Yorkshire | British | 22806550002 | ||||||
| PARTRIDGE, Neil Russell | Geschäftsführer | Cranford Lands Lane HG5 8DH Knaresborough North Yorkshire | British | 43666120001 | ||||||
| STOTHARD, Neil Andrew | Geschäftsführer | C/O Vp Plc Central House Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate North Yorkshire | England | British | 40008250003 | |||||
| WOOLLEY, Eric Ryhs | Geschäftsführer | 8 Hereford Road HG1 2NP Harrogate North Yorkshire | British | 22806550002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vp Plc | 06. Apr. 2016 | Otley Road Beckwithshaw HG3 1UD Harrogate Central House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat VIBROPLANT INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. März 1998 Geliefert am 03. Apr. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. März 1982 Geliefert am 05. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific eqitable charge over all f/h & l/h properties and or the proceeds of the sale thereof, fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security scottish form | Erstellt am 15. März 1972 Geliefert am 29. März 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag A standard security which was presented for registration of sasines on 17TH march 1972 for securing the monies due from fred pilkington and son limited to the chargee secured by a charge dated 13.5.69 | |
Kurze Angaben A fixed charge a time floating charge onqueendykes industrial estate broxbourne etc (see doc 43 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge effecting substitution of security. | Erstellt am 29. Nov. 1971 Geliefert am 06. Dez. 1971 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from fred pilkington and son limited to the charge secured by a charge dated 23/5/69 | |
Kurze Angaben First fixed charge on freehold property at boblers mill, nottingham, t/n W123063 with landlords fixtures and a first floating charge on the space heating equipment. (See docs 41). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Disposition | Erstellt am 17. März 1969 Geliefert am 05. Dez. 1969 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 17 march 69 disposition which was presened for registration of registered of sasines on 16 sept 69 for securing £39,298. | |
Kurze Angaben 2.769 acres of leed property at greendykes industrial estate, broxbum west lothian. (37). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Disposition | Erstellt am 17. März 1969 Geliefert am 20. Okt. 1969 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Disposition which was presented for registration at register of sasines on 16 sept. 69 for securing sterling pounds 39298 | |
Kurze Angaben 2.769 acres of lead property at greendykes industrial estate, broxbum west lothian. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0