KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00540556 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St Anns Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VENT MASTER (EUROPE) LIMITED | 21. Juni 1996 | 21. Juni 1996 |
| BERISFORD BAKER STREET LIMITED | 01. März 1995 | 01. März 1995 |
| BERISFORD TREASURY LIMITED | 10. Feb. 1995 | 10. Feb. 1995 |
| BERISFORD TREASURY LIMITED | 09. Mai 1989 | 09. Mai 1989 |
| S & W BERISFORD TREASURY LIMITED | 29. Okt. 1987 | 29. Okt. 1987 |
| ASTON METAL CO LIMITED | 12. Nov. 1954 | 12. Nov. 1954 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 09. Aug. 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Kachmer als Geschäftsführer am 03. Apr. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Graham Philip Brisley Veal als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Blades als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Doerr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Adrian David Gray als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Sekretär | St Ann's Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne | 94529700001 | |||||||
| GRAY, Adrian David | Geschäftsführer | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||
| JONES, Maurice Delon | Geschäftsführer | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||
| BURROWES, Rosemary Anne | Sekretär | 108c Bramley Road Oakwood N14 4HT London | British | 49687740001 | ||||||
| HOOPER, David Ross | Sekretär | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Sekretär | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||
| BUTLER, Peter Robert | Geschäftsführer | Gifford House 22 Chalklands Howe Green CM2 7TH Chelmsford Essex | British | 34707070001 | ||||||
| CUTHBERTSON, George Brian | Geschäftsführer | 39 The Gardens WD1 3DN Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | 6996370001 | |||||
| DOERR, Thomas | Geschäftsführer | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||
| FINDLER, Jonathan Paul | Geschäftsführer | Westwood House Heathfield Avenue SL5 0AL Ascot Berkshire | British | 45532880003 | ||||||
| GORDON, Alastair Neil | Geschäftsführer | 64 Castelnau SW13 9EX London | England | British | 61620710001 | |||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||
| JONES, Eric Alan | Geschäftsführer | Stidolphs Old Farm House Eggpie Lane Sevenoaks TN4 6NP Weald Kent | British | 27290300001 | ||||||
| KACHMER, Michael James | Geschäftsführer | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||
| O'CONNOR, Patrick Finbarr | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 66 Cumberland Mills Square Saunders Ness Road E14 3BJ Isle Of Dogs London | British/Irish | 900010100001 | ||||||
| WILSON, Andrew George Richard | Geschäftsführer | Cononley Hall Main Street Cononley BD20 8LJ Skipton West Yorkshire | British | 47433990002 | ||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310650003 | |||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Geschäftsführer | Washington House 40-41 Conduit Street W1S 2YQ London | 75310650002 | |||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 | |||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Geschäftsführer | 1 Farnham Road GU2 4RG Guildford Surrey | 75310610001 |
Hat KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Erstellt am 11. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Erstellt am 20. Feb. 2002 Geliefert am 08. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Erstellt am 20. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 13. Aug. 1999 Geliefert am 27. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations due or to become due from each credit party from time to time to the facility agent, each issuing bank, the lenders or any of them or their respective affiliates under any credit document or secured hedge agreement | |
Kurze Angaben All investment property: all right, title and interest of the company in all shares of capital stock owned by any us subsidiary ,the pledge agreement and the certificates, the collateral account together with all amounts on deposit from time to time in such deposit account. All books, records, ledger cards, files, computer programs, tapes, discs and related data processing software that at any time evidence or contain information relating to any of the collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment. | Erstellt am 30. Sept. 1991 Geliefert am 16. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for each bank (as defined) and barclays bank PLC (the replacement agent) under the terms of the debenture dated 26.9.90 | |
Kurze Angaben All the company's rights in the book debts & other debts, licenses, coments, authorisations etc. (see form 395 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Sept. 1990 Geliefert am 09. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obliger (as therein defiend) to national westminster bank PLC (the second security agent) and the banks (as threin defined) or any at them under the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from berisford international PLC under the subcrdination guarantee | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Sept. 1990 Geliefert am 09. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the security agent) and the banks (aas therein defined) or any of them under each of the indebtedness agreements | |
Kurze Angaben Nsee from 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0