PAYLESS PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PAYLESS PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00543407 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
- (7012) /
Wo befindet sich PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 100 Barbirolli Square M2 3EY Manchester Greater Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PAYLESS D.I.Y. LIMITED | 10. Dez. 1985 | 10. Dez. 1985 |
| TUBBS BUILDING SUPPLIES LIMITED | 01. Juli 1985 | 01. Juli 1985 |
| PAYLESS D.I.Y. LIMITED | 01. Jan. 1983 | 01. Jan. 1983 |
| MARLEY HOMECARE LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
| MARLEY RETAIL LIMITED | 17. Jan. 1955 | 17. Jan. 1955 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 21. Feb. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 01. Mai 2012 | 27 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Nov. 2011 | 36 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 97 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 95 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B | 9 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William Grimsey am 13. Mai 2011 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Gawsworth House Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6XB am 11. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Robbins als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Dawn Michelle Wilkinson am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Thomas Christopher Morgan am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Bird als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Patrick Gladwin am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Brian Keith Robbins am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 21. Feb. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Brian Keith Robbins als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Thomas Christopher Morgan als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Unitt als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Penelope Teale als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 22. Feb. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PAYLESS PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKINSON, Dawn Michelle | Sekretär | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire United Kingdom | British | 105435010001 | ||||||
| GLADWIN, Robert Patrick | Geschäftsführer | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | British | 130288970001 | |||||
| GRIMSEY, William | Geschäftsführer | 9 The Avenue WD7 7DG Radlett Tall Timbers Hertfordshire | United Kingdom | British | 50647840004 | |||||
| MORGAN, Thomas Christopher | Geschäftsführer | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | British | 152428250002 | |||||
| BANKS, David | Sekretär | Ground Floor Flat Redland Green Road BS6 7HE Bristol Avon | British | 87235970001 | ||||||
| FENNELL, Sonia | Sekretär | Gilliver Cottage Gilliver Lane Clipston On The Wolds NG12 5PD Nottingham | British | 9591230004 | ||||||
| HOSKINS, William | Sekretär | 11 Grange Court Road AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | 121893830001 | ||||||
| HUGHES, Gerard Maxwell | Sekretär | 53 Chesilton Road Fulham SW6 5AA London | British | 70698270002 | ||||||
| RIMMER, Barbara | Sekretär | 28 Chapel Lane Hale Barns WA15 0HN Altrincham Cheshire | British | 76973560002 | ||||||
| STEVENS, Philip Alan | Sekretär | 31 Summit Drive IG8 8QW Woodford Green Essex | British | 9581300001 | ||||||
| WILLIAMS, David Robert | Sekretär | 15 St Stephens Road CH42 8PP Prenton Merseyside | British | 157062220001 | ||||||
| WILSON, Geoffrey Charles | Sekretär | Broadoaks 237 Seabridge Lane ST5 3TB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 72996700001 | ||||||
| ARCHER, William Ernest | Geschäftsführer | The Priory 2 Astley Close WA16 8GJ Knutsford Cheshire | British | 15170380004 | ||||||
| BANKS, David | Geschäftsführer | Ground Floor Flat Redland Green Road BS6 7HE Bristol Avon | British | 87235970001 | ||||||
| BIRD, Richard Sidney | Geschäftsführer | 80 Wolsey Road HA6 2EH Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 111500210002 | |||||
| BOWE, Alan Laurence | Geschäftsführer | Church View Farmhouse Church Lane, Osgathorpe LE12 9SY Loughborough Leicestershire | British | 64241650002 | ||||||
| COHEN, John Alexander | Geschäftsführer | 7 Rectory Gardens Wollaton NG8 2AR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 25406220001 | |||||
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Geschäftsführer | 3 Cottage Farm Close Osgathorpe LE12 9UE Loughborough Leicestershire | British | 52040210002 | ||||||
| GILES, Alan James | Geschäftsführer | Tanglewood Crowsley Road RG9 3LE Shiplake Oxfordshire | England | British | 156046020001 | |||||
| HOOD, John | Geschäftsführer | Briarwood 15 Twatling Road Barnt Green B45 8HX Birmingham West Midlands | British | 39644740001 | ||||||
| HOSKINS, William | Geschäftsführer | 11 Grange Court Road AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | 121893830001 | ||||||
| JOHNSON, Stephen Richard | Geschäftsführer | The Old Vicarage Lower Dunsforth YO26 9SA York | England | British | 87398750001 | |||||
| MCDOUGAL, Robert Hugh | Geschäftsführer | 41 Tensing Close Great Sankey WA5 5AN Warrington Cheshire | British | 15170390002 | ||||||
| MORTON, Ivor Malcolm | Geschäftsführer | Lysander 8 Pine Close Shottery CV37 9FB Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | 30725390003 | ||||||
| MURRAY, Stephan Peter | Geschäftsführer | Red Brick Barn Caythorpe NG14 7EB Nottingham Nottinghamshire | British | 53490630001 | ||||||
| PIGGOTT, Kenneth Stanton | Geschäftsführer | 172 Loughborough Road NG11 6LF Ruddington Nottingham | United Kingdom | British | 144061950001 | |||||
| RADFORD, Kenneth Thomas | Geschäftsführer | 21 Melton Road Tollerton NG12 4EL Nottingham | British | 47191400001 | ||||||
| ROBBINS, Brian Keith | Geschäftsführer | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | American | 153559370002 | |||||
| RUSSELL, Stephen George | Geschäftsführer | The Manor Barn 19b Far Street Wymeswold LE12 6TZ Loughborough Leicestershire | British | 145267530001 | ||||||
| SCRIBBINS, Rodney Martin | Geschäftsführer | The Hemploe Hemploe Road NN6 6HF Welford Northampton | England | British | 98160250001 | |||||
| SINCLAIR, Jonathan Stuart | Geschäftsführer | 57 Hallfields Edwalton NG12 4AA Nottingham | British | 45080280003 | ||||||
| TEALE, Penelope Jane | Geschäftsführer | 1 Weldon Rise Off Pitcher Lane MK5 8BW Loughton Milton Keynes | United Kingdom | British | 126053080001 | |||||
| THOMAS, Shelley Frances | Geschäftsführer | Everest Road SK14 4DX Hyde Woodside Farm Cheshire | United Kingdom | British | 133244600001 | |||||
| UNITT, Andrew Vaughan | Geschäftsführer | 64 Main Street LE74 4UU Cossington Hollycroft Leicester | England | British | 182500750001 | |||||
| UNITT, Andrew Vaughan | Geschäftsführer | 64 Main Street LE74 4UU Cossington Hollycroft Leicester | England | British | 182500750001 |
Hat PAYLESS PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security accession deed | Erstellt am 22. Feb. 2007 Geliefert am 06. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 19. Aug. 1998 Geliefert am 03. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any group company (as therein defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries, as therein defined) under the banking documents and the mezzanine loan agreement (both as therein defined) whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise and in each case under the working capital facility letter | |
Kurze Angaben F/H property known as bonehill road tamworth t/n SF319160, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 13. Nov. 1968 Geliefert am 02. Dez. 1968 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Trust deed for further securing £5,000,000 debenture stock of the marley tile (holding) company LTD. Secured by two trust deeds dated 14/2/58 & 8/5/63 respectively. | |
Kurze Angaben Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PAYLESS PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0