HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00544265 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hazlehead Crowedge S36 4HG Sheffield South Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| STONEWARE LIMITED | 05. Feb. 1955 | 05. Feb. 1955 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr John Sage als Direktor am 31. Juli 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Calum James Forsyth als Geschäftsführer am 31. Juli 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Taylor als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Barker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Paul William | Sekretär | 13 St Peters Grove YO30 6AQ York | British | 62180340002 | ||||||
| SAGE, John | Geschäftsführer | Latimer Road Cropston LE7 7GP Leicester 19 United Kingdom | England | British | 171410140001 | |||||
| TAYLOR, Paul William | Geschäftsführer | 13 St Peters Grove YO30 6AQ York | United Kingdom | British | 62180340002 | |||||
| PHILLIPS, Robert Glyn | Sekretär | 23 Mead Way Kirkburton HD8 0TG Huddersfield West Yorkshire | British | 842980001 | ||||||
| BARKER, Keith Stuart | Geschäftsführer | 12 Tan House Lane Parbold WN8 7HG Wigan Greater Manchester | England | British | 110773520001 | |||||
| BARNETT, Michael David | Geschäftsführer | 26 Brough Road South Cave HU15 2BX Brough North Humberside | United Kingdom | British | 102557780001 | |||||
| BEEVER, Robert Neville | Geschäftsführer | Dalveen Woodhead Road Holmfirth HD7 1PX Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 1646430001 | |||||
| BIRD, Stephen Clive | Geschäftsführer | South End Cottage Orleans Road TW1 3BL Twickenham Middlesex | British | 47512480003 | ||||||
| BROSSET, Michel, Dr | Geschäftsführer | Am Sportplatz 6 Monheim/Rhein D-40789 Germany | French | 75143240001 | ||||||
| DOE, Brian | Geschäftsführer | Whiterails Kington Langley SN15 5NS Chippenham Wiltshire | British | 30733690001 | ||||||
| FORSYTH, Calum James | Geschäftsführer | Galloping Lane Paddlebrook Barns Ditchford On Fosse GL56 9QT Moreton In Marsh The Stables Gloucestershire | England | Uk | 172355700002 | |||||
| GALE, Paul Nicolas | Geschäftsführer | Ash Cottage Upper Wilshaw HD7 3EA Holmfirth West Yorkshire | British | 72881120001 | ||||||
| GORANSSON, Rolf Claes Erik | Geschäftsführer | Unter Den Ulmen 1 50968 Koln Germany | Sweden | 73403360003 | ||||||
| HASKELL, Peter | Geschäftsführer | 1 Clarel Street Penistone S30 6AU Sheffield South Yorkshire | British | 1646450001 | ||||||
| HOUBEN, Philippus Petrus Franciscus Clemens | Geschäftsführer | Zuider Stationsweg 2d 2061 He Bloemendaal The Netherlands | Netherlands | Dutch | 71084460001 | |||||
| LEMON, David Edward Leonard | Geschäftsführer | 6 Hillcrest Avenue South Normanton DE55 3NR Alfreton Derbyshire | British | 2649630001 | ||||||
| PHILLIPS, Robert Glyn | Geschäftsführer | 23 Mead Way Kirkburton HD8 0TG Huddersfield West Yorkshire | British | 842980001 | ||||||
| REDDICK, Terence William | Geschäftsführer | Shires Rest Gainsborough Road DN10 5DF Drakeholes | British | 92835860001 | ||||||
| SPRATT, Quentin Rodney | Geschäftsführer | Orchard Farm Brow Lane Antrobus CW9 6JY Northwich Cheshire | United Kingdom | British | 60606400001 | |||||
| TAYLOR, Andrew Rankine | Geschäftsführer | Highfield Hall 306 Barnsley Road WF2 6AX Sandal | England | British | 158807800001 | |||||
| THOMPSON, Kenneth | Geschäftsführer | 105 Castle Rock Drive LE67 4SE Coalville Leicestershire | British | 1680650001 |
Hat HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 13. Sept. 2005 Geliefert am 23. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the afforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge,any real property,the charged deposits and all investments,shares and related rights.assignment,the insurances and the assigned deposits.floating charge,undertaking and assets.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Apr. 2002 Geliefert am 30. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to each beneficiary and all other money and obligations due or to become due by each other company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including (I) vaillant house,medway city estate,trident close,rochester; K602936; (ii) land on the east side of dunster road,chelmsley wood,birmingham,west midlands; WM24946; (iii) unit D1,lowfields business park,elland,west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pik debenture | Erstellt am 18. Apr. 2002 Geliefert am 30. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to each beneficiary and all other money and obligations due or to become due by each other company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including (I) vaillant house,medway city estate,trident close,rochester; K602936; (ii) land on the east side of dunster road,chelmsley wood,birmingham,west midlands; WM24946; (iii) unit D1,lowfields business park,elland,west yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Dez. 1980 Geliefert am 13. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10,901.18 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future of the chargeing subsitionery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HEPWORTH BUILDING PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0