SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED

SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00549109
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Long Marston
    Nr Stratford Upon Avon
    CV37 8AQ Warwickshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SIMS BIRD METALS LIMITED31. Juli 199531. Juli 1995
    BIRDS COMMERCIAL METALS LIMITED 12. Mai 195512. Mai 1955

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Bescheinigung über die Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    1 SeitenCERT15

    legacy

    4 SeitenOC138

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Final dividend 27/11/07
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    legacy

    1 Seiten652a

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006

    7 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2005

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2004

    7 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2003

    7 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Wer sind die Geschäftsführer von SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILLIAMS, David Michael
    Woodgate 1 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    Woodgate 1 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British63200960003
    BIRD, William Thomas
    Tre Evan House
    Llangarron
    HR9 6PR Ross On Wye
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Tre Evan House
    Llangarron
    HR9 6PR Ross On Wye
    Herefordshire
    EnglandBritish69794010007
    ELLIOTT, John Henry
    Oak Priors
    Matthews Close
    CV37 6FR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    Oak Priors
    Matthews Close
    CV37 6FR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British19153440001
    WHITTAKER, John Royston
    5 Chasely Crescent
    Up Hatherley
    GL51 3RY Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    5 Chasely Crescent
    Up Hatherley
    GL51 3RY Cheltenham
    Gloucestershire
    British93437660001
    BIRD, Anthony Patrick Michael
    Upper Billesley
    CV37 9RH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Upper Billesley
    CV37 9RH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish3264880001
    BIRD, Brian Francis
    Bertholey
    Llantrisant
    NP15 1LR Usk
    Monmouthshire
    Geschäftsführer
    Bertholey
    Llantrisant
    NP15 1LR Usk
    Monmouthshire
    EnglandBritish107684500001
    BIRD, Janet Eleanor
    Upper Billesley
    CV37 9RH Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Upper Billesley
    CV37 9RH Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish6116520001
    BIRD, Terence John
    51 Evesham Street
    B49 5DS Alcester
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    51 Evesham Street
    B49 5DS Alcester
    Warwickshire
    British42447750001
    BIRD, Walter Thomas
    Tidenham Chase Court
    Tidenham Chase
    NP6 7JN Chepstow
    Gwent
    Geschäftsführer
    Tidenham Chase Court
    Tidenham Chase
    NP6 7JN Chepstow
    Gwent
    British3264890002
    CRABB, John
    36 Cowdroy Avenue
    Cammeray
    New South Wales 2062
    Australia
    Geschäftsführer
    36 Cowdroy Avenue
    Cammeray
    New South Wales 2062
    Australia
    Australian69623970001
    CUNNINGHAM, Ross Brodie
    22a Upper Avenue Road
    NSW 2088 Mosman
    New South Wales
    Australia
    Geschäftsführer
    22a Upper Avenue Road
    NSW 2088 Mosman
    New South Wales
    Australia
    Australian47252680001
    ELLIOTT, John Henry
    Oak Priors
    Matthews Close
    CV37 6FR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Oak Priors
    Matthews Close
    CV37 6FR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish19153440001
    GULLIVER, Russell Keith John
    19 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    19 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Australian44620650002
    LAWLEY, Keith David
    Meadow Views
    Llantrissant
    NP15 1LG Usk
    Gwent
    Geschäftsführer
    Meadow Views
    Llantrissant
    NP15 1LG Usk
    Gwent
    British91413240001
    MARSHALL, Michael George
    Abbotts Ground Cottage
    Broad Marston Lane
    GL55 6SJ Mickleton
    Glos
    Geschäftsführer
    Abbotts Ground Cottage
    Broad Marston Lane
    GL55 6SJ Mickleton
    Glos
    British16614830001
    SUTCLIFFE, Jeremy Leigh
    26 Prince Albert Road
    NSW 2088 Mosman
    New South Wales
    Australia
    Geschäftsführer
    26 Prince Albert Road
    NSW 2088 Mosman
    New South Wales
    Australia
    British50262610002
    WHEELER, David Kenneth Anthony
    13 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    13 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    British70375130001

    Hat SIMSMETAL UK (MIDWEST) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 07. Juni 1995
    Geliefert am 15. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Commonwealth Bank of Australia
    Transaktionen
    • 15. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 19. Juli 1993
    Geliefert am 23. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £37,253.10
    Kurze Angaben
    All sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 23. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit application
    Erstellt am 21. Mai 1992
    Geliefert am 29. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £44,755-80 under the terms of the credit ap@lication
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See form 395 relevant to this charge.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 29. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 21. Mai 1991
    Geliefert am 29. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £106,643 pursuant to the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    All of the company's right title and interest in and to all sums payable under the insurance (as defined in the form 395).
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 29. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 07. Jan. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Sept. 1989
    Geliefert am 22. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 09. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Feb. 1987
    Geliefert am 23. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Warehouse/factory fronting to birmingham road, stratford-upon-avon, warwickshire known as "ex post office stores".
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 05. Juli 1985
    Geliefert am 11. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Former british telecom depot adjoining birmingham road stratford-upon-avon. (See doc M80 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited.
    Transaktionen
    • 11. Juli 1985Registrierung einer Belastung
    Further guarantee debenture
    Erstellt am 11. Jan. 1985
    Geliefert am 29. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 21. März 1983
    Geliefert am 25. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. März 1983Registrierung einer Belastung
    Further guarantee and debenture dated 23.2.82
    Erstellt am 23. Feb. 1982
    Geliefert am 03. März 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All that property, undertaking and assets chrged by the principal deed and further deeds.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. März 1982Registrierung einer Belastung
    Chattels mortgage
    Erstellt am 20. Sept. 1978
    Geliefert am 21. Sept. 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and singular the chattels, plant machinery and items following 3 american model 597C crawler mounted duty cycle magnet cranes serial nos cs 19083, cs 19085, cs 19087 1 american model 5720 pedestal mounted duty cycle magnet crane serial no. Cs 19081.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 21. Sept. 1978Registrierung einer Belastung
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 23. Jan. 1978
    Geliefert am 07. Feb. 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All that property undertaking & assets charged by the principal deed & further deed.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1978Registrierung einer Belastung
    A registered charge
    Erstellt am 08. Juni 1977
    Geliefert am 17. Juni 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of this other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assetscharge by the principal deed and further deed.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1977Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 22. Apr. 1976
    Geliefert am 29. Apr. 1976
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Warehouse premises, land and bungalow, banbury road, stratford-upon-avon, warwickshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1976Registrierung einer Belastung
    • 09. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 09. März 1976
    Geliefert am 17. März 1976
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to and/or all or any of the other companies named therein the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. März 1976Registrierung einer Belastung
    Assignment
    Erstellt am 04. Feb. 1976
    Geliefert am 24. Feb. 1976
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and singular the sum or sums of money now or to become due/owing payable to the company from birds processors LTD under the terms of an agreement dated 31/10/75 for the hiring of a harris 1335A shear serial no 401 (for details see doc M70).
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust LTD
    Transaktionen
    • 24. Feb. 1976Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Sept. 1975
    Geliefert am 30. Sept. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company all or any of the other companies named in doc 64 to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital by way of fixed & floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1975Registrierung einer Belastung
    • 09. Juni 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0