VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00549181 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Oldham Road Middleton M24 2DB Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BRITISH VITA INVESTMENTS LIMITED | 13. Mai 1955 | 13. Mai 1955 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian William Robb am 16. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 06. Nov. 2020
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mohammed Omar Shafi Khan als Direktor am 12. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian William Robb als Direktor am 07. Jan. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Mark Cheele als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Oldham Road Middleton Manchester M24 2DB verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED | Sekretär | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England |
| 110906090002 | ||||||||||
| O'RIORDAN, Daniel Joseph, Mr. | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | England | British | 176979900001 | |||||||||
| ROBB, Ian William | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | United Kingdom | British | 263073080001 | |||||||||
| ROUND, Darren Lee | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | England | British | 100922110001 | |||||||||
| SHAFI KHAN, Mohammed Omar | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | United Kingdom | British | 239506860001 | |||||||||
| HODGES, John | Sekretär | 1a Ashlea Grove Grotton OL4 4LE Oldham | British | 350570001 | ||||||||||
| STIRZAKER, Mark Robert | Sekretär | Lower Dunishbooth House Lane Head OL12 6BH Rochdale Lancashire | British | 78366970002 | ||||||||||
| TEAGUE, Alan Richard | Sekretär | 26 Orchard Street Stockton Heath WA4 6LH Warrington | British | 290650004 | ||||||||||
| BHATT, Kanakrai Ramanlal | Geschäftsführer | Whiteoaks Chester Road Mere WA16 6LG Knutsford Cheshire | British | 33879920001 | ||||||||||
| BURLEY, Nicholas James | Geschäftsführer | 45 Pall Mall SW1Y 5JG London Times Place | United Kingdom | British | 122799590001 | |||||||||
| CHEELE, Jonathan Mark | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | England | British | 127959950003 | |||||||||
| DOBSON, Roy | Geschäftsführer | 248 Compstall Road Romiley SK6 4JG Stockport Cheshire | British | 6930380002 | ||||||||||
| FRANCIS, Stephen Ronald William | Geschäftsführer | Belvedere Lodge 18 Highbury Road Wimbledon Village SW19 7PR London | England | British | 105961550001 | |||||||||
| HARRIS, Howard Elliott | Geschäftsführer | 15 Queen's Gate Gardens SW7 5LY London | British | 93378750001 | ||||||||||
| HAY, Nigel Bruce | Geschäftsführer | 6 Carr Holme Gardens Green Lane East Cabus PR6 7QH Garstang Lancashire | British | 79273660002 | ||||||||||
| MAIDEN, Jeremy Kim | Geschäftsführer | Beech Lawn Heath WF1 5SL Wakefield West Yorkshire | British | 71913700002 | ||||||||||
| MAUNDRELL, Graham Lloyd | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | United Kingdom | British | 56093930002 | |||||||||
| MCGEE, Robert | Geschäftsführer | Dale Brow Farm 61 Macclesfield Road Prestbury SK10 4BH Macclesfield Cheshire | British | 87945430001 | ||||||||||
| MELTHAM, John David | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | United Kingdom | British | 74570910001 | |||||||||
| MENENDEZ, Joseph Henry | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | Usa | American | 127225800003 | |||||||||
| O'CONNOR, Calvin James John | Geschäftsführer | 10 Moss Lane Timperley WA15 6SZ Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 16253240001 | |||||||||
| OLIVER, John Lancaster | Geschäftsführer | The Croft House 4 Hawkshill Close KT10 8JY Esher Surrey | United Kingdom | United Kingdom | 116941050001 | |||||||||
| SELLERS, Rodney Horrocks | Geschäftsführer | Stonecroft 3 Lostock Junction Lane Lostock BL6 4JR Bolton Lancashire | England | English | 53752390002 | |||||||||
| STIRZAKER, Mark Robert | Geschäftsführer | Lower Dunishbooth House Lane Head OL12 6BH Rochdale Lancashire | England | British | 78366970002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (Group) Unlimited | 06. Apr. 2016 | Oldham Road Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat VITA PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. Apr. 2009 Geliefert am 01. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from or by a principal to each of the secured parties, all monies due or to become due from the principals and/or british vita unlimited to the secured parties and all monies due or to become due to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Aug. 2005 Geliefert am 12. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor and each other company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all right title and interest in the tangible moveable property any account that is a mandatory prepayment account the intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital. Assigned the proceeds of any insurance policy and all related rights and the specific contracts. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 31. Dez. 1993 Geliefert am 19. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies now or hereafter standing to the credit of account no.301-018-5548-68-001 With the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0