WARRENDER AIRCRAFT SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WARRENDER AIRCRAFT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00551300 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WARRENDER AIRCRAFT SERVICES LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich WARRENDER AIRCRAFT SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Johnson House Abbots Park Monks Way Preston Brook WA7 3GH Runcorn Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WARRENDER AIRCRAFT SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EXPRESS CLEANERS (RUSHDEN) LIMITED | 29. Juni 1955 | 29. Juni 1955 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WARRENDER AIRCRAFT SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WARRENDER AIRCRAFT SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy James Morris am 17. Sept. 2012 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Yvonne May Monaghan am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy James Morris am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Yvonne May Monaghan am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WARRENDER AIRCRAFT SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONAGHAN, Yvonne May | Sekretär | Johnson House Abbots Park Monks Way Preston Brook WA7 3GH Runcorn Cheshire | British | 7934540003 | ||||||
| MONAGHAN, Yvonne May | Geschäftsführer | Johnson House Abbots Park Monks Way Preston Brook WA7 3GH Runcorn Cheshire | England | British | 7934540003 | |||||
| MORRIS, Timothy James | Geschäftsführer | Johnson House Abbots Park Monks Way Preston Brook WA7 3GH Runcorn Cheshire | England | British | 126969480002 | |||||
| CARELESS, Robert | Sekretär | 43 Newey Road Hall Green B28 0JQ Birmingham West Midlands | British | 652260001 | ||||||
| BARNEY, Stephen George | Geschäftsführer | The Dower House 77 Brook Street LE12 6TT Wymeswold Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 73277610001 | |||||
| BRADBURN, Lynda Maria | Geschäftsführer | 10 Haddon Grove Timperley WA15 6SA Altrincham Cheshire | British | 56685300001 | ||||||
| BROWN, Keith Peter | Geschäftsführer | 3 Hanover Drive Wigmore ME8 0RF Gillingham Kent | British | 17541780002 | ||||||
| CARELESS, Robert | Geschäftsführer | 43 Newey Road Hall Green B28 0JQ Birmingham West Midlands | British | 652260001 | ||||||
| CARELESS, Robert | Geschäftsführer | 43 Newey Road Hall Green B28 0JQ Birmingham West Midlands | British | 652260001 | ||||||
| CARROLL, Paul Bryan | Geschäftsführer | 8 Falkirk Avenue WA8 9DX Widnes Cheshire | England | British | 85123780001 | |||||
| HOLMES, Gary William | Geschäftsführer | 48 Badgers Way DT10 1EP Sturminster Newton Dorset | British | 93975060001 | ||||||
| HOLMES, Gary William | Geschäftsführer | 48 Badgers Way DT10 1EP Sturminster Newton Dorset | British | 93975060001 | ||||||
| JACKSON, John Ellis | Geschäftsführer | Ellerslie Coronation Road SL5 9LQ Ascot Berkshire | British | 2219540001 | ||||||
| LILLEY, Colin | Geschäftsführer | 17 Summers Close Main Street Kirkby Mallory LE9 7QP Leicestershire | British | 52131060001 | ||||||
| MCCRAE, Alastair Murdoch Mcintyre | Geschäftsführer | 25 Buckingham Road Sandiacre NG10 5PP Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 51771950001 | |||||
| MEYERS, Richard John | Geschäftsführer | 84 Hemingford Road Islington N1 1DD London | British | 71241210001 | ||||||
| ROBINSON, Peter Michael | Geschäftsführer | West End House 9 West End South Cave HU15 2EX Brough North Yorkshire | British | 32996430003 | ||||||
| SKIMER, Charles | Geschäftsführer | 13 Moorhouse Road W2 5DH London | British | 124303990001 | ||||||
| SUTTON, Michael Alan | Geschäftsführer | 25a Westbourne Road Birkdale PR8 2HZ Southport Merseyside | British | 7436190002 | ||||||
| WARRENDER, Terry Victor | Geschäftsführer | 91 Grove Lane Timperley WA15 6PN Altrincham Cheshire | British | 3782850001 | ||||||
| WILKINSON, James Henry | Geschäftsführer | 2 The Nursery Sutton Courtenay OX14 4UA Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | British | 56006210002 | |||||
| ZERNY, Richard Guy Frederick | Geschäftsführer | Stratton House Southside, Kilham YO25 4ST Driffield North Humberside | British | 10153950007 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WARRENDER AIRCRAFT SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semara Contract Services Limited | 06. Apr. 2016 | Abbots Park Monks Way WA7 3GH Preston Brook Johnson House Cheshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WARRENDER AIRCRAFT SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 18. Juli 1997 Geliefert am 31. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge by way of legal mortgage | Erstellt am 26. Juni 1997 Geliefert am 07. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee as regards each existing facility (as defined) all money and liabilities outstanding due owing or incurred by a company under such existing facility in excess of such existing facility's steadfast exposure (which as between the companies and the banks shall be conclusively presumed to be the amounts indicated in the steadfast agreement) up to but not exceeding the adjusted limits together with any accrued and unpaid interest (including default interest if applicable) in respect of such excess amounts, all sums due to the co-ordinating banks or the banks under this letter and all amounts due or payable under the terms of the new money security (as defined) | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 5 atlantic street altrincham trafford greater manchester t/no.GM560786. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge by way of legal mortgage | Erstellt am 26. Juni 1997 Geliefert am 07. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee as regards each existing facility (as defined) all money and liabilities outstanding due owing or incurred by a company under such existing facility in excess of such existing facility's steadfast exposure (which as between the companies and the banks shall be conclusively presumed to be the amounts indicated in the steadfast agreement) up to but not exceeding the adjusted limits together with any accrued and unpaid interest (including default interest if applicable) in respect of such excess amounts, all sums due to the co-ordinating banks or the banks under this letter and all amounts due or payable under the terms of the new money security (as defined) | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit 11 crown industrial estate canal road timperley trafford greater manchester. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0