ORB ESTATES PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameORB ESTATES PLC
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 00552331
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ORB ESTATES PLC?

    • (7011) /

    Wo befindet sich ORB ESTATES PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o THE MACDONALD PARTNERSHIP PLC
    29 Craven Street
    WC2N 5NT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ORB ESTATES PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OSSORY ESTATES PLC19. Jan. 198719. Jan. 1987
    STEWART NAIRN GROUP PLC30. Jan. 198430. Jan. 1984
    STEWART NAIRN GROUP P.L.C.(THE) 21. Juli 195521. Juli 1955

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ORB ESTATES PLC?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Juni 2003
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Jan. 2004
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ORB ESTATES PLC?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis21. Nov. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung05. Dez. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ORB ESTATES PLC?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für ORB ESTATES PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    28 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    29 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    29 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    30 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    32 SeitenWU07

    Fortführung des Gläubigerausschusses

    7 SeitenCOM3

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 14. Mai 2019

    2 Seiten2.15

    Ernennung eines Liquidators

    3 SeitenWU04

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Mitteilung über die Aufhebung des Verwaltungsbeschlusses

    3 Seiten2.19

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2019

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2018

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2018

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2017

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2017

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2016

    2 Seiten2.15

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O the Macdonald Partnership Plc 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH zum C/O the Macdonald Partnership Plc 29 Craven Street London WC2N 5NT am 11. Aug. 2016

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2016

    2 Seiten2.15

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Macdonald Partnership Plc 4th Floor 100 Fenchurch Street London EC3M 5JD zum C/O the Macdonald Partnership Plc 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH am 11. Nov. 2015

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2015

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2015

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2014

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2014

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2013

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2013

    2 Seiten2.15

    Wer sind die Geschäftsführer von ORB ESTATES PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WALGATE SERVICES LIMITED
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    Sekretär
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    59142480001
    BENNETT, Michael Peter
    4 Saltcoats Road
    Chiswick
    W4 1AR London
    Sekretär
    4 Saltcoats Road
    Chiswick
    W4 1AR London
    British25799790001
    GULMOHAMED, Farid Rashid
    35 Canons Drive
    HA8 7RB Edgware
    Middlesex
    Sekretär
    35 Canons Drive
    HA8 7RB Edgware
    Middlesex
    British13242170001
    KENNEDY, Alastair
    5 Butley Lanes
    Prestbury
    SK10 4HU Macclesfield
    Cheshire
    Sekretär
    5 Butley Lanes
    Prestbury
    SK10 4HU Macclesfield
    Cheshire
    English9842970004
    RIDAL, Philip Martin
    1 Ham Street
    TW10 7HR Richmond
    Surrey
    Sekretär
    1 Ham Street
    TW10 7HR Richmond
    Surrey
    BritishChartered Accountant79892010001
    BROWN, Cedric Harold
    60 Main Street
    LE12 8TH Swithland
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    60 Main Street
    LE12 8TH Swithland
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector1426900003
    CATTO, Peter Michael Ian
    14 Hyde Park Gardens
    W2 2LU London
    Geschäftsführer
    14 Hyde Park Gardens
    W2 2LU London
    BritishChartered Accountant51122800001
    CLAESSON, Per Johan
    Erikdahlbergsvag 3
    Kalmar 39235
    Sweden
    Geschäftsführer
    Erikdahlbergsvag 3
    Kalmar 39235
    Sweden
    SwedishManaging Director77942650001
    COLE, Denys Lucien Hubert
    Flat 2 White Lodge Wellington Court
    Wellington Road St Saviour
    JE2 7TE Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Flat 2 White Lodge Wellington Court
    Wellington Road St Saviour
    JE2 7TE Jersey
    Channel Islands
    BritishChartered Accountant2991190003
    COTTRELL, Dennis William
    Bechet 1 Hammond End
    Farnham Common
    SL2 3LG Slough
    Geschäftsführer
    Bechet 1 Hammond End
    Farnham Common
    SL2 3LG Slough
    BritishDirector61882620001
    DELACAVE, Jacques Theodore Louis
    Flat N 56 Warwick Square
    SW1V 2AJ London
    Geschäftsführer
    Flat N 56 Warwick Square
    SW1V 2AJ London
    BelgianEconomist35533340001
    EVEREST, Peter Lindsey
    Fir Trees 6 The Glen
    Crosslands
    LU1 4EU Caddington
    Beds
    Geschäftsführer
    Fir Trees 6 The Glen
    Crosslands
    LU1 4EU Caddington
    Beds
    BritishChartered Surveyor23018550001
    FOSLER, Frederick Alan
    Conkwell Grange
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    Geschäftsführer
    Conkwell Grange
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    BritishChartered Surveyor14331600001
    GULMOHAMED, Farid Rashid
    35 Canons Drive
    HA8 7RB Edgware
    Middlesex
    Geschäftsführer
    35 Canons Drive
    HA8 7RB Edgware
    Middlesex
    BritishChartered Accountant13242170001
    GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik Valentin
    Skeppargatan 6
    11452
    Stockholm
    Sweden
    Geschäftsführer
    Skeppargatan 6
    11452
    Stockholm
    Sweden
    SwedishCeo55080740001
    HAWKES, Michael John Cameron
    Park Farm Drive
    Punchbowl Lane
    RH5 4EB Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Park Farm Drive
    Punchbowl Lane
    RH5 4EB Dorking
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor33284180001
    HELVERT, Charles Osborne
    Beavers
    4 Sandown Avenue
    KT10 9NT Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Beavers
    4 Sandown Avenue
    KT10 9NT Esher
    Surrey
    BritishAccountant79161310001
    HIGGINS, Mitchell
    Bieldside Mill 23 North Deeside Road
    Bieldside
    AB15 9AD Aberdeen
    Geschäftsführer
    Bieldside Mill 23 North Deeside Road
    Bieldside
    AB15 9AD Aberdeen
    BritishChartered Surveyor34937290001
    HIGGINS, William
    Burchetts Green House
    SL6 6QZ Burchetts Green
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Burchetts Green House
    SL6 6QZ Burchetts Green
    Berkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor37571980001
    JOHNSON, Simon Harcourt
    Quenby Lodge
    Hungarton Road
    LE7 9JF Hungarton
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Quenby Lodge
    Hungarton Road
    LE7 9JF Hungarton
    Leicestershire
    BritishSurveyor92698710001
    JOHNSTONE, Steven Francis
    568 Green Lanes
    N13 5RZ London
    Geschäftsführer
    568 Green Lanes
    N13 5RZ London
    EnglandBritishChartered Accountant77477440001
    MADDOCK, Roger Charles
    Magdala Mount
    Lower Kings Cliff, St. Helier
    JE2 3ST Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Magdala Mount
    Lower Kings Cliff, St. Helier
    JE2 3ST Jersey
    Channel Islands
    BritishChartered Accountant74380410001
    MULDOON, John Gerard
    16 Carbery Avenue
    BH6 3LF Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    16 Carbery Avenue
    BH6 3LF Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritishSurveyor94510780001
    NOLAN, Samuel Johnston
    Lepine Rouge Rue De Lepine
    JE3 5AV Trinity
    Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Lepine Rouge Rue De Lepine
    JE3 5AV Trinity
    Jersey
    Channel Islands
    BritishChartered Accountant76262580001
    RIDAL, Philip Martin
    1 Ham Street
    TW10 7HR Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Ham Street
    TW10 7HR Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant79892010001
    SEBIRE, David John
    Willesley House
    Willesley
    GL8 8QU Tetbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Willesley House
    Willesley
    GL8 8QU Tetbury
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant1426430001
    TAYLOR, Roger James
    Apartment 67 Chaedoz
    Haute Nedaz
    Sion Ch-1997
    Switzerland
    Geschäftsführer
    Apartment 67 Chaedoz
    Haute Nedaz
    Sion Ch-1997
    Switzerland
    SwitzerlandBritishDirector127805790001
    TURNBULL, Nigel James Cavers
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant1604580001
    TURNER, Norman Patrick
    Hillside Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Hillside Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    BritishCompany Director9842980001
    WALKER, Michael John Milnes
    Red House 6 Church Street
    Cawthorne
    S75 4HP Barnsley
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Red House 6 Church Street
    Cawthorne
    S75 4HP Barnsley
    South Yorkshire
    BritishSolicitor21030300001

    Hat ORB ESTATES PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Memorandum of deposit and charge over securities (own liabilities)
    Erstellt am 11. Nov. 2002
    Geliefert am 20. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    3,750,000 ordinary 25P shares and 125,150,682 ordinary 10P shares including all dividends or interest paid or payable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alismoor Limited
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Memorandum of deposit and charge over securities (third party liabilities)
    Erstellt am 11. Nov. 2002
    Geliefert am 20. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from dr gail alison smith (the borrower) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    3,750,000 ordinary 25P shares, 125,152,682 ordinary 10P shares including al dividends or interest paid or payable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alismoor Limited
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Security interest agreement deposit with bank
    Erstellt am 02. Jan. 2002
    Geliefert am 03. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All monies from time to time standing to the credit of the account maintained by the company with the bank (account number 1028-50213094),. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over end user contracts
    Erstellt am 22. Aug. 2001
    Geliefert am 24. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orb developments limited to the chargee pursuant to an agreement dated 29 june 2001
    Kurze Angaben
    The benefit of its right,title and interest in and to the contracts, sums which shall from time to time become payable to the company under the contracts, the rights of the company arising out of or in connection with any breach or default of or under any of the terms,convenants or conditions of the contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Security interest agreement deposit with bank
    Erstellt am 14. Juni 2001
    Geliefert am 16. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies from time to time standing to the credit of the account maintained by the company with the bank (account numbered 50215127) including any redesignation of that account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 16. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Security interest agreement deposit with bank
    Erstellt am 14. Juni 2001
    Geliefert am 16. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies from time to time standing to the credit of the account maintained by the company with the bank (account number 1028-50213904) including any redesignation of that account any account which derives in whole or in part from such account any sub-account and any account substituted as the account by written agreement between the parties.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 16. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party general security assignment over agreement for lease
    Erstellt am 17. Jan. 2001
    Geliefert am 20. Jan. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All the benefit of the company's right title and interest in and to the contract being the agreement for sale dated 16TH january 2001 between the company, orb developments limited, andrew cohen and G.smith and all rtelated rights therto and thereof under the terms of the assignment and agreememnt for lease. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 17. Jan. 2001
    Geliefert am 20. Jan. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities of the company and orb developments limited to the chargee
    Kurze Angaben
    1). l/h land known or to be known as delphis house poole quay poole dorset any l/h or f/h land that the company may become entitled to within the boundaries of the f/h land with t/no:-DT276476 and l/h land with t/no;- DT274518. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Share charge
    Erstellt am 31. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from orb (lexham) limited (the borrower) to all or any of the secured parties (as defined) under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed charge all shares (as defined) held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights (as defined).
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    General security assignment
    Erstellt am 12. Nov. 1999
    Geliefert am 19. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orb aquisitions limited to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All the benefit of the right title and interest and to the contract specified in the schedule to the form 395 relating to contracts for agreement and sa le of 24 colherne road SW10 * see form 395 for further details *.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An investment portfolio third party security agreement
    Erstellt am 05. Nov. 1999
    Geliefert am 19. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All of the liabilities due from orb developments limited to the chargee under the terms of this security agreement
    Kurze Angaben
    All interest in the whole of the issued share capital of the debtor ("the charged assets") and all income derived from and rights attaching to the charged assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Commercial mortgage
    Erstellt am 02. Dez. 1997
    Geliefert am 03. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the property k/a land and buildings on the south side of rounds green road,oldbury,warley.t/no.WM468823;land and buildings on the west side of harborough hill road,barnsley.t/nos.SYK146374 & SYK182369 and all buildings,fixtures and fixed plant and machinery from time to time on such property together with all estates,rights,title,options,and privileges appurtenant to,or benefitting,the same including all beneficial interests of the company in the property.fixed charge the benefit of all guarantees,indemnities,rent deposits,agreements,contracts,undertakings & warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bristol & West PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 1991
    Geliefert am 13. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    70, west park ave, kew, richmond upon thames, title no. Sy 312998.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Juli 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 28. Sept. 1990
    Geliefert am 02. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 29-3-84
    Kurze Angaben
    Cash deposit in the sum of £1,750,000 & all interest accrued & to account threreon.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 11. Jan. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Dez. 1988
    Geliefert am 01. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    11 de waldon street, london borough of city of westminster title no ngl 623839.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Aug. 1988
    Geliefert am 07. Sept. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    11 de walden st, london borough of city of westminster.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 1988Registrierung einer Belastung
    Letter of charge
    Erstellt am 09. Aug. 1988
    Geliefert am 09. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All moneys now or at any time hereafter standingto the credit of any account (s) of the company with bank designated barclays bank PLC re ossory estates PLC security realisation account.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. März 1988
    Geliefert am 17. März 1988
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become deu from the company and/or nairn property development limited to teh chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Flat 3, 50 brooks mews l/borough of city of westmister t/no:- ngl 606440.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. März 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 08. März 1988
    Geliefert am 17. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company ad/or nairn property development limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Flat 4, 50 brooks mews 6/borough of city of westmisnter t/no:- ngl 606441.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Okt. 1987
    Geliefert am 30. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or nairn property development limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    45 & 47 broughton street cheetham & 21, cheetwood road cheetham, greater manchester t/no- la 29114.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    • 26. Feb. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Okt. 1987
    Geliefert am 30. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    11 de walden street, l/b of city of westminster t/no - ngl 305173.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    • 01. März 1989Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit of deeds w/I.
    Erstellt am 24. März 1987
    Geliefert am 08. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    (1) f/h property k/a 45/47 broughton street manchester and all cheetwood road cheetham t/n la 29114 (for further properties please see doc m 3/9APR/ln).
    Berechtigte Personen
    • Pk English Trust Limited
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    • 26. Feb. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 1987
    Geliefert am 26. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    40 st. Georges road golders green l/b of barnet t/n nx 313621.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 1987Registrierung einer Belastung
    • 26. Feb. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Property acquired
    Erstellt am 02. März 1987
    Geliefert am 14. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due secured in property acquiredby ossory estates PLC
    Kurze Angaben
    All and whole the street or dunagroom flat of the dwellehouse no 62 palmerton place in the city of edinburgh midlothian.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security property acquired 14TH oct 1988
    Erstellt am 02. März 1987
    Geliefert am 08. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due secured an property acquired by ossary estates PLC
    Kurze Angaben
    All and whole the street or dinagroom flat of the dwelin house no 62 plamerton place in the city of edinburgh midlothian.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 21. Aug. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ORB ESTATES PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. Juli 2003Beginn der Verwaltung
    14. Mai 2019Verwaltung entlassen
    Verwaltungsordnung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Douglas Macdonald
    The Macdonald Partnership
    81 St Martins Lane
    WC2N 4AA London
    Praktiker
    The Macdonald Partnership
    81 St Martins Lane
    WC2N 4AA London
    2
    DatumTyp
    13. März 2019Antragsdatum
    14. Mai 2019Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Douglas Macdonald
    29 Craven Street
    WC2N 5NT London
    Praktiker
    29 Craven Street
    WC2N 5NT London
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praktiker
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0