ORB ESTATES PLC
Überblick
Unternehmensname | ORB ESTATES PLC |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Unternehmensnummer | 00552331 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ORB ESTATES PLC?
- (7011) /
Wo befindet sich ORB ESTATES PLC?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o THE MACDONALD PARTNERSHIP PLC 29 Craven Street WC2N 5NT London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ORB ESTATES PLC?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
OSSORY ESTATES PLC | 19. Jan. 1987 | 19. Jan. 1987 |
STEWART NAIRN GROUP PLC | 30. Jan. 1984 | 30. Jan. 1984 |
STEWART NAIRN GROUP P.L.C.(THE) | 21. Juli 1955 | 21. Juli 1955 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ORB ESTATES PLC?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Juni 2003 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Jan. 2004 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ORB ESTATES PLC?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Nov. 2016 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 05. Dez. 2016 |
Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ORB ESTATES PLC?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ORB ESTATES PLC?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 28 Seiten | WU07 | ||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 29 Seiten | WU07 | ||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 29 Seiten | WU07 | ||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 30 Seiten | WU07 | ||
Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht | 32 Seiten | WU07 | ||
Fortführung des Gläubigerausschusses | 7 Seiten | COM3 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 14. Mai 2019 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Ernennung eines Liquidators | 3 Seiten | WU04 | ||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 2 Seiten | COCOMP | ||
Mitteilung über die Aufhebung des Verwaltungsbeschlusses | 3 Seiten | 2.19 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2019 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2018 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2018 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2017 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2017 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2016 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O the Macdonald Partnership Plc 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH zum C/O the Macdonald Partnership Plc 29 Craven Street London WC2N 5NT am 11. Aug. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2016 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Macdonald Partnership Plc 4th Floor 100 Fenchurch Street London EC3M 5JD zum C/O the Macdonald Partnership Plc 3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH am 11. Nov. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2015 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2015 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2014 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2014 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Juli 2013 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 10. Jan. 2013 | 2 Seiten | 2.15 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ORB ESTATES PLC?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALGATE SERVICES LIMITED | Sekretär | 25 North Row W1K 6DJ London | 59142480001 | |||||||
BENNETT, Michael Peter | Sekretär | 4 Saltcoats Road Chiswick W4 1AR London | British | 25799790001 | ||||||
GULMOHAMED, Farid Rashid | Sekretär | 35 Canons Drive HA8 7RB Edgware Middlesex | British | 13242170001 | ||||||
KENNEDY, Alastair | Sekretär | 5 Butley Lanes Prestbury SK10 4HU Macclesfield Cheshire | English | 9842970004 | ||||||
RIDAL, Philip Martin | Sekretär | 1 Ham Street TW10 7HR Richmond Surrey | British | Chartered Accountant | 79892010001 | |||||
BROWN, Cedric Harold | Geschäftsführer | 60 Main Street LE12 8TH Swithland Leicestershire | United Kingdom | British | Director | 1426900003 | ||||
CATTO, Peter Michael Ian | Geschäftsführer | 14 Hyde Park Gardens W2 2LU London | British | Chartered Accountant | 51122800001 | |||||
CLAESSON, Per Johan | Geschäftsführer | Erikdahlbergsvag 3 Kalmar 39235 Sweden | Swedish | Managing Director | 77942650001 | |||||
COLE, Denys Lucien Hubert | Geschäftsführer | Flat 2 White Lodge Wellington Court Wellington Road St Saviour JE2 7TE Jersey Channel Islands | British | Chartered Accountant | 2991190003 | |||||
COTTRELL, Dennis William | Geschäftsführer | Bechet 1 Hammond End Farnham Common SL2 3LG Slough | British | Director | 61882620001 | |||||
DELACAVE, Jacques Theodore Louis | Geschäftsführer | Flat N 56 Warwick Square SW1V 2AJ London | Belgian | Economist | 35533340001 | |||||
EVEREST, Peter Lindsey | Geschäftsführer | Fir Trees 6 The Glen Crosslands LU1 4EU Caddington Beds | British | Chartered Surveyor | 23018550001 | |||||
FOSLER, Frederick Alan | Geschäftsführer | Conkwell Grange Limpley Stoke BA3 6HD Bath | British | Chartered Surveyor | 14331600001 | |||||
GULMOHAMED, Farid Rashid | Geschäftsführer | 35 Canons Drive HA8 7RB Edgware Middlesex | British | Chartered Accountant | 13242170001 | |||||
GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik Valentin | Geschäftsführer | Skeppargatan 6 11452 Stockholm Sweden | Swedish | Ceo | 55080740001 | |||||
HAWKES, Michael John Cameron | Geschäftsführer | Park Farm Drive Punchbowl Lane RH5 4EB Dorking Surrey | England | British | Chartered Surveyor | 33284180001 | ||||
HELVERT, Charles Osborne | Geschäftsführer | Beavers 4 Sandown Avenue KT10 9NT Esher Surrey | British | Accountant | 79161310001 | |||||
HIGGINS, Mitchell | Geschäftsführer | Bieldside Mill 23 North Deeside Road Bieldside AB15 9AD Aberdeen | British | Chartered Surveyor | 34937290001 | |||||
HIGGINS, William | Geschäftsführer | Burchetts Green House SL6 6QZ Burchetts Green Berkshire | England | British | Chartered Surveyor | 37571980001 | ||||
JOHNSON, Simon Harcourt | Geschäftsführer | Quenby Lodge Hungarton Road LE7 9JF Hungarton Leicestershire | British | Surveyor | 92698710001 | |||||
JOHNSTONE, Steven Francis | Geschäftsführer | 568 Green Lanes N13 5RZ London | England | British | Chartered Accountant | 77477440001 | ||||
MADDOCK, Roger Charles | Geschäftsführer | Magdala Mount Lower Kings Cliff, St. Helier JE2 3ST Jersey Channel Islands | British | Chartered Accountant | 74380410001 | |||||
MULDOON, John Gerard | Geschäftsführer | 16 Carbery Avenue BH6 3LF Bournemouth Dorset | England | British | Surveyor | 94510780001 | ||||
NOLAN, Samuel Johnston | Geschäftsführer | Lepine Rouge Rue De Lepine JE3 5AV Trinity Jersey Channel Islands | British | Chartered Accountant | 76262580001 | |||||
RIDAL, Philip Martin | Geschäftsführer | 1 Ham Street TW10 7HR Richmond Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 79892010001 | ||||
SEBIRE, David John | Geschäftsführer | Willesley House Willesley GL8 8QU Tetbury Gloucestershire | British | Chartered Accountant | 1426430001 | |||||
TAYLOR, Roger James | Geschäftsführer | Apartment 67 Chaedoz Haute Nedaz Sion Ch-1997 Switzerland | Switzerland | British | Director | 127805790001 | ||||
TURNBULL, Nigel James Cavers | Geschäftsführer | 17 Salisbury Avenue AL5 2QF Harpenden Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 1604580001 | ||||
TURNER, Norman Patrick | Geschäftsführer | Hillside Macclesfield Road SK9 7BW Alderley Edge Cheshire | British | Company Director | 9842980001 | |||||
WALKER, Michael John Milnes | Geschäftsführer | Red House 6 Church Street Cawthorne S75 4HP Barnsley South Yorkshire | British | Solicitor | 21030300001 |
Hat ORB ESTATES PLC Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Memorandum of deposit and charge over securities (own liabilities) | Erstellt am 11. Nov. 2002 Geliefert am 20. Nov. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 3,750,000 ordinary 25P shares and 125,150,682 ordinary 10P shares including all dividends or interest paid or payable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of deposit and charge over securities (third party liabilities) | Erstellt am 11. Nov. 2002 Geliefert am 20. Nov. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from dr gail alison smith (the borrower) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 3,750,000 ordinary 25P shares, 125,152,682 ordinary 10P shares including al dividends or interest paid or payable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security interest agreement deposit with bank | Erstellt am 02. Jan. 2002 Geliefert am 03. Jan. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All monies from time to time standing to the credit of the account maintained by the company with the bank (account number 1028-50213094),. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over end user contracts | Erstellt am 22. Aug. 2001 Geliefert am 24. Aug. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from orb developments limited to the chargee pursuant to an agreement dated 29 june 2001 | |
Kurze Angaben The benefit of its right,title and interest in and to the contracts, sums which shall from time to time become payable to the company under the contracts, the rights of the company arising out of or in connection with any breach or default of or under any of the terms,convenants or conditions of the contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security interest agreement deposit with bank | Erstellt am 14. Juni 2001 Geliefert am 16. Juni 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies from time to time standing to the credit of the account maintained by the company with the bank (account numbered 50215127) including any redesignation of that account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security interest agreement deposit with bank | Erstellt am 14. Juni 2001 Geliefert am 16. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies from time to time standing to the credit of the account maintained by the company with the bank (account number 1028-50213904) including any redesignation of that account any account which derives in whole or in part from such account any sub-account and any account substituted as the account by written agreement between the parties. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Third party general security assignment over agreement for lease | Erstellt am 17. Jan. 2001 Geliefert am 20. Jan. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All the benefit of the company's right title and interest in and to the contract being the agreement for sale dated 16TH january 2001 between the company, orb developments limited, andrew cohen and G.smith and all rtelated rights therto and thereof under the terms of the assignment and agreememnt for lease. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Third party legal charge | Erstellt am 17. Jan. 2001 Geliefert am 20. Jan. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies and liabilities of the company and orb developments limited to the chargee | |
Kurze Angaben 1). l/h land known or to be known as delphis house poole quay poole dorset any l/h or f/h land that the company may become entitled to within the boundaries of the f/h land with t/no:-DT276476 and l/h land with t/no;- DT274518. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Share charge | Erstellt am 31. März 2000 Geliefert am 04. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from orb (lexham) limited (the borrower) to all or any of the secured parties (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed charge all shares (as defined) held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights (as defined). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
General security assignment | Erstellt am 12. Nov. 1999 Geliefert am 19. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from orb aquisitions limited to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All the benefit of the right title and interest and to the contract specified in the schedule to the form 395 relating to contracts for agreement and sa le of 24 colherne road SW10 * see form 395 for further details *. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An investment portfolio third party security agreement | Erstellt am 05. Nov. 1999 Geliefert am 19. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All of the liabilities due from orb developments limited to the chargee under the terms of this security agreement | |
Kurze Angaben All interest in the whole of the issued share capital of the debtor ("the charged assets") and all income derived from and rights attaching to the charged assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Commercial mortgage | Erstellt am 02. Dez. 1997 Geliefert am 03. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the property k/a land and buildings on the south side of rounds green road,oldbury,warley.t/no.WM468823;land and buildings on the west side of harborough hill road,barnsley.t/nos.SYK146374 & SYK182369 and all buildings,fixtures and fixed plant and machinery from time to time on such property together with all estates,rights,title,options,and privileges appurtenant to,or benefitting,the same including all beneficial interests of the company in the property.fixed charge the benefit of all guarantees,indemnities,rent deposits,agreements,contracts,undertakings & warranties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Jan. 1991 Geliefert am 13. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 70, west park ave, kew, richmond upon thames, title no. Sy 312998. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 28. Sept. 1990 Geliefert am 02. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 29-3-84 | |
Kurze Angaben Cash deposit in the sum of £1,750,000 & all interest accrued & to account threreon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 24. Dez. 1988 Geliefert am 01. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 11 de waldon street, london borough of city of westminster title no ngl 623839. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Aug. 1988 Geliefert am 07. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 11 de walden st, london borough of city of westminster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of charge | Erstellt am 09. Aug. 1988 Geliefert am 09. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys now or at any time hereafter standingto the credit of any account (s) of the company with bank designated barclays bank PLC re ossory estates PLC security realisation account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 08. März 1988 Geliefert am 17. März 1988 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become deu from the company and/or nairn property development limited to teh chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Flat 3, 50 brooks mews l/borough of city of westmister t/no:- ngl 606440. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 08. März 1988 Geliefert am 17. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company ad/or nairn property development limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Flat 4, 50 brooks mews 6/borough of city of westmisnter t/no:- ngl 606441. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Okt. 1987 Geliefert am 30. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or nairn property development limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben 45 & 47 broughton street cheetham & 21, cheetwood road cheetham, greater manchester t/no- la 29114. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Okt. 1987 Geliefert am 30. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 11 de walden street, l/b of city of westminster t/no - ngl 305173. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit of deeds w/I. | Erstellt am 24. März 1987 Geliefert am 08. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben (1) f/h property k/a 45/47 broughton street manchester and all cheetwood road cheetham t/n la 29114 (for further properties please see doc m 3/9APR/ln). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. März 1987 Geliefert am 26. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 40 st. Georges road golders green l/b of barnet t/n nx 313621. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Property acquired | Erstellt am 02. März 1987 Geliefert am 14. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due secured in property acquiredby ossory estates PLC | |
Kurze Angaben All and whole the street or dunagroom flat of the dwellehouse no 62 palmerton place in the city of edinburgh midlothian. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security property acquired 14TH oct 1988 | Erstellt am 02. März 1987 Geliefert am 08. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due secured an property acquired by ossary estates PLC | |
Kurze Angaben All and whole the street or dinagroom flat of the dwelin house no 62 plamerton place in the city of edinburgh midlothian. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ORB ESTATES PLC Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Verwaltungsordnung |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0