D-UK INTERNATIONAL LTD
Überblick
Unternehmensname | D-UK INTERNATIONAL LTD |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00552438 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von D-UK INTERNATIONAL LTD?
- Großhandel mit Bekleidung und Schuhen (46420) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich D-UK INTERNATIONAL LTD?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill Dickinson Llp No 1 St Pauls Square L3 9SJ Liverpool |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von D-UK INTERNATIONAL LTD?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HANESBRANDS UK LTD | 11. März 2016 | 11. März 2016 |
DBAPPAREL UK LTD | 20. März 2006 | 20. März 2006 |
SARA LEE INTIMATES UK LIMITED | 08. Jan. 2003 | 08. Jan. 2003 |
PLAYTEX LIMITED | 23. Juli 1955 | 23. Juli 1955 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von D-UK INTERNATIONAL LTD?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2022 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2023 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 01. Jan. 2022 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für D-UK INTERNATIONAL LTD?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 16. Juni 2024 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 30. Juni 2024 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 16. Juni 2023 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für D-UK INTERNATIONAL LTD?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Juli 2024 | 11 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kenia Denoyes als Sekretär am 25. Aug. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O a&L Goodbody, Augustine House Austin Friars London EC2N 2HA England zum Hill Dickinson Llp No 1 st Pauls Square Liverpool L3 9SJ am 01. Aug. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stylianos Efstathiou als Direktor am 31. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Maria Savvidou als Geschäftsführer am 31. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Part First Floor (East) Unity Building a, Riverside Way Camberley GU15 3YL England zum C/O a&L Goodbody, Augustine House Austin Friars London EC2N 2HA am 25. Nov. 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Jan. 2022 | 29 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Juni 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Michael Alan Reinstein as a person with significant control on 12. Apr. 2022 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Cessation of Hanesbrands Inc. as a person with significant control on 12. Apr. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andreas Gabel als Geschäftsführer am 31. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Maria Savvidou als Direktor am 31. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed hanesbrands uk LTD\certificate issued on 31/03/22 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Heather Laura Nogueira als Geschäftsführer am 10. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Kenia Denoyes als Sekretär am 07. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Carroll Southern als Sekretär am 07. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Markland Scott Lewis als Geschäftsführer am 07. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O a&L Goodbody, Augustine House, 6a Austin Friars London EC2N 2HA United Kingdom zum Part First Floor (East) Unity Building a, Riverside Way Camberley GU15 3YL am 17. Sept. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Jan. 2021 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 6 Church Street West Woking Surrey GU21 6DJ zum C/O a&L Goodbody, Augustine House, 6a Austin Friars London EC2N 2HA am 05. Feb. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von D-UK INTERNATIONAL LTD?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSTATHIOU, Stylianos | Geschäftsführer | St Pauls Square L3 9SJ Liverpool Hill Dickinson Llp No 1 | Cyprus | Cypriot | Company Director | 307610860001 | ||||
BLINCOW, Robert Stanley | Sekretär | South Glen 89 South Street PA16 8QN Greenock Renfrewshire | British | 14053860001 | ||||||
BLINCOW, Robert Stanley | Sekretär | South Glen 89 South Street PA16 8QN Greenock Renfrewshire | British | 14053860001 | ||||||
BRATT, Douglas | Sekretär | 57 Brisbane Street KA30 8QP Largs Ayrshire | British | 110847170001 | ||||||
DENOYES, Kenia | Sekretär | St Pauls Square L3 9SJ Liverpool Hill Dickinson Llp No 1 | 288520410001 | |||||||
DONNELLY, David John, Mr. | Sekretär | 2 Deramore Avenue Giffnock G46 6SL Glasgow | British | 110847310002 | ||||||
JOHNSON, Joia M | Sekretär | Church Street West GU21 6DJ Woking 6 Surrey | 208074940001 | |||||||
LAVELLE, Audrey | Sekretär | c/o Dbapparel Uk Ltd Industrial Estate PA14 5UY Port Glasgow Playtex Park Renfrewshire Great Britain | 172896300001 | |||||||
SOUTHERN, Elizabeth Carroll | Sekretär | Building A, Riverside Way GU15 3YL Camberley Part First Floor (East) Unity England | 267756090001 | |||||||
ADKINS, Kirk Slee | Geschäftsführer | St Catherines Lodge St Marys Road SL5 9AY Ascot Berkshire | United States Citizen | Ceo Playtex Wonderbra Shock Ab | 142912240001 | |||||
BROWN, Katharine Jane | Geschäftsführer | 41 Anxey Way Haddenham HP17 8DJ Aylesbury Buckinghamshire | British | Solicitor | 64457200001 | |||||
CHANDLER, Mark Randall | Geschäftsführer | Chemin Des Tournelles 78810 Davron France | American | Company Director | 37860510002 | |||||
DEVIN, Paul Gregory | Geschäftsführer | Britannia Wharf Monument Road GU21 5LW Woking Surrey | United Kingdom | British | General Manager | 207660280001 | ||||
DIXEY, John William | Geschäftsführer | Rustlings Forest Road KT24 5BX East Horsley Surrey | Gb-Eng | British | Company Director | 101455840001 | ||||
DUFFY, Hugh Brian | Geschäftsführer | 1522 Mill Plain Road Fairfield FOREIGN Connecticut 06430 Usa | British | Director | 14053880001 | |||||
FRANCESCHINI, Donald Joseph | Geschäftsführer | 2980 Congress Street Fairfield 06430 Connecticut Usa | Usa | Director | 22878760001 | |||||
GABEL, Andreas | Geschäftsführer | Building A, Riverside Way GU15 3YL Camberley Part First Floor (East) Unity England | Germany | German | Director | 267756000001 | ||||
GLENTON, Arnaud John Dominic | Geschäftsführer | Britannia Wharf Monument Road GU21 5LW Woking Surrey | United Kingdom | British | General Manager | 181930020001 | ||||
GRANT-WOOD, Calum | Geschäftsführer | Church Street West GU21 6DJ Woking 6 Surrey | United Kingdom | British | General Manager | 191893690001 | ||||
HANDLEY, Helen Kay | Geschäftsführer | 6 Daniels Lane CR6 9ET Warlingham Surrey | British | Solicitor | 109816110001 | |||||
HOYLE, Eric Nelson | Geschäftsführer | 496 Stonegate Lane Winston-Salem North Carolina 27104 Usa | Usa | Chief Financial Officer | 33161350001 | |||||
HUYCK, Arn Van | Geschäftsführer | Church Street West GU21 6DJ Woking 6 Surrey | Belgium | Belgian | None | 235988620001 | ||||
IANDOLO, Antonio | Geschäftsführer | Church Street West GU21 6DJ Woking 6 Surrey England | France | Italian | None | 235988350001 | ||||
JAGUN, Ayotola | Geschäftsführer | 4e Bassett Road W10 6JJ London | British | Chartered Secretary | 77729230001 | |||||
KENNEDY, Denise Yvonne | Geschäftsführer | 3 Hamilton Lodge Kings Road SL4 2AS Windsor Berkshire | British | Solicitor | 43844440001 | |||||
LEKIEFFRE, Antoine | Geschäftsführer | Britannia Wharf Monument Road GU21 5LW Woking Surrey | France | French | Director | 182038350001 | ||||
LEWIS, Markland Scott | Geschäftsführer | Building A, Riverside Way GU15 3YL Camberley Part First Floor (East) Unity England | North Carolina | American | None | 198681230001 | ||||
LIVINGSTON, Osmund Piers | Geschäftsführer | 2 Shaftsbury Way Strawberry Hill TW2 5RP Twickenham Middlesex | British | Company Director | 809050001 | |||||
NOGUEIRA, Heather Laura | Geschäftsführer | Building A, Riverside Way GU15 3YL Camberley Part First Floor (East) Unity England | England | South African | Director | 267756070001 | ||||
RISTON, Francois | Geschäftsführer | Church Street West GU21 6DJ Woking 6 Surrey | France | French | Director | 182038140001 | ||||
RIX, Deborah | Geschäftsführer | 9 Colville Gardens GU18 5QQ Lightwater Folly Brook House Surrey | England | British | General Manager | 138473100001 | ||||
RUBENSTEIN, Howard Justin | Geschäftsführer | 10 Cyprus Avenue Finchley N3 1ST London | United Kingdom | British | Solicitor | 66642870003 | ||||
SAVVIDOU, Maria | Geschäftsführer | Austin Friars EC2N 2HA London C/O A&L Goodbody, Augustine House England | Cyprus | Cypriot | Lawyer | 294400380001 | ||||
SOTOS, Hercules Peter | Geschäftsführer | 12 Dogwood Lane FOREIGN Greenwich Ct 06830 Usa | American | Vice Chairman | 14053870001 | |||||
VARANI, Alberto | Geschäftsführer | Largo Dell Olgiata 15 Isola 95 00123 Villino A3 Int 1 Rome Italy | Italian | Company Director | 37860590001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei D-UK INTERNATIONAL LTD?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Alan Reinstein | 12. Apr. 2022 | St Pauls Square L3 9SJ Liverpool Hill Dickinson Llp No 1 | Nein | ||||||||||
Nationalität: American Staatsangehörigkeit: United States | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hanesbrands Inc. | 06. Apr. 2016 | East Hanes Mill Road Winston-Salem 1000 Nc 27105 United States | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für D-UK INTERNATIONAL LTD?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
16. Juni 2017 | 16. Juni 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat D-UK INTERNATIONAL LTD Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Trust deed | Erstellt am 24. Sept. 2010 Geliefert am 09. Okt. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £19,720.26 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of a fixed legal charge all of the tenant's interest in the deposit account and all money from time to time standing to the credit of or acrruing to the deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite all assets guarantee and indemnity and debenture | Erstellt am 30. Juni 2010 Geliefert am 01. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 27. Nov. 2008 Geliefert am 01. Dez. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re db apparel UK limited and numbered 300002 00775896 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company. The accounts with the bank denominated in us dollars designated lloyds tsb bank PLC re db apparel UK limited and now numbered 301218 11606875 and any account(s). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite all assets guarantee and indemnity and debenture | Erstellt am 26. Okt. 2006 Geliefert am 07. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its securities all loan capiatl indebtedness or liabilities on any account all amounts all its documents of title and all debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security. | Erstellt am 24. Jan. 1990 Geliefert am 31. Jan. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben 5.86 acres of ground lying to the north east of dubbs road port glasgow renfrew forming part of the industrial estate (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed & floating | Erstellt am 14. Dez. 1989 Geliefert am 23. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 27. Jan. 1989 Geliefert am 14. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Plot of ground extending to 0.4558 acres adjacent to dubbs road industrial estate, port glasgow (for full details see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security. | Erstellt am 10. Jan. 1989 Geliefert am 18. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Area of ground lying to the north east of the public road k/a dubbs road parish of port glasgow and county of renfrew and forming part of the industiral estate at dubbs road, port glasgow. (For full details see 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 22. Dez. 1988 Geliefert am 30. Dez. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat D-UK INTERNATIONAL LTD Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0